Buscador CIF Logo

Actos BORME Embutidos Del Centro Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Embutidos Del Centro Sa

Actos BORME Embutidos Del Centro Sa - A78171360

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Toledo para Embutidos Del Centro Sa con CIF A78171360

馃敊 Perfil de Embutidos Del Centro Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Toledo

Actos BORME de Embutidos Del Centro Sa

08 de Febrero de 2023
Reelecciones. Consejero: MERCEDES CACERES GONZALEZ;VERONICA GARCIA CACERES;SANDRA GARCIA CACERES.Presidente: VERONICA GARCIA CACERES. Cons.Del.Sol: VERONICA GARCIA CACERES;SANDRA GARCIACACERES;MERCEDES CACERES GONZALEZ. Secretario: SANDRA GARCIA CACERES. Datos registrales. T 1733 , F 149, S 8, HTO 28413, I/A 24 ( 1.02.23).

27 de Diciembre de 2021
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.501.045,38 Euros. Resultante Suscrito: 3.501.045,38 Euros. Datos registrales. T 1733 ,F 149, S 8, H TO 28413, I/A 23 (20.12.21).

Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: INVERSIONES SACEM17 SL. Datos registrales. T 1655 , F 199, S 8, H TO 28413,I/A 22 (20.12.21).

29 de Junio de 2021
Nombramientos. Auditor: BENAVIDES ALMELA LOURDES. Aud.Supl.: MORADILLO RIOSALIDO AMPARO. Datos registrales. T1655 , F 199, S 8, H TO 28413, I/A 21 (21.06.21).

21 de Enero de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: MANCEBO FRAILE FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: MANCEBO FRAILE FRANCISCO JAVIER.Apo.Manc.: ARBOLEYA GONZALEZ JOSE RAMON. Apo.Sol.: ARBOLEYA GONZALEZ JOSE RAMON. Apo.Manc.: MORILLASROLDAN ELIAS. Apo.Sol.: MORILLAS ROLDAN ELIAS. Datos registrales. T 1655 , F 198, S 8, H TO 28413, I/A 20 (14.01.21).

05 de Marzo de 2019
Nombramientos. Auditor: BENAVIDES ALMELA LOURDES. Aud.Supl.: ESTEO SANCHEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 1655, F 198, S 8, H TO 28413, I/A 19 (26.02.19).

21 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA ROBLEDO TOMAS. Presidente: GARCIA ROBLEDO TOMAS. Cons.Del.Sol: GARCIAROBLEDO TOMAS. Nombramientos. Presidente: GARCIA CACERES VERONICA. Datos registrales. T 1655 , F 198, S 8, H TO28413, I/A 18 (11.02.19).

19 de Diciembre de 2018
Revocaciones. Auditor: CASADO TRUE & FAIR SL. Datos registrales. T 1655 , F 198, S 8, H TO 28413, I/A 17 (12.12.18).

28 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: BLAZQUEZ SIERRA JOSE LUIS;GARCIA ROBLEDO TOMAS;SIERRA SIERRA ELVIRA;BLAZQUEZSIERRA JUAN CARLOS;GARCIA CACERES VERONICA;GARCIA CACERES SANDRA;CACERES GONZALEZ MERCEDES.Secretario: BLAZQUEZ SIERRA JOSE LUIS. Cons.Del.Man: BLAZQUEZ SIERRA JOSE LUIS. Presidente: GARCIA ROBLEDOTOMAS. Cons.Del.Man: GARCIA ROBLEDO TOMAS;BLAZQUEZ SIERRA JUAN CARLOS;GARCIA CACERES VERONICA;GARCIACACERES SANDRA. Vicesecret.: CACERES GONZALEZ MERCEDES. Nombramientos. Consejero: GARCIA ROBLEDOTOMAS;CACERES GONZALEZ MERCEDES;GARCIA CACERES VERONICA;GARCIA CACERES SANDRA. Presidente: GARCIA

Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 999.994,24 Euros. Desembolsado: 999.994,24 Euros. Resultante Suscrito: 7.002.090,76 Euros.Resultante Desembolsado: 7.002.090,76 Euros. Datos registrales. T 1515 , F 149, S 8, H TO 28413, I/A 16 (15.02.18).

31 de Julio de 2017
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.001.048,00 Euros. Desembolsado: 2.001.048,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.002.096,52 Euros.Resultante Desembolsado: 6.002.096,52 Euros. Datos registrales. T 1515 , F 149, S 8, H TO 28413, I/A 14 (24.07.17).

14 de Julio de 2017
Nombramientos. Auditor: CASADO TRUE & FAIR SL. Datos registrales. T 1510 , F 206, S 8, H TO 28413, I/A 13 ( 6.07.17).

16 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA ROBLEDO TOMAS;BLAZQUEZ SIERRA JOSE LUIS;SIERRA SIERRA ELVIRA;CACERESGONZALEZ MERCEDES;GARCIA CACERES VERONICA;GARCIA CACERES SANDRA;BLAZQUEZ SIERRA JUAN CARLOS.Presidente: GARCIA ROBLEDO TOMAS. Cons.Del.Man: GARCIA ROBLEDO TOMAS. Secretario: BLAZQUEZ SIERRA JOSE LUIS.Cons.Del.Man: BLAZQUEZ SIERRA JOSE LUIS. Vicesecret.: CACERES GONZALEZ MERCEDES. Cons.Del.Man: GARCIACACERES VERONICA;GARCIA CACERES SANDRA;BLAZQUEZ SIERRA JUAN CARLOS. Nombramientos. Consejero: GARCIAROBLEDO TOMAS;BLAZQUEZ SIERRA JOSE LUIS;SIERRA SIERRA ELVIRA;CACERES GONZALEZ MERCEDES;GARCIACACERES VERONICA;GARCIA CACERES SANDRA;BLAZQUEZ SIERRA JUAN CARLOS. Presidente: GARCIA ROBLEDO TOMAS.Secretario: BLAZQUEZ SIERRA JOSE LUIS. Vicesecret.: CACERES GONZALEZ MERCEDES. Cons.Del.Man: GARCIA ROBLEDOTOMAS;BLAZQUEZ SIERRA JOSE LUIS;GARCIA CACERES VERONICA;GARCIA CACERES SANDRA;BLAZQUEZ SIERRA JUANCARLOS. Datos registrales. T 1510 , F 206, S 8, H TO 28413, I/A 12 ( 8.08.16).

04 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Auditor: CASADO TRUE & FAIR SL. Datos registrales. T 1510 , F 205, S 8, H TO 28413, I/A 10 (27.11.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BLAZQUEZ GARCIA LUIS;GARCIA ROBLEDO TOMAS;SIERRA SIERRA ELVIRA;CACERESGONZALEZ MERCEDES;GARCIA CACERES VERONICA;GARCIA CACERES SANDRA;BLAZQUEZ SIERRA JUANCARLOS;BLAZQUEZ SIERRA JOSE LUIS. Presidente: BLAZQUEZ GARCIA LUIS. Cons.Del.Man: BLAZQUEZ GARCIA LUIS.Secretario: GARCIA ROBLEDO TOMAS. Cons.Del.Man: GARCIA ROBLEDO TOMAS. Vicesecret.: CACERES GONZALEZMERCEDES. Cons.Del.Man: GARCIA CACERES VERONICA;GARCIA CACERES SANDRA;BLAZQUEZ SIERRA JUANCARLOS;BLAZQUEZ SIERRA JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: GARCIA ROBLEDO TOMAS;BLAZQUEZ SIERRA JOSELUIS;SIERRA SIERRA ELVIRA;CACERES GONZALEZ MERCEDES;GARCIA CACERES VERONICA;GARCIA CACERESSANDRA;BLAZQUEZ SIERRA JUAN CARLOS. Presidente: GARCIA ROBLEDO TOMAS. Secretario: BLAZQUEZ SIERRA JOSELUIS. Vicesecret.: CACERES GONZALEZ MERCEDES. Cons.Del.Man: GARCIA ROBLEDO TOMAS;BLAZQUEZ SIERRA JOSELUIS;GARCIA CACERES VERONICA;GARCIA CACERES SANDRA;BLAZQUEZ SIERRA JUAN CARLOS. Otros conceptos:ESTABLECIDA LA RETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 1510 , F 205, S 8, H TO 28413, I/A11 (27.11.14).

10 de Diciembre de 2012
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.001.048,00 Euros. Desembolsado: 2.001.048,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.001.048,52 Euros.Resultante Desembolsado: 4.001.048,52 Euros. Datos registrales. T 1510 , F 205, S 8, H TO 28413, I/A 9 (29.11.12).

15 de Febrero de 2011
Reelecciones. Auditor: CASADO TRUE & FAIR SL. Datos registrales. T 1510 , F 205, S 8, H TO 28413, I/A 7 ( 3.02.11).

Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 968.774,52 Euros. Desembolsado: 968.774,52 Euros. Resultante Suscrito: 2.000.000,52 Euros.Resultante Desembolsado: 2.000.000,52 Euros. Datos registrales. T 1510 , F 205, S 8, H TO 28413, I/A 8 ( 3.02.11).

14 de Enero de 2011
Fe de erratas: REELEGIDO POR ERROR DON JOSE BLAZQUEZ GARCIA CUANDO EN REALIDAD ES DON LUIS BLAZQUEZGARCIA. Datos registrales. T 1421 , F 210, S 8, H TO 28413, I/A 6 (30.12.10).

11 de Enero de 2011
Nombramientos. Consejero: GARCIA CACERES VERONICA;BLAZQUEZ SIERRA JOSE LUIS;BLAZQUEZ SIERRA JUANCARLOS;GARCIA CACERES SANDRA. Vicesecret.: CACERES GONZALEZ MERCEDES. Cons.Del.Man: GARCIA CACERESVERONICA;GARCIA CACERES SANDRA;BLAZQUEZ SIERRA JUAN CARLOS;BLAZQUEZ SIERRA JOSE LUIS. Reelecciones.Consejero: BLAZQUEZ GARCIA JOSE;GARCIA ROBLEDO TOMAS;SIERRA SIERRA ELVIRA;CACERES GONZALEZ MERCEDES.Presidente: BLAZQUEZ GARCIA JOSE. Secretario: GARCIA ROBLEDO TOMAS. Cons.Del.Man: BLAZQUEZ GARCIA JOSE;GARCIAROBLEDO TOMAS. Datos registrales. T 1421 , F 210, S 8, H TO 28413, I/A 6 (30.12.10).

16 de Abril de 2009
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 68.026,00 Euros. Desembolsado: 68.026,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.031.226,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.031.226,00 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: EXPLOTACIONES DEMANUFACTURAS CARNICAS DE CENTRO S. Datos registrales. T 1421 , F 209, S 8, H TO 28413, I/A 5 (30.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n