Buscador CIF Logo

Actos BORME Embutidos Fermin Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Embutidos Fermin Sl

Actos BORME Embutidos Fermin Sl - B37212388

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Salamanca para Embutidos Fermin Sl con CIF B37212388

馃敊 Perfil de Embutidos Fermin Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Salamanca

Actos BORME de Embutidos Fermin Sl

28 de Enero de 2021
Nombramientos. Auditor: KRESTON IBERAUDIT IBAC SLP. Datos registrales. T 387 , F 216, S 8, H SA 1190, I/A 30 (21.01.21).

20 de Noviembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: ANDRES TEJEDOR MANUEL. Datos registrales. T 387 , F 176, S 8, H SA 1190, I/A 29 (12.11.20).

18 de Septiembre de 2020
Otros conceptos: MODIFICACION TOTAL DE ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 387 , F 174, S 8, H SA 1190, I/A 27 (2.09.20).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN GOMEZ SANTIAGO. Presidente: MARTIN GOMEZ SANTIAGO. Consejero: MARTINGOMEZ FRANCISCA;BENITO HERNANDEZ EUSEBIA;TEJEDOR GUERRERO MANUEL ANDRES. Nombramientos.SecreNoConsj: MARTIN HERRERO MIGUEL ANGEL. Consejero: MARTIN GOMEZ SANTIAGO. Presidente: MARTIN GOMEZSANTIAGO. Con.Delegado: MARTIN GOMEZ SANTIAGO. Consejero: MARTIN GOMEZ FRANCISCA;BENITO HERNANDEZEUSEBIA;TEJEDOR GUERRERO MANUEL ANDRES. Datos registrales. T 387 , F 175, S 8, H SA 1190, I/A 28 ( 2.09.20).

27 de Julio de 2018
Reelecciones. Auditor: NEXT AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 387 , F 174, S 8, H SA 1190, I/A 26(17.07.18).

11 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: UCAR INNERARITY MARIANO. Nombramientos. SecreNoConsj: RODRIGUEZ JIMENEZJOSE-LUIS. Datos registrales. T 387 , F 173, S 8, H SA 1190, I/A 24 (28.11.17).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE-LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj: MARTIN HERREROMIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 387 , F 173, S 8, H SA 1190, I/A 25 (28.11.17).

29 de Diciembre de 2015
Reelecciones. Auditor: NEXT AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 387 , F 173, S 8, H SA 1190, I/A 23(14.12.15).

21 de Noviembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN GOMEZ SANTIAGO. Presidente: MARTIN GOMEZ SANTIAGO. Consejero: MARTINGOMEZ FRANCISCA;BENITO HERNANDEZ EUSEBIA;TEJEDOR GUERRERO MANUEL ANDRES;GRAND DISTRIBUCION YSERVICIOS 99 SL;VI脩A VICTORIA SL. SecreNoConsj: LARIO RIVAS ADELA. Nombramientos. Consejero: MARTIN GOMEZSANTIAGO. Presidente: MARTIN GOMEZ SANTIAGO. Consejero: MARTIN GOMEZ FRANCISCA;BENITO HERNANDEZEUSEBIA;TEJEDOR GUERRERO MANUEL ANDRES. SecreNoConsj: UCAR INNERARITY MARIANO. Otros conceptos:Modificaci贸n de los art铆culos 21, 26, 27 y 28 y eliminaci贸n del contenido del art铆culo 29 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T387 , F 172, S 8, H SA 1190, I/A 22 (13.11.14).

31 de Enero de 2014
Ceses/Dimisiones. Con.Ind.: ININ GESTION SL. Datos registrales. T 387 , F 171, S 8, H SA 1190, I/A 21 (14.01.14).

30 de Enero de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.150.057,80 Euros. Resultante Suscrito: 127.548,00 Euros. Datos registrales. T 387 , F171, S 8, H SA 1190, I/A 20 (15.01.13).

27 de Septiembre de 2012
Nombramientos. Auditor: NEXT AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 387 , F 171, S 8, H SA 1190, I/A 19(18.09.12).

22 de Febrero de 2012
Nombramientos. Con.Ind.: ININ GESTION SL. Otros conceptos: Modificados los art铆culos 21, 26潞, 27潞 y 28潞 de los EstatutosSociales. Datos registrales. T 387 , F 170, S 8, H SA 1190, I/A 16 ( 9.02.12).

16 de Agosto de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 738.869,40 Euros. Resultante Suscrito: 1.277.605,80 Euros. Datos registrales. T 387 , F 167, S 8, HSA 1190, I/A 15 ( 2.08.11).

19 de Julio de 2011
Reelecciones. Auditor: V. GALLEGO CASTA脩ERA Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 387 , F 167, S 8, H SA 1190, I/A 14 (5.07.11).

27 de Abril de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: VI脩A EL CABALLO SL. Nombramientos. Consejero: VI脩A VICTORIA SL. Datos registrales. T 387, F 167, S 8, H SA 1190, I/A 13 (12.04.10).

02 de Marzo de 2010
Nombramientos. Auditor: V. GALLEGO CASTA脩ERA Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 387 , F 166, S 8, H SA 1190, I/A 10(17.02.10).

Nombramientos. Consejero: OSBORNE COLOGAN IGNACIO. Datos registrales. T 387 , F 166, S 8, H SA 1190, I/A 11 (17.02.10).

Ceses/Dimisiones. Consejero: OSBORNE GAMERO-CIVICO TOMAS;OSBORNE COLOGAN IGNACIO. Nombramientos.Consejero: GRAND DISTRIBUCION Y SERVICIOS 99 SL;VI脩A EL CABALLO SL. Datos registrales. T 387 , F 166, S 8, H SA 1190,I/A 12 (17.02.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n