Actos BORME de Empresa Gestora De Aguas Linenses Sl
06 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apoderado: BECERRA GARCIA MARIA SILVANA. Datos registrales. T 36330 , F 72, S 8, H M 575975, I/A 42(27.10.23).
13 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: PARRA MEDIAVILLA FELIX. Nombramientos. Apoderado: PARRA MEDIAVILLA FELIX. Datosregistrales. T 36330 , F 69, S 8, H M 575975, I/A 41 ( 2.12.22).
30 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ RODRIGUEZ-LIEVANA EMILIO. Datos registrales. T 36330 , F 67, S 8, H M 575975,I/A 40 (23.09.21).
19 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ MEDINA FRANCISCO. Vicepresid.: JIMENEZ MEDINA FRANCISCO. Nombramientos.Consejero: FERNANDEZ RODRIGUEZ DE LIEVANA EMILIO. Vicepresid.: FERNANDEZ RODRIGUEZ DE LIEVANA EMILIO. Datosregistrales. T 36330 , F 67, S 8, H M 575975, I/A 39 (12.07.21).
08 de Julio de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: SUAREZ MALDONADO JUSTO PEDRO. Datos registrales. T 36330 , F 65, S 8, H M 575975, I/A38 ( 1.07.20).
03 de Julio de 2020Revocaciones. Apoderado: REINA CUETO ENRIQUE-JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: REINA CUETO ENRIQUE-JOSE.Datos registrales. T 36330 , F 62, S 8, H M 575975, I/A 36 (26.06.20).
Revocaciones. Apoderado: SAEZ ESTEBAN FRANCISCO-RAMON. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAEZ ESTEBANFRANCISCO-RAMON. Datos registrales. T 36330 , F 64, S 8, H M 575975, I/A 37 (26.06.20).
27 de Septiembre de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: PERAITA AGUILAR LUIS ALFONSO. Datos registrales. T 36330 , F 62, S 8, H M 575975, I/A 35(20.09.19).
19 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: ATANASIO GOITIA FRANCISCO. Datos registrales. T 36330 , F 60, S 8, H M 575975, I/A 33(12.06.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARCO FLORIANO ANTONIO. Datos registrales. T 36330 , F 61, S 8, H M 575975, I/A 34(12.06.19).
11 de Junio de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORENO GALVEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 36330 , F 58, S 8, H M 575975, I/A 30 (4.06.19).
Nombramientos. Apoderado: RINCON MAROTO EDUARDO. Datos registrales. T 36330 , F 58, S 8, H M 575975, I/A 31 ( 4.06.19).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CHINCHILLA PEDRO. Datos registrales. T 36330 , F 59, S 8, H M 575975, I/A 32 (4.06.19).
02 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: DURAN LUNA CESAR-ANTONIO. Datos registrales. T 36330 , F 57, S 8, H M 575975, I/A 29(26.03.19).
15 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: PARRA MEDIAVILLA FELIX. Datos registrales. T 36330 , F 51, S 8, H M 575975, I/A 26 ( 7.11.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARBAN FERNANDEZ ISIDORO ANTONIO. Datos registrales. T 36330 , F 54, S 8, H M 575975,I/A 27 ( 7.11.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA PEREZ FELIPE BERNABE;COLIO ABRIL PABLO. Datos registrales. T 36330 , F 57, S 8, H M575975, I/A 28 ( 7.11.18).
15 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apoderado: JARQUE URIBE CARLOS MANUEL. Datos registrales. T 36330 , F 51, S 8, H M 575975, I/A 25 (7.11.17).
24 de Octubre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: COLIO ABRIL PABLO. Datos registrales. T 32541 , F 224, S 8, H M 575975, I/A 24 (14.10.17).
26 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: RUIZ ESPEJO MANUEL. Datos registrales. T 32541 , F 223, S 8, H M 575975, I/A 23 (19.09.17).
29 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORENO GALVEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 32541 , F 222, S 8, H M 575975, I/A 22(19.05.17).
12 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: PERAITA AGUILAR LUIS ALFONSO. Datos registrales. T 32541 , F 221, S 8, H M 575975, I/A 21 (5.05.17).
20 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: BEJAR OCHOA JUAN. Datos registrales. T 32541 , F 221, S 8, H M 575975, I/A 20 (12.11.15).
06 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apoderado: JARQUE URIBE CARLOS MANUEL. Datos registrales. T 32541 , F 217, S 8, H M 575975, I/A 19(29.10.15).
20 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: LAFUENTE PEREZ-LUCAS SANTIAGO;IGLESIAS CASILLA JOSE-ANTONIO. Presidente:LAFUENTE PEREZ-LUCAS SANTIAGO. Vicepresid.: IGLESIAS CASILLA JOSE-ANTONIO. Nombramientos. Consejero: DIAZGAZQUEZ LUCAS. Presidente: DIAZ GAZQUEZ LUCAS. Consejero: JIMENEZ MEDINA FRANCISCO. Vicepresid.: JIMENEZ MEDINAFRANCISCO. Datos registrales. T 32541 , F 217, S 8, H M 575975, I/A 18 (11.05.15).
28 de Abril de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: CORONA FERNANDEZ ALBERTO. Datos registrales. T 32541 , F 215, S 8, H M 575975, I/A 17(20.04.15).
20 de Abril de 2015Nombramientos. Apoderado: SAEZ ESTEBAN FRANCISCO-RAMON. Datos registrales. T 32541 , F 214, S 8, H M 575975, I/A 16(13.04.15).
24 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: DE LOS RIOS JIMENO JUAN. Datos registrales. T 32541 , F 214, S 8, H M 575975, I/A 15(11.03.15).
16 de Enero de 2015Nombramientos. Apoderado: ALCOUCER DIAZ MANUEL. Datos registrales. T 32055 , F 222, S 8, H M 575975, I/A 12 ( 8.01.15).
Nombramientos. Apoderado: BECERRA GARCIA MARIA SILVANA. Datos registrales. T 32055 , F 222, S 8, H M 575975, I/A 13 (8.01.15).
Nombramientos. Apoderado: REINA CUETO ENRIQUE-JOSE. Datos registrales. T 32055 , F 224, S 8, H M 575975, I/A 14 (8.01.15).
09 de Octubre de 2014Nombramientos. Apoderado: VILLALOBOS LINARES FRANCISCO. Datos registrales. T 32055 , F 218, S 8, H M 575975, I/A 9(30.09.14).
Nombramientos. Apoderado: AMOR MARTINEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 32055 , F 219, S 8, H M 575975, I/A 10(30.09.14).
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ MEDINA FRANCISCO. Datos registrales. T 32055 , F 220, S 8, H M 575975, I/A 11(30.09.14).
29 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apoderado: DIAZ GAZQUEZ LUCAS. Datos registrales. T 32055 , F 215, S 8, H M 575975, I/A 8 (19.09.14).