Buscador CIF Logo

Actos BORME Empresa Mixta Aguas De Ubrique Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Empresa Mixta Aguas De Ubrique Sa

Actos BORME Empresa Mixta Aguas De Ubrique Sa - A72262678

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Cadiz para Empresa Mixta Aguas De Ubrique Sa con CIF A72262678

🔙 Perfil de Empresa Mixta Aguas De Ubrique Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Cadiz

Actos BORME de Empresa Mixta Aguas De Ubrique Sa

17 de Noviembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: ISABEL GOMEZ GARCIA;MANUEL ANGEL CHACON GONZALEZ;MANUEL TORORINCON;CABEZAS ARENAS FRANCISCO JAVIER;JORGE OLIVA PEREZ. Presidente: ISABEL GOMEZ GARCIA. Nombramientos.Consejero: JOSE MARIO CASILLAS ARDILA;MANUEL ANGEL CHACON GONZALEZ;MARIANA MORENO GIL;CABEZAS ARENASFRANCISCO JAVIER;VIRGINIA BAZAN CALVILLO. Presidente: JOSE MARIO CASILLAS ARDILA. Datos registrales. T 2451 , F199, S 8, H CA 46845, I/A 23 ( 9.11.23).

28 de Abril de 2023
Otros conceptos: Inscrito el cambio de representante físico de la entidad consejera "SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGUASFILTRADAS SA", siendo actualmente Doña Elena Ollero Rosety. Datos registrales. T 2451 , F 199, S 8, H CA 46845, I/A 22(20.04.23).

17 de Enero de 2023
Reelecciones. Auditor: VACIERO AUDITORES SL. Datos registrales. T 2451 , F 198, S 8, H CA 46845, I/A 21 ( 9.01.23).

10 de Octubre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: SOCIEDAD IBERICA DEL AGUA SIA SA;CONSERVACION Y SISTEMAS SA;INFRAESTRUCTURASY DISTRIBUCION GENERAL DE AGUAS S;SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGUAS FILTRADAS SA. Vicepresid.: SOCIEDAD IBERICADEL AGUA SIA SA. Nombramientos. Consejero: SOCIEDAD IBERICA DEL AGUA SIA SA;CONSERVACION Y SISTEMAS

03 de Febrero de 2022
Nombramientos. Auditor: VACIERO AUDITORES SL. Datos registrales. T 2207 , F 212, S 8, H CA 46845, I/A 19 (27.01.22).

20 de Enero de 2022
Otros conceptos: Cambio de representantes físico en los consejeros "SOCIEDAD IBERICA DEL AGUA SIA SA" , representadaahora por Don Emilio Fernández Rodríguez de Liévana y en la sociedad "CONSERVACION Y SISTEMAS SA" por Don Manuel FerrazSumillera. Datos registrales. T 2207 , F 212, S 8, H CA 46845, I/A 18 (13.01.22).

06 de Abril de 2021
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2207 , F 211, S 8, H CA 46845, I/A 16 (24.03.21).

Otros conceptos: Cambio de representantes fisicos en los consejeros "Ibérica del Agua SIA, S.A.U.",representada ahora por ManuelFerraz Sumillera y en la entidad "Conservación y Sistemas S.A." por Don Antonio Gragera Molina .- Datos registrales. T 2207 , F 211,S 8, H CA 46845, I/A 17 (25.03.21).

18 de Marzo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: CORDOBA CHACON JOSE JOAQUIN. Nombramientos. Consejero: OLIVA PEREZ JORGE. Datosregistrales. T 2207 , F 211, S 8, H CA 46845, I/A 15 ( 9.03.21).

05 de Marzo de 2020
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2207 , F 210, S 8, H CA 46845, I/A 14 (26.02.20).

19 de Septiembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ GARCIA ISABEL;CHACON GONZALEZ MANUEL ANGEL;TORO RINCONMANUEL;BAUTISTA PIÑA JOSE ANTONIO;GARCIA SOLANO JOSE. Presidente: GOMEZ GARCIA ISABEL. Nombramientos.Consejero: CHACON GONZALEZ MANUEL ANGEL;TORO RINCON MANUEL;CABEZAS ARENAS FRANCISCO JAVIER;CORDOBACHACON JOSE JOAQUIN;GOMEZ GARCIA ISABEL. Presidente: GOMEZ GARCIA ISABEL. Datos registrales. T 2207 , F 210, S 8,H CA 46845, I/A 13 (10.09.19).

02 de Octubre de 2018
Nombramientos. Vicepresid.: SOCIEDAD IBERICA DEL AGUA SIA SA. Datos registrales. T 2207 , F 210, S 8, H CA 46845, I/A 12(25.09.18).

06 de Agosto de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ MEDINA FRANCISCO;FERRAZ SUMILLERA MANUEL;CORONA FERNANDEZALBERTO;BENITEZ VALIENTE ANTONIA. Vicepresid.: JIMENEZ MEDINA FRANCISCO. Nombramientos. Consejero:CONSERVACION Y SISTEMAS SA;INFRAESTRUCTURAS Y DISTRIBUCION GENERAL DE AGUAS S;SOCIEDAD ESPAÑOLA DEAGUAS FILTRADAS SA;SOCIEDAD IBERICA DEL AGUA SIA SA. Datos registrales. T 2207 , F 209, S 8, H CA 46845, I/A 10(26.07.18).

29 de Diciembre de 2017
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 4º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambiode domicilio social. C/ HERNAN CORTES 1 Ptl.B (UBRIQUE). Datos registrales. T 2207 , F 209, S 8, H CA 46845, I/A 9(21.12.17).

22 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: MARQUEZ GARCIA SALAZAR MANUEL FRANCISCO. Datos registrales. T 2127 , F 162, S 8, H CA46845, I/A 8 (15.09.16).

16 de Febrero de 2016
Otros conceptos: Ampliación de poderes del director gerente Don Manuel Francisco Márquez García-Salazar. Datos registrales. T2127 , F 161, S 8, H CA 46845, I/A 7 ( 5.02.16).

09 de Febrero de 2016
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2127 , F 160, S 8, H CA 46845, I/A 6 ( 1.02.16).

24 de Septiembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: TORO RINCON MANUEL;GOMEZ GARCIA ISABEL;BAUTISTA PIÑA JOSE ANTONIO;GARCIASOLANO JOSE;GONZALEZ LOBO MARIA REMEDIOS. Presidente: TORO RINCON MANUEL. Nombramientos. Consejero:GOMEZ GARCIA ISABEL;TORO RINCON MANUEL;BAUTISTA PIÑA JOSE ANTONIO;GARCIA SOLANO JOSE;CHACONGONZALEZ MANUEL ANGEL. Datos registrales. T 2127 , F 160, S 8, H CA 46845, I/A 4 (16.09.15).

Nombramientos. Presidente: GOMEZ GARCIA ISABEL. Datos registrales. T 2127 , F 160, S 8, H CA 46845, I/A 5 (16.09.15).

26 de Enero de 2015
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2127 , F 160, S 8, H CA 46845, I/A 3 (15.01.15).

13 de Octubre de 2014
Nombramientos. Presidente: TORO RINCON MANUEL. Vicepresid.: JIMENEZ MEDINA FRANCISCO. Apoderado: CORONAFERNANDEZ ALBERTO;LOPEZ SANCHEZ ROSA MARIA. SecreNoConsj: MATEOS CALZON JUAN CARLOS. D. Gerente:MARQUEZ GARCIA SALAZAR MANUEL FRANCISCO. Datos registrales. T 2127 , F 158, S 8, H CA 46845, I/A 2 ( 6.10.14).

10 de Septiembre de 2014
Constitución. Comienzo de operaciones: 1.09.14. Duración: 25.04.39. Objeto social: Constituye el objeto social de la Sociedad, lagestión y prestación del servicio público, esencial y reservado de suministro domiciliario de agua potable, alcantarillado y depuración deaguas residuales, en el municipio de Ubrique, realizando las siguientes funciones propias del mismo. a) Captac. Domicilio: C/JUZGADO S/N ED DE SERVICIOS MULTIPLES 4& PLANT (UBRIQUE). Capital suscrito: 150.000,00 Euros. Desembolsado:150.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: TORO RINCON MANUEL;JIMENEZ MEDINA FRANCISCO;GARCIA SOLANOJOSE;BAUTISTA PIÑA JOSE ANTONIO;GOMEZ GARCIA ISABEL;GONZALEZ LOBO MARIA REMEDIOS;CORONA FERNANDEZALBERTO;FERRAZ SUMILLERA MANUEL. Apoderado: DIAZ GAZQUEZ LUCAS. Datos registrales. T 2130 , F 67, S 8, H CA 46845,I/A 1 ( 1.09.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información