Actos BORME de Empresa Municipal Almeria Xxi Sa
15 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON;MARTINEZ LABELLA ANA MARIA;ALONSOBONILLO JUAN JOSE;COBOS SANCHEZ MARGARITA;SANCHEZ MARIN MARIA SACRAMENTOS;VILLANUEVA PLEGUEZUELOEUSEBIO FRANCISCO;HERRERA AMATE FATIMA;PEREZ DE LA BLANCA PRADAS JOAQUIN;CAZORLA GARRIDOMIGUEL;MATEOS CAMPOS MARIA DEL CARMEN. Con.Delegado: MARTINEZ LABELLA ANA MARIA. Presidente: FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON. Consejero: DIAZ MARTINEZ PEDRO JOSE;SEGURA ROMAN JUAN JOSE;ROJASFERNANDEZ JUAN FRANCISCO. Nombramientos. Secretario: GOMEZ GARRIDO FERNANDO. Consejero: VAZQUEZ AGUEROMARIA DEL MAR;CABRERA CARMONA ELOISA MARIA;CRUZ MENDOZA DIEGO;NIETO MARTINEZ LORENA DEL MAR;LAYNEZGUIJOSA PAOLA;ENRIQUEZ CABA RAUL;HERRERA AMATE FATIMA;ROJAS FERNANDEZ JUAN FRANCISCO;LORENZO LOPEZALEJANDRO JOSE. Presidente: VAZQUEZ AGUERO MARIA DEL MAR. Con.Delegado: CABRERA CARMONA ELOISA MARIA.Datos registrales. T 1021 , F 215, S 8, H AL 24959, I/A 30 ( 7.09.23).
04 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: COMPADRE NOE LIDIA. Nombramientos. Consejero: DIAZ MARTINEZ PEDRO JOSE;SEGURAROMAN JUAN JOSE;ROJAS FERNANDEZ JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 1021 , F 215, S 8, H AL 24959, I/A 29(22.02.21).
01 de Septiembre de 2020Modificaciones estatutarias. ARTICULO 17º. Composicion y condición de los Consejeros. El Consejo de Administración es el órganode administracion y gestión de la sociedad, a la que representa en juicio y fuera de el. El Consejo de Administración está integrado porel numero de Consejeros que determine la Junta General, en una. Datos registrales. T 1021 , F 214, S 8, H AL 24959, I/A 28(19.08.20).
30 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: CAZORLA GARRIDO MIGUEL;MARTINEZ LABELLA ANA MARIA;ALFONSO GRANERO JOSEANTONIO;CASTELLON RUBIO MIGUEL ANGEL;ALONSO BONILLO JUAN JOSE;DIAZ GARCIA CRISTOBAL;HERNANDEZORLANDI MARIA ISABEL;GUZMAN DE LA ROZA MANUEL;FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON;PLAZA GARCIA INESMARIA;ESTEBAN MARTINEZ RAFAEL. Con.Delegado: MARTINEZ LABELLA ANA MARIA. Vicesecret.: GUZMAN DE LA ROZAMANUEL. Presidente: FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ-PACHECOMONTERREAL RAMON;MARTINEZ LABELLA ANA MARIA;ALONSO BONILLO JUAN JOSE;COBOS SANCHEZMARGARITA;SANCHEZ MARIN MARIA SACRAMENTOS;VILLANUEVA PLEGUEZUELO EUSEBIO FRANCISCO;HERRERA AMATEFATIMA;COMPADRE NOE LIDIA;PEREZ DE LA BLANCA PRADAS JOAQUIN;CAZORLA GARRIDO MIGUEL;MATEOS CAMPOSMARIA DEL CARMEN. Presidente: FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON. Reelecciones. Secretario: GOMEZGARRIDO FERNANDO. Datos registrales. T 1021 , F 213, S 8, H AL 24959, I/A 26 (22.10.19).
Nombramientos. Con.Delegado: MARTINEZ LABELLA ANA MARIA. Datos registrales. T 1021 , F 214, S 8, H AL 24959, I/A 27(22.10.19).
08 de Octubre de 2019Nombramientos. Auditor: GRUPO DEAS FILCO AUDITORES CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 1021 , F 213, S 8, H AL24959, I/A 25 (24.09.19).
07 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ MARTINEZ PEDRO JOSE. Nombramientos. Consejero: ALFONSO GRANERO JOSEANTONIO. Datos registrales. T 1021 , F 212, S 8, H AL 24959, I/A 23 (30.05.19).
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: CASTELLON RUBIO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Con.Delegado: MARTINEZ LABELLAANA MARIA. Datos registrales. T 1021 , F 212, S 8, H AL 24959, I/A 24 (30.05.19).
29 de Mayo de 2019Nombramientos. Consejero: MARTINEZ LABELLA ANA MARIA;CAZORLA GARRIDO MIGUEL. Modificaciones estatutarias."=ARTICULO 17º.- Composición y condición de los consejeros.= El Consejo de Administración es el órgano de administración y gestiónde la Sociedad, a la que representa en juicio y fuera de él. El Consejo de Administración está integrado por el número de consejerosque determine la Junta General, en. Datos registrales. T 1021 , F 211, S 8, H AL 24959, I/A 22 (20.05.19).
30 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: GOMEZ CALVACHE PEDRO. Datos registrales. T 1021 , F 210, S 8, H AL 24959, I/A 21 (19.12.16).
17 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: MARIN GAMEZ NICASIO. Con.Delegado: FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON.Nombramientos. Consejero: CASTELLON RUBIO MIGUEL ANGEL. Con.Delegado: CASTELLON RUBIO MIGUEL ANGEL. Datosregistrales. T 1021 , F 210, S 8, H AL 24959, I/A 20 ( 9.03.16).
22 de Febrero de 2016Nombramientos. Auditor: GRUPO DEAS FILCO AUDITORES CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 1021 , F 210, S 8, H AL24959, I/A 19 ( 9.02.16).
08 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Presidente: RODRIGUEZ COMENDADOR PEREZ LUIS ROGELIO. Consejero: RODRIGUEZ COMENDADORPEREZ LUIS ROGELIO. Nombramientos. Presidente: FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON. Consejero: ALONSOBONILLO JUAN JOSE. Datos registrales. T 1021 , F 210, S 8, H AL 24959, I/A 18 (28.01.16).
09 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ COMENDADOR PEREZ LUIS ROGELIO;VENZAL CONTRERAS PABLOJOSE;GUIJARRO CALVO RAFAEL;RODRIGUEZ RODRIGUEZ ESTEBAN TELESFORO;DE HARO BALAO DOLORES;MUÑIZGARCIA MARIA;ABAD VIVAS-PEREZ RAFAELA;RODRIGUEZ FORURIA CLARA INES;ESTEBAN MARTINEZ RAFAEL. Presidente:RODRIGUEZ COMENDADOR PEREZ LUIS ROGELIO. Vicepresid.: VENZAL CONTRERAS PABLO JOSE. Con.Delegado: VENZALCONTRERAS PABLO JOSE. Vicesecret.: MUÑIZ GARCIA MARIA. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ COMENDADORPEREZ LUIS ROGELIO;FERNANDEZ-PACHECO MONTERREAL RAMON;GUZMAN DE LA ROZA MANUEL;DIAZ GARCIACRISTOBAL;DIAZ MARTINEZ PEDRO JOSE;HERNANDEZ ORLANDI MARIA ISABEL;ESTEBAN MARTINEZ RAFAEL;MARINGAMEZ NICASIO;PLAZA GARCIA INES MARIA. Reelecciones. Secretario: GOMEZ GARRIDO FERNANDO. Datos registrales. T1021 , F 208, S 8, H AL 24959, I/A 16 ( 2.09.15).
Nombramientos. Presidente: RODRIGUEZ COMENDADOR PEREZ LUIS ROGELIO. Con.Delegado: FERNANDEZ-PACHECOMONTERREAL RAMON. Secretario: GUZMAN DE LA ROZA MANUEL. Datos registrales. T 1021 , F 208, S 8, H AL 24959, I/A 17 (2.09.15).
11 de Marzo de 2013Nombramientos. Auditor: GRUPO RONDA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1021 , F 208, S 8, H AL 24959, I/A 15(25.02.13).
25 de Enero de 2013Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-Se fija el domicilio en Almería, en la Plaza Caragea, nº 7, C.P.04003. El Consejo de Administación tendrá competencia para cambiar su domicilio, dentro del término municipal, así como paraacordarla creación o el traslado de sucursales.. Cambio de domicilio social. PLAZA CAREAGA 7 (ALMERIA). Datos registrales. T1021 , F 208, S 8, H AL 24959, I/A 14 (17.01.13).
15 de Octubre de 2012Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: http://www.almeria21.com. Datos registrales. T 1021 , F 208, S8, H AL 24959, I/A 1n ( 1.10.12).
10 de Octubre de 2012Nombramientos. Apoderado: GOMEZ CALVACHE PEDRO. Datos registrales. T 1021 , F 208, S 8, H AL 24959, I/A 13 (28.09.12).
09 de Julio de 2012Nombramientos. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SA. Datos registrales. T 1021 , F 208, S 8, H AL 24959, I/A 12(27.06.12).
20 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: ESPINAR BUESO ANTONIO. Consejero: VENZAL CONTRERAS PABLO JOSE;MUÑIZ GARCIAMARIA;SOTO RICO MARIA ROSARIO;ORTEGA MARTINEZ MARIA PILAR;PLAZA GARCIA INES MARIA;MEGINO LOPEZ JUANFRANCISCO;RODRIGUEZ COMENDADOR PEREZ LUIS ROGELIO. Vicesecret.: VENZAL CONTRERAS PABLO JOSE.Con.Delegado: MEGINO LOPEZ JUAN FRANCISCO. Presidente: RODRIGUEZ COMENDADOR PEREZ LUIS ROGELIO. Consejero:ESTEBAN MARTINEZ RAFAEL;GARRIDO MAYORAL FRANCISCO. Nombramientos. Secretario: GOMEZ GARRIDO FERNANDO.Consejero: GUIJARRO CALVO RAFAEL;VENZAL CONTRERAS PABLO JOSE. Vicepresid.: VENZAL CONTRERAS PABLO JOSE.Con.Delegado: VENZAL CONTRERAS PABLO JOSE. Consejero: MUÑIZ GARCIA MARIA;ABAD VIVAS-PEREZ RAFAELA;DE HAROBALAO DOLORES;RODRIGUEZ RODRIGUEZ ESTEBAN TELESFORO;RODRIGUEZ FORURIA CLARA INES;ESTEBAN MARTINEZRAFAEL. Vicesecret.: MUÑIZ GARCIA MARIA. Secretario: GOMEZ GARRIDO FERNANDO. Datos registrales. T 1021 , F 207, S 8, HAL 24959, I/A 11 (10.10.11).
20 de Septiembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: CERVANTES OCAÑA DIEGO JESUS. Nombramientos. Consejero: ESTEBAN MARTINEZRAFAEL. Datos registrales. T 1021 , F 206, S 8, H AL 24959, I/A 9 ( 6.09.10).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CANTON GONGORA ANTONIO. Nombramientos. Consejero: GARRIDO MAYORAL FRANCISCO.Datos registrales. T 1021 , F 206, S 8, H AL 24959, I/A 10 ( 6.09.10).
20 de Abril de 2010Reducción de capital. Importe reducción: 1.667.019,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.876.927,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital.- El capital social, que estará íntegramente suscrito y desembolsado por el Excmo.Ayuntamiento de Almería, propietario exclusivo del mismo, es de 4.876.927 euros. . Artículo 7. Acciones. El valor del capital social esde 4.876.927 euros. Está dividido en cuatro millones ochocientas setenta y seis mil novecientas veintisiete acciones nominativas deigual valor. El valor nominal de cada acción es de 1 euro. Todas las acciones corresponden a una única clase y se. Datos registrales.
Reducción de capital. Importe reducción: 2.259.797,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.617.130,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital.- El capital social, que está íntegramente suscrito y desembolsado por el Excmo.Ayuntamietno de Almería, propietario exclusivo del mismo, es de 2.617.130 Euros.. Artículo 7. Acciones. El valor del capital social esde 2.617.130 euros. Está dividido en dos millones seiscientas diecisiete mil ciento trienta acciones nominativas de igual valor. El valornominal de cada acción es de 1 euro.. Datos registrales. T 1021 , F 206, S 8, H AL 24959, I/A 8 ( 8.04.10).