Actos BORME de Empresa Municipal De La Vivienda De Coslada Sa
20 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ DIAZ JUAN;HIDALGO GARCIA ROCIO;HUETE PEREZ JULIO;MARTINEZ NAUSIA JOSEMIGUEL;AGUILAR CRESPO CRISTINA CARMEN. Vicepresid.: HUETE PEREZ JULIO. Secretario: AGUILAR CRESPO CRISTINACARMEN. Consejero: GARRETAS LAGUNA MARIA PAZ. Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ AUSIN MARIA TERESA;HUETEPEREZ JULIO;LA PORTE FERNANDEZ ALFARO MARIA ISABEL. Nombramientos. Consejero: OROSA HIDALGOMACARENA;VICENTE LEO ANTONIO;NOEDA FANEGO SONIA;ROMERO CASTRO FERNANDO;GARRETAS LAGUNAOSCAR;VIONDI ARESE FRANCISCO JAVIER;LEBRATO BUSTOS ELENA;DIAZ-SUELTO GARCIA-HINOJOSA JESUSDOMINGO.Presidente: OROSA HIDALGO MACARENA. Vicepresid.: ROMERO CASTRO FERNANDO. Secretario: LEBRATO BUSTOS ELENA.Apo.Man.Soli: OROSA HIDALGO MACARENA;ROMERO CASTRO FERNANDO;LA PORTE FERNANDEZ ALFARO MARIA ISABEL.Reelecciones. Consejero: ECHEVARRIA SIERRA MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 40595 , F 121, S 8, H M 94334, I/A 81(13.11.23).
10 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ AUSIN MARIA TERESA. Presidente: GONZALEZ AUSIN MARIA TERESA. Datosregistrales. T 40595 , F 121, S 8, H M 94334, I/A 80 ( 2.11.23).
17 de Abril de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.906.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.460.892,45 Euros. Datos registrales. T 40595, F 120, S 8, H M 94334, I/A 78 (10.04.23).
Ceses/Dimisiones. Consejero: BALADRON FERRERO JOSE LUIS. Datos registrales. T 40595 , F 120, S 8, H M 94334, I/A 79(10.04.23).
10 de Febrero de 2023Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 587/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 28/11/2022. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID. Juez: DON ANDRES SANCHEZ MAGRO.Resoluciones: "1.- Se declara cumplido 铆ntegramente el convenio suscrito por el deudor EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DECOSLADA S.A.U. con sus acreedores y que fue aprobado por sentencia de este Juzgado de 05/06/2019, dictada en esteprocedimiento concursal. Datos registrales. T 40595 , F 120, S 8, H M 94334, I/A 77 ( 5.02.23).
13 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: MARTINEZ RAMOS FRANCISCA PILAR. Aud.Supl.: MILLAN MARTINEZ MARIA GLORIA. Datosregistrales. T 40595 , F 119, S 8, H M 94334, I/A 76 ( 5.01.23).
13 de Septiembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ BARAS MIGUEL. Nombramientos. Consejero: GARRETAS LAGUNA MARIA PAZ.Datos registrales. T 40595 , F 119, S 8, H M 94334, I/A 75 ( 6.09.22).
02 de Marzo de 2022Nombramientos. Auditor: MARTINEZ RAMOS FRANCISCA PILAR. Aud.Supl.: MILLAN MARTINEZ MARIA GLORIA. Datosregistrales. T 40595 , F 119, S 8, H M 94334, I/A 74 (23.02.22).
24 de Noviembre de 2021Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 232.496,85 Euros. Desembolsado: 232.496,85 Euros. Resultante Suscrito: 8.367.392,45 Euros.Resultante Desembolsado: 8.367.392,45 Euros. Datos registrales. T 40595 , F 118, S 8, H M 94334, I/A 73 (17.11.21).
26 de Octubre de 2020Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 874.424,95 Euros. Desembolsado: 874.424,95 Euros. Resultante Suscrito: 8.134.895,60 Euros.Resultante Desembolsado: 8.134.895,60 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 30312 , F 225, S 8, H M 94334, I/A 72 (19.10.20).
23 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: RODA LOPEZ MARIA ANGELES;ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO;LOPEZ GALANJOAQUIN;CALVO ASENSIO SERGIO;ROBLES LOPEZ VIRGINIA;PULIDO PULIDO LOURDES. Presidente: ARROYO LAZAROMARIA DEL ROSARIO. Consejero: ALONSO GARCIA ANDRES. Vicepresid.: ALONSO GARCIA ANDRES. Consejero: GONZALEZJIMENEZ DAVID ALEJANDRO. Secretario: GONZALEZ JIMENEZ DAVID ALEJANDRO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZAUSIN MARIA TERESA;PEREZ DIAZ JUAN;HIDALGO GARCIA ROCIO;HUETE PEREZ JULIO;BALADRON FERRERO JOSELUIS;MARTINEZ NAUSIA JOSE MIGUEL;AGUILAR CRESPO CRISTINA CARMEN;ECHEVARRIA SIERRA MARIA CRISTINA.Secretario: LAZARO SANZ DIEGO. Consejero: LAZARO SANZ DIEGO. Presidente: GONZALEZ AUSIN MARIA TERESA. Vicepresid.:HUETE PEREZ JULIO. Datos registrales. T 30312 , F 223, S 8, H M 94334, I/A 69 (16.10.20).
Revocaciones. Apoderado: ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO;ALONSO GARCIA ANDRES;LA PORTE FERNANDEZ-ALFARO ISABEL. Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ AUSIN MARIA TERESA;HUETE PEREZ JULIO;LA PORTEFERNANDEZ ALFARO MARIA ISABEL. Datos registrales. T 30312 , F 224, S 8, H M 94334, I/A 70 (16.10.20).
Ceses/Dimisiones. Consejero: LAZARO SANZ DIEGO. Secretario: LAZARO SANZ DIEGO. Nombramientos. Consejero:RODRIGUEZ BARAS MIGUEL. Secretario: AGUILAR CRESPO CRISTINA CARMEN. Datos registrales. T 30312 , F 225, S 8, H M94334, I/A 71 (16.10.20).
18 de Septiembre de 2020Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 587/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 4/12/2019. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID. Juez: ANDRES SANCHEZ MAGRO.Resoluciones: APROBACION DEL CONVENIO SEGUN MANDAMIENTO FIRME EXPEDIDO EL 5 DE JUNIO DE 2019,.POR ELJUZGADO DE LO MERCANTIL N潞 2 DE MADRID, NUMERO DE PROCEDIMIENTO 587/2014. Datos registrales. T 30312 , F 222, S8, H M 94334, I/A 68 (11.09.20).
28 de Enero de 2020Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 587/2014. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 5/06/2019. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID. Juez: ANDRES SANCHEZ MAGRO.Resoluciones: ANOTACION PREVENTIVA DE LA SENTENCIA DE APROBACION DEL CONVENIO; CESE DELOS.ADMINISTRADORES CONCURSALES; FECHA CESE: 5 DE JUNIO DE 2019. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal587/2014. Fecha de resoluci贸n 25/10/2016. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LOMERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANDRES SANCHEZ MAGRO. Administrador Concursal. Fecha 5/06/2019, NIF/CIF 44387015M.ROLDAN MARTINEZ VICENTE. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 587/2014. Fecha de resoluci贸n 25/10/2016.Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANDRESSANCHEZ MAGRO. Auxiliar Delegado Concursal. Fecha 5/06/2019, NIF/CIF 08947617L. GALIANA AGUERA JUAN JOSE. Datosregistrales. T 30312 , F 221, S 8, H M 94334, I/A A (21.01.20).
16 de Enero de 2018Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 587/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 25/10/2016. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANDRES SANCHEZ MAGRO.Resoluciones: Mandamiento expedido el d铆a 11.11.16 ordenando la anotaci贸n preventiva de la declaraci贸n de concurso de car谩ctervoluntario necesario, seg煤n se acord贸 en resoluci贸n de 25.10.2016. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 587/2014. Fechade resoluci贸n 25/10/2016. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez:DON ANDRES SANCHEZ MAGRO. Administrador Concursal. Fecha 25/10/2016, NIF/CIF 44387015M. ROLDAN MARTINEZVICENTE. Auxiliar Delegado Concursal. Fecha 25/10/2016, NIF/CIF 08947617L. GALIANA AGUERA JUAN JOSE. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 587/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 25/10/2016. Resoluciones acordando la intervenci贸n osuspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DEMADRID. Juez: DON ANDRES SANCHEZ MAGRO. Datos registrales. T 30312 , F 220, S 8, H M 94334, I/A 67 ( 5.01.18).
27 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: OTERO PEREZ VALENTIN;LUQUE LORA JOSE. Secretario: LUQUE LORA JOSE.Nombramientos. Consejero: ALONSO GARCIA ANDRES;GONZALEZ JIMENEZ DAVID ALEJANDRO. Secretario: GONZALEZJIMENEZ DAVID ALEJANDRO. Vicepresid.: ALONSO GARCIA ANDRES. Datos registrales. T 30312 , F 218, S 8, H M 94334, I/A 64(20.11.15).
Nombramientos. Apoderado: ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO;ALONSO GARCIA ANDRES;LA PORTE FERNANDEZ-ALFARO ISABEL. Datos registrales. T 30312 , F 219, S 8, H M 94334, I/A 65 (20.11.15).
Revocaciones. Apoderado: SAA GARCIA ANA MARIA;ALONSO GARCIA ANDRES;LA PORTE FERNANDEZ-ALFARO ISABEL;SAAGARCIA ANA MARIA;LA PORTE FERNANDEZ ALFARO MARIA ISABEL;SAA GARCIA ANA MARIA;SAA GARCIA ANA MARIA.Datos registrales. T 30312 , F 220, S 8, H M 94334, I/A 66 (20.11.15).
19 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO. Vicepresid.: ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO.Consejero: SAA GARCIA ANA MARIA;LOPEZ GALAN JOAQUIN;ALONSO GARCIA ANDRES. Presidente: SAA GARCIA ANA MARIA.Vicepresid.: ALONSO GARCIA ANDRES. Consejero: BRANDIS GARCIA-VILLALBA CONCEPCION. Secretario: BRANDIS GARCIA-VILLALBA CONCEPCION. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ HERNANDEZ LAURENTINO.Nombramientos. Consejero: ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO;LOPEZ GALAN JOAQUIN;OTERO PEREZVALENTIN;CALVO ASENSIO SERGIO;ROBLES LOPEZ VIRGINIA;PULIDO PULIDO LOURDES;LUQUE LORA JOSE. Presidente:ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO. Secretario: LUQUE LORA JOSE. Reelecciones. Consejero: RODA LOPEZ MARIAANGELES. Datos registrales. T 30312 , F 218, S 8, H M 94334, I/A 62 (11.11.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO. Datos registrales. T 30312 , F 218, S 8, H M 94334, I/A63 (11.11.15).
15 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GIL BARAHONA MAURICIO JOSE. Datos registrales. T 30312 , F 217, S 8, H M 94334, I/A 61 (6.10.15).
16 de Julio de 2014Revocaciones. Apoderado: MURILLO DIAZ ANTONIO;MURILLO DIAZ ANTONIO;HUELAMO SAMPEDRO JOSE;MURILLO DIAZANTONIO;HUELAMO SAMPEDRO JOSE. Apo.Manc.: MURILLO DIAZ ANTONIO;GRANADOS RODRIGUEZ JUANMANUEL;MORGAOD GOMEZ FELIX. Apoderado: GRANADOS RODRIGUEZ JUAN MANUEL;MORENO MARTINEZ MARIAISABEL;BARTOLOME LLORENTE JUAN CARLOS;BARTOLOME LLORENTE JUAN CARLOS;GRANADOS RODRIGUEZ JUANMANUEL;MORENO MARTINEZ MARIA ISABEL;BARTOLOME LLORENTE JUAN CARLOS;BARTOLOME LLORENTE JUANCARLOS;ROBLES SEPULVEDA MARCO ANTONIO;MURILLO DIAZ ANTONIO;GARCIA FERRER JUAN JOSE;MURILLO DIAZANTONIO;MURILLO DIAZ ANTONIO;MURILLO DIAZ ANTONIO;MURILLO DIAZ ANTONIO. Apo.Manc.: GUISADO RODRIGUEZAGUSTIN. Apo.Sol.: GUISADO RODRIGUEZ AGUSTIN. Apo.Manc.: SAN FRUTOS PEREZ PEDRO;ZAMARRA ALVARO JUANANTONIO. Apo.Sol.: ZAMARRA ALVARO JUAN ANTONIO. Apoderado: GUISADO RODRIGUEZ AGUSTIN;GUISADO RODRIGUEZAGUSTIN;GUISADO RODRIGUEZ AGUSTIN;GUISADO RODRIGUEZ AGUSTIN;GUISADO RODRIGUEZ AGUSTIN;GUISADORODRIGUEZ AGUSTIN;GUISADO RODRIGUEZ AGUSTIN. Apo.Man.Soli: GOMEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES. Apo.Manc.:ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO. Apo.Man.Soli: LA PORTE FERNANDEZ ALFARO MARIA ISABEL. Apo.Manc.: GOMEZFERNANDEZ MARIA DOLORES;ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO;LA PORTE FERNANDEZ-ALFARO ISABEL.Apo.Man.Soli: GOMEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES;LA PORTE FERNANDEZ-ALFARO ISABEL;ARROYO LAZARO MARIA DELROSARIO. Otros conceptos: Revocado el poder conferido a Don Jos茅 Huelamo Sampedro, que caus贸 la inscripci贸n 3& de la hojaregistral. Revocados los poderes otorgados a don Agust铆n Guisado Rodr铆guez y Don Pedro San Frutos P茅rez, que causar贸n lainscripci贸n 42 de la hoja registral. Datos registrales. T 30312 , F 217, S 8, H M 94334, I/A 60 ( 8.07.14).
13 de Febrero de 2014Reelecciones. Consejero: RODA LOPEZ MARIA ANGELES. Datos registrales. T 30312 , F 216, S 8, H M 94334, I/A 59 ( 4.02.14).
26 de Junio de 2013Nombramientos. Presidente: SAA GARCIA ANA MARIA. Vicepresid.: ALONSO GARCIA ANDRES. Apoderado: SAA GARCIA ANAMARIA;ALONSO GARCIA ANDRES;LA PORTE FERNANDEZ-ALFARO ISABEL;SAA GARCIA ANA MARIA;LA PORTE FERNANDEZALFARO MARIA ISABEL;SAA GARCIA ANA MARIA;SAA GARCIA ANA MARIA. Datos registrales. T 30312 , F 216, S 8, H M 94334,I/A 58 (18.06.13).
28 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MANZANO ALONSO MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. Consejero: GIL BARAHONAMAURICIO JOSE. Datos registrales. T 30312 , F 215, S 8, H M 94334, I/A 57 (20.05.13).
27 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Presidente: GOMEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES. Consejero: GOMEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES.Nombramientos. Consejero: ALONSO GARCIA ANDRES. Datos registrales. T 30312 , F 215, S 8, H M 94334, I/A 56 (17.05.13).
13 de Diciembre de 2012Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN Y REFUNDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD -. Datosregistrales. T 5765 , F 224, S 8, H M 94334, I/A 55 ( 4.12.12).
12 de Julio de 2012Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5765 , F 223, S 8, H M 94334, I/A 54 ( 2.07.12).
22 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: HERRERA MEDINA VICTOR. Consejero: HERRERA MEDINA VICTOR. Nombramientos.Consejero: BRANDIS GARCIA-VILLALBA CONCEPCION. Secretario: BRANDIS GARCIA-VILLALBA CONCEPCION. Datosregistrales. T 5765 , F 223, S 8, H M 94334, I/A 53 (13.06.12).
03 de Febrero de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: GOMEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES;ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO;LA PORTEFERNANDEZ-ALFARO ISABEL. Apo.Man.Soli: GOMEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES;LA PORTE FERNANDEZ-ALFAROISABEL;ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO. Datos registrales. T 5765 , F 222, S 8, H M 94334, I/A 51 (25.01.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ MARINA IVAN. Nombramientos. Consejero: LOPEZ GALAN JOAQUIN. Datos registrales.T 5765 , F 223, S 8, H M 94334, I/A 52 (25.01.12).
26 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Gerente: ALVARO MARTIN ADOLFO. Consejero: GUISADO RODRIGUEZ AGUSTIN;SEGURADO CORVILLODOLORES;SAN FRUTOS PEREZ PEDRO;CABEZA BARROSO FIDEL L. Presidente: GUISADO RODRIGUEZ AGUSTIN. Vicepresid.:SAN FRUTOS PEREZ PEDRO. Consejero: ALONSO GARCIA ANDRES;PERAL VEGA JOSE ANTONIO;SANTOS RODRIGUEZJUAN. Secretario: ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO. Revocaciones. Apoderado: ALVARO MARTIN ADOLFO.Nombramientos. Presidente: GOMEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES. Vicepresid.: ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO.Secretario: HERRERA MEDINA VICTOR. Gerente: LA PORTE FERNANDEZ ALFARO MARIA ISABEL. Consejero: GOMEZFERNANDEZ MARIA DOLORES;SAA GARCIA ANA MARIA;HERRERA MEDINA VICTOR;LOPEZ MARINA IVAN;RODRIGUEZHERNANDEZ LAURENTINO;MANZANO ALONSO MARIA DEL CARMEN. Apo.Man.Soli: GOMEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES.Apo.Manc.: ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO. Apo.Man.Soli: LA PORTE FERNANDEZ ALFARO MARIA ISABEL.Reelecciones. Consejero: ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO. Datos registrales. T 5765 , F 220, S 8, H M 94334, I/A 50(13.09.11).
07 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: GUISADO RODRIGUEZ AGUSTIN. Datos registrales. T 5765 , F 219, S 8, H M 94334, I/A 49(27.12.10).
23 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: GUISADO RODRIGUEZ AGUSTIN. Datos registrales. T 5765 , F 219, S 8, H M 94334, I/A 48(11.02.10).
17 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: MENA OSA ANGEL. Nombramientos. Consejero: SANTOS RODRIGUEZ JUAN. Datosregistrales. T 5765 , F 217, S 8, H M 94334, I/A 46 ( 5.02.10).
Nombramientos. Apoderado: GUISADO RODRIGUEZ AGUSTIN. Datos registrales. T 5765 , F 218, S 8, H M 94334, I/A 47 (5.02.10).
15 de Julio de 2009Nombramientos. Apoderado: GUISADO RODRIGUEZ AGUSTIN. Datos registrales. T 5765 , F 217, S 8, H M 94334, I/A 45 (3.07.09).
01 de Julio de 2009Ceses/Dimisiones. Gerente: ZAMARRA ALVARO JUAN ANTONIO. Consejero: CORTES SAEZ MONICA. Secretario: CORTESSAEZ MONICA. Nombramientos. Consejero: PERAL VEGA JOSE ANTONIO. Gerente: ALVARO MARTIN ADOLFO. Apoderado:ALVARO MARTIN ADOLFO. Secretario: ARROYO LAZARO MARIA DEL ROSARIO. Datos registrales. T 5765 , F 215, S 8, H M94334, I/A 42 (20.06.09).
Nombramientos. Apoderado: GUISADO RODRIGUEZ AGUSTIN. Datos registrales. T 5765 , F 216, S 8, H M 94334, I/A 43(20.06.09).
Reelecciones. Consejero: RODA LOPEZ MARIA ANGELES. Datos registrales. T 5765 , F 217, S 8, H M 94334, I/A 44 (20.06.09).