Buscador CIF Logo

Actos BORME Empresa Municipal De Servicios De Ciudad Real Sociedad Limitada

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Empresa Municipal De Servicios De Ciudad Real Sociedad Limitada

Actos BORME Empresa Municipal De Servicios De Ciudad Real Sociedad Limitada - B13413547

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Ciudad Real para Empresa Municipal De Servicios De Ciudad Real Sociedad Limitada con CIF B13413547

🔙 Perfil de Empresa Municipal De Servicios De Ciudad Real Sociedad Limitada
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Ciudad Real

Actos BORME de Empresa Municipal De Servicios De Ciudad Real Sociedad Limitada

25 de Mayo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: MORALES CAZALLAS RAFAEL ANGEL;MARTINEZ ARCOS SARA SUSANA;SERRANO DE LAMUÑOZA DAVID;SANCHEZ CRUZADO ALDANA REMEDIOS;TURRILLO GOMEZ FELIPE;FERNANDEZ MORALES JORGE.Vicepresid.: MARTINEZ ARCOS SARA SUSANA. Presidente: SERRANO DE LA MUÑOZA DAVID. Nombramientos. Consejero:SERRANO DE LA MUÑOZA DAVID;MARTINEZ ARCOS SARA SUSANA;RONCERO GARCIA-CARPINTERO MARIA DELROSARIO;MAROTO MOJONERO PEDRO;HERRERA FERNANDEZ MARIO;RUIZ VALDEPEÑAS MOLINO JOSEANTONIO;MORALES CAZALLAS RAFAEL ANGEL;MERINO VERA FERMIN;RODRIGUEZ-REY EXPOSITO MARIA TERESA.Presidente: SERRANO DE LA MUÑOZA DAVID. Vicepresid.: MARTINEZ ARCOS SARA SUSANA. SecreNoConsj: GONZALEZ-ALBOMORALES JOSE. Datos registrales. T 577 , F 85, S 8, H CR 15373, I/A 43 (18.05.21).

Nombramientos. Apoderado: SERRANO DE LA MUÑOZA DAVID. Datos registrales. T 577 , F 85, S 8, H CR 15373, I/A 44(18.05.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: HERRERA FERNANDEZ MARIO. Nombramientos. Consejero: PEINADO FERNANDEZ-ESPARTERO NIEVES. Datos registrales. T 577 , F 86, S 8, H CR 15373, I/A 45 (18.05.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ VALDEPEÑAS MOLINO JOSE ANTONIO. Nombramientos. Consejero: BLAZQUEZ GARCIA-VALENZUELA LUIS-JUAN. Datos registrales. T 577 , F 86, S 8, H CR 15373, I/A 46 (18.05.21).

30 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMACHO AYUSO SATURNINO. Nombramientos. Consejero: MORALES CAZALLAS RAFAELANGEL. Datos registrales. T 577 , F 85, S 8, H CR 15373, I/A 42 (21.11.18).

05 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Presidente: FERNANDEZ MORALES JORGE. Vicepresid.: SERRANO DE LA MUÑOZA DAVID.Nombramientos. Presidente: SERRANO DE LA MUÑOZA DAVID. Vicepresid.: MARTINEZ ARCOS SARA SUSANA. Datosregistrales. T 524 , F 204, S 8, H CR 15373, I/A 39 (15.11.17).

Nombramientos. Apoderado: SERRANO DE LA MUÑOZA DAVID. Datos registrales. T 524 , F 204, S 8, H CR 15373, I/A 40(15.11.17).

Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ GALLARDO PATRICIA. Datos registrales. T 524 , F 205, S 8, H CR 15373, I/A 41 (15.11.17).

02 de Octubre de 2017
Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ GALLARDO PATRICIA. Datos registrales. T 524 , F 204, S 8, H CR 15373, I/A 38 (13.09.17).

05 de Mayo de 2016
Nombramientos. Presidente: FERNANDEZ MORALES JORGE. Vicepresid.: SERRANO DE LA MUÑOZA DAVID. SecreNoConsj:GONZALEZ-ALBO MORALES JOSE. Apoderado: FERNANDEZ MORALES JORGE. Datos registrales. T 524 , F 203, S 8, H CR15373, I/A 37 (22.04.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información