Actos BORME de Empresa Municipal De Transportes De Valencia Sa
21 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: CHINER Y PALMI JOSEP IGNASI. Datos registrales. T 10920, L 8198, F 43, S 8, H V 10607, I/A 98(14.11.23).
31 de Agosto de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: GREZZI GIUSEPPE;SORIANO RODRIGUEZ MARIA PILAR;BEAMUD VILLANUEVA LUCIA;VALIACOTANDA ELISA;TORRADO DE CASTRO MARTA;MUNDINA GOMEZ CARLOS;ESTELLES ESCORIHUELA NARCISO;MONTA脩EZVALENZUELA VICENTE. Presidente: GREZZI GIUSEPPE. Vicepresid.: VALIA COTANDA ELISA. Consejero: SANJUAN ROCABORJA JESUS. Nombramientos. Consejero: CARBONELL AGUILAR JESUS;MUNDINA GOMEZ CARLOS LUIS;GIL UNCIO MARIADEL ROCIO;RIBO CANUT JOAN;GREZZI GIUSEPPE;PEREZ HERRERO MARIA;BADENAS CARPIO JUAN MANUEL. Datosregistrales. T 10920, L 8198, F 41, S 8, H V 10607, I/A 94 (24.08.23).
Revocaciones. Apo.Sol.: GREZZI GIUSEPPE;VALIA COTANDA ELISA. Nombramientos. Apo.Sol.: CARBONELL AGUILARJESUS;MUNDINA GOMEZ CARLOS LUIS. Presidente: CARBONELL AGUILAR JESUS. Vicepresid.: MUNDINA GOMEZ CARLOSLUIS. Datos registrales. T 10920, L 8198, F 42, S 8, H V 10607, I/A 95 (24.08.23).
Ceses/Dimisiones. D. Gerente: SERRANO BALBUENA MARTA ELIA. Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GARCIA DE DIOSANTONIO;MARTINEZ GARCIA DE DIOS ANTONIO. Datos registrales. T 10920, L 8198, F 43, S 8, H V 10607, I/A 96 (24.08.23).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 15.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:30.000.000,00 Euros. Desembolsado: 30.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 30.000.000,00 Euros. Resultante Desembolsado:30.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 10920, L 8198, F 41, S 8, H V 10607, I/A 93 (24.08.23).
Revocaciones. Apoderado: SERRANO BALBUENA MARTA ELIA. Nombramientos. D. Gerente: MARTINEZ GRAU MANUEL.Apoderado: MARTINEZ GRAU MANUEL. Datos registrales. T 10920, L 8198, F 43, S 8, H V 10607, I/A 97 (24.08.23).
06 de Febrero de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GARCIA DE DIOS ANTONIO. Datos registrales. T 10920, L 8198, F 40, S 8, H V10607, I/A 92 (30.01.23).
29 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Modificaciones estatutarias. Art铆culo 18.- El Consejo, convocado por elpresidente o el que haga sus veces. Art铆culo 19.- Los acuerdos se adoptar谩n por mayor铆a absoluta de los consejeros que concurran ala sesi贸n en modalidad presencial o telem谩tica. Adicionado el "ARTICULO 9 bis.- Celebraci贸n telem谩tica de la Junta General." a losestatutos de la sociedad. Datos registrales. T 10920, L 8198, F 40, S 8, H V 10607, I/A 91 (22.11.22).
25 de Enero de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ GARCIA DE DIOS ANTONIO. Apo.Man.Soli: GARCIA ALEMANY JOSEP-ENRIC. Datosregistrales. T 10028, L 7310, F 136, S 8, H V 10607, I/A 90 (18.01.21).
16 de Diciembre de 2020Nombramientos. D. Gerente: SERRANO BALBUENA MARTA ELIA. Apoderado: SERRANO BALBUENA MARTA ELIA. Datosregistrales. T 10028, L 7310, F 136, S 8, H V 10607, I/A 89 ( 9.12.20).
17 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: RAYON ALEDO MARIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: APARISI NAVARRO ESMERALDA. Datosregistrales. T 10028, L 7310, F 135, S 8, H V 10607, I/A 88 ( 9.11.20).
22 de Octubre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ GARCIA DE DIOS ANTONIO. Datos registrales. T 10028, L 7310, F 134, S 8, H V 10607,I/A 87 (15.10.20).
21 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. D. Gerente: GARCIA ALEMANY JOSEP-ENRIC. Revocaciones. Apoderado: GARCIA ALEMANY JOSEP-ENRIC. Datos registrales. T 10028, L 7310, F 134, S 8, H V 10607, I/A 86 (13.10.20).
06 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: VILAR ZANON RAMON. Nombramientos. Consejero: SANJUAN ROCA BORJA JESUS. Datosregistrales. T 10028, L 7310, F 134, S 8, H V 10607, I/A 85 (29.09.20).
03 de Julio de 2020Nombramientos. Vicesecret.: ALVAREZ GUAITA VIRGINIA. Datos registrales. T 10028, L 7310, F 134, S 8, H V 10607, I/A 84(26.06.20).
31 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Secretario: MARTINEZ TARIN SALVADOR. Nombramientos. Secretario: LLAVADOR CISTERNES HILARIO.Datos registrales. T 10028, L 7310, F 133, S 8, H V 10607, I/A 82 (24.01.20).
08 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: GARCIA ALEMANY JOSEP-ENRIC. Reelecciones. Secretario: MARTINEZ TARIN SALVADOR. D.Gerente: GARCIA ALEMANY JOSEP-ENRIC. Datos registrales. T 10028, L 7310, F 132, S 8, H V 10607, I/A 81 (31.10.19).
16 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: GREZZI GIUSEPPE;SORIANO RODRIGUEZ MARIA PILAR;SARRIA MORELL VICENT;MENDOZASEGUI ALBERTO;FERNANDEZ-CHECA RUIZ ALEJANDRO;ESTELLES ESCORIHUELA NARCISO. Presidente: GREZZI GIUSEPPE.Vicepresid.: SARRIA MORELL VICENT. Consejero: OLIVER SANZ MARIA. Revocaciones. Apo.Manc.: GREZZI GIUSEPPE;SARRIAMORELL VICENT. Nombramientos. Apo.Sol.: GREZZI GIUSEPPE;VALIA COTANDA ELISA. Consejero: GREZZIGIUSEPPE;SORIANO RODRIGUEZ MARIA PILAR;BEAMUD VILLANUEVA LUCIA;VILAR ZANON RAMON;VALIA COTANDAELISA;TORRADO DE CASTRO MARTA;MUNDINA GOMEZ CARLOS LUIS;ESTELLES ESCORIHUELA NARCISO;MONTA脩EZVALENZUELA VICENTE. Presidente: GREZZI GIUSEPPE. Vicepresid.: VALIA COTANDA ELISA. Datos registrales. T 10021, L7303, F 85, S 8, H V 10607, I/A 80 ( 8.08.19).
28 de Mayo de 2019Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 85, S 8, H V 10607, I/A 79(21.05.19).
04 de Enero de 2019Cambio de objeto social. la organizaci贸n y la prestaci贸n del servicio p煤blico de transporte urbano, colectivo, en superficie, depasajeros y sus equipajes, en Valencia C贸digo Nacional de Actividades Econ贸micas CNAE-2009: 4931. Transporte terrestre urbano depasajeros. Son actividades secundarias incluidas en el objeto socia. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 85, S 8, H V 10607, I/A 78(27.12.18).
25 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: FRESNEDA SANCHEZ MIGUEL ANGEL;ROMERO CIVERA CARLOS. Nombramientos.Apo.Man.Soli: CHINER Y PALMI JOSEP IGNASI;SALOM SEGUI ENRIQUE. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 84, S 8, H V10607, I/A 77 (18.06.18).
11 de Abril de 2018Modificaciones estatutarias. Art铆culo 1. La Sociedad se denomina Empresa Municipal de Transportes de Val茅ncia, S.A. (MedioPropio).. Datos registrales. T 10021, L 7303, F 84, S 8, H V 10607, I/A 76 ( 4.04.18).
27 de Marzo de 2018Modificaciones estatutarias. Art铆culo 4潞. Duraci贸n de la sociedad indefinida.. art铆culo 10.- respecto a la reuni贸n dentro del primersemestre de la Junta general. . Art铆culo 2. La Sociedad es medio propio del Ayuntamiento de Valencia. Fe de erratas: Ladenominaci贸n de la mercantil desde su constituci贸n es: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALENCIA SA. Datosregistrales. T 10021, L 7303, F 84, S 8, H V 10607, I/A 75 (20.03.18).