Actos BORME de Empresa Municipal Del Suelo De Jerez Sa
02 de Noviembre de 2015Cesi贸n global de activo y pasivo. Beneficiarias de la cesi贸n: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.Disoluci贸n. Cesi贸n global de activo y pasivo. Extinci贸n. Datos registrales. T 2054 , F 156, S 8, H CA 8050, I/A 36 (10.06.15).
17 de Junio de 2015Cesi贸n global de activo y pasivo. Beneficiarias de la cesi贸n: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA. Datosregistrales. T 2054 , F 156, S 8, H CA 8050, I/A 36 (10.06.15).
21 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ BENITEZ JOSE. Nombramientos. Consejero: ROSA PRADO MANUEL. Datos registrales.T 2054 , F 157, S 8, H CA 8050, I/A 34 (13.05.14).
Nombramientos. Consejero: JIMENEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2054 , F 157, S 8, H CA 8050, I/A 35(13.05.14).
19 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: GRISOL GIL JUAN PEDRO. Datos registrales. T 2054 , F 155, S 8, H CA 8050, I/A 33 (12.02.14).
03 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: PACHECO HERRERA PEDRO. Nombramientos. Consejero: LOPEZ BENITEZ JOSE. Datosregistrales. T 2054 , F 155, S 8, H CA 8050, I/A 32 (25.05.13).
21 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: ESPINOSA DE LA CALLE ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: MU脩OZ MARTIN AGUSTIN.Datos registrales. T 2054 , F 155, S 8, H CA 8050, I/A 31 (13.12.12).
03 de Agosto de 2012Modificaciones estatutarias. Modf. Esta. Adaptaci贸n. Otros conceptos: Adaptaci贸n del articulado a la reciente normativa vigentereguladora de la actividad de las sociedades de capital. Ampliacion del objeto social. La Empresa Municipal del Suelo de Jerez,S.A. tiene por objeto social el desarrollo urban铆stico, la actividad urbanizadora y la ejecuci贸n material delas determinaciones delplaneamiento territorial y urban铆stico en el t茅rmino municipal de Jerez de la Frontera, as铆 como la definici贸n, promoci贸n, par. Datosregistrales. T 891 , F 58, S 8, H CA 8050, I/A 30 (23.07.12).
27 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: NU脩EZ GOMEZ FERNANDO. Datos registrales. T 891 , F 57, S 8, H CA 8050, I/A 29 (16.02.12).
27 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Gerente: RUBIALES BONILLA SEBASTIAN. Datos registrales. T 891 , F 57, S 8, H CA 8050, I/A 27 (17.10.11).
Nombramientos. Gerente: NU脩EZ GOMEZ FERNANDO. Datos registrales. T 891 , F 57, S 8, H CA 8050, I/A 28 (17.10.11).
13 de Octubre de 2011Revocaciones. Apoderado: LEBRERO CONTRERAS FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: SALDA脩A MORENO ANTONIO.Datos registrales. T 891 , F 56, S 8, H CA 8050, I/A 26 (30.09.11).
15 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ MU脩OZ MARIA DEL PILAR;CRISOL GIL JUAN PEDRO;LEBRERO CONTRERASFRANCISCO;FERNANDEZ ORTEGA ANTONIO;DEL VALLE ROMANO JOAQUIN. Presidente: SANCHEZ MU脩OZ MARIA DELPILAR. Vicepresid.: LEBRERO CONTRERAS FRANCISCO. Consejero: BECERRA VILA AFRICA DEL ROSARIO;DURA DE PINOJAVIER MARIA LUCRECIO;SALDA脩A MORENO ANTONIO;RODRIGUEZ SANCHEZ ROSARIO. Nombramientos. Consejero:GARCIA PELAYO JURADO MARIA JOSE;RUA PATON MARIA JOSE;GRISOL GIL JUAN PEDRO;FLOR ACHUA LUIS;PACHECOHERRERA PEDRO;DEL VALLE ROMANO JOAQUIN. Presidente: GARCIA PELAYO JURADO MARIA JOSE. Vicepresid.: SALDA脩AMORENO ANTONIO. Consejero: SALDA脩A MORENO ANTONIO;ESPINOSA DE LA CALLE ENRIQUE;LUCRECIO DURA DEPINEDO JAVIER MARIA. Datos registrales. T 891 , F 56, S 8, H CA 8050, I/A 25 ( 1.09.11).