Actos BORME de Empresa Municipal Del Suelo Y La Vivienda De Mutxamel Sl
08 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: CUEVAS OLMO JOSE VICENTE. Datos registrales. T 3946 , F 117, S 8, H A 121822, I/A 19(30.10.23).
06 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: CA脩ADAS GALLARDO SEBASTIAN;BERMEJO CASTELLO JOSE ANTONIO. Presidente: CA脩ADASGALLARDO SEBASTIAN. Consejero: SOLA SUAREZ ANTONIO;PASTOR GOSALBEZ LLUIS MIQUEL;BERNABEU LLEDOFRANCISCO MANUEL;MARTINEZ RAMOS MARIA LORETO;SELLES LLORENS ALBERTO. Nombramientos. Consejero: GARCIABERENGUER RAFAEL;GOMIS DOMENECH VICENTE;RIERA ALBEROLA MARIA LORETO;FORNER SALA ERIBERTO;LOPEZTORRES VANESA;IBORRA NAVARRO BORJA;MARTINEZ VERDU CONCEPCION;LLORCA CONCA LARA. Presidente: GARCIABERENGUER RAFAEL. Reelecciones. Consejero: DA SILVA ORTEGA MIGUEL. Datos registrales. T 3946 , F 117, S 8, H A121822, I/A 18 (31.08.23).
06 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: IBORRA NAVARRO BORJA. Datos registrales. T 3946 , F 117, S 8, H A 121822, I/A 17 (28.06.21).
05 de Marzo de 2021Nombramientos. Auditor: AUDIMER AUDIT PARTNERS SL. Datos registrales. T 3460 , F 115, S 8, H A 121822, I/A 16 (25.02.21).
29 de Enero de 2021Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PEREZ ANTON FRANCISCO JOSE. Nombramientos. SecreNoConsj: CALDERON DUQUECRISTINA. Datos registrales. T 3460 , F 115, S 8, H A 121822, I/A 15 (21.01.21).
20 de Septiembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ RAMOS JOSE ANTONIO. Revocaciones. Apoderado: GUTIERREZ ALVARO JOSELUIS. Nombramientos. Apoderado: CUEVAS OLMO JOSE VICENTE. Consejero: MARTINEZ RAMOS MARIA LORETO;SELLESLLORENS ALBERTO;IBORRA NAVARRO BORJA;DA SILVA ORTEGA MIGUEL. Reelecciones. Consejero: CA脩ADAS GALLARDOSEBASTIAN;BERMEJO CASTELLO JOSE ANTONIO. Presidente: CA脩ADAS GALLARDO SEBASTIAN. Consejero: SOLA SUAREZANTONIO;PASTOR GOSALBEZ LLUIS MIQUEL;BERNABEU LLEDO FRANCISCO MANUEL Datos registrales. T 3460 , F 115, S 8,H A 121822, I/A 14 (13.09.19).
05 de Febrero de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 220.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 226.000,00 Euros. Datos registrales. T 3460 , F 115, S 8, HA 121822, I/A 13 (26.01.18).
16 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ RAMOS MARIA LORETO;IBORRA NAVARRO BORJA;PUIG CANTO ALEXIA. Datosregistrales. T 3460 , F 115, S 8, H A 121822, I/A 12 ( 5.10.17).
04 de Mayo de 2017Nombramientos. Auditor: MARTINEZ LOPEZ FERMIN. Datos registrales. T 3460 , F 114, S 8, H A 121822, I/A 11 (25.04.17).
09 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MIRALLES MARTINEZ SALVADOR;CUEVAS OLMO JOSE VICENTE. Nombramientos. Consejero:MARTINEZ RAMOS MARIA LORETO;IBORRA NAVARRO BORJA;SOLA SUAREZ ANTONIO;PASTOR GOSALBEZ LLUISMIQUEL;PUIG CANTO ALEXIA;MARTINEZ RAMOS JOSE ANTONIO. Reelecciones. Consejero: CA脩ADAS GALLARDOSEBASTIAN;BERMEJO CASTELLO JOSE ANTONIO. Presidente: CA脩ADAS GALLARDO SEBASTIAN. Consejero: BERNABEULLEDO FRANCISCO MANUEL. Datos registrales. T 3460 , F 114, S 8, H A 121822, I/A 10 (30.09.15).
08 de Enero de 2014Nombramientos. Auditor: LLUCH BOLUDA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3460 , F 114, S 8, H A 121822, I/A 9 (30.12.13).
05 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: CAPDEPON FERNANDEZ ESTEBAN. Nombramientos. Consejero: MIRALLES MARTINEZSALVADOR. Datos registrales. T 3460 , F 114, S 8, H A 121822, I/A 8 (27.03.13).
11 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: SANCHEZ PEREZ SALVADOR. Nombramientos. SecreNoConsj: PEREZ ANTON FRANCISCOJOSE. Datos registrales. T 3460 , F 114, S 8, H A 121822, I/A 7 (29.11.12).
05 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Apoderado: ABAD LOPEZ JUAN CARLOS. Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ ALVARO JOSE LUIS.Datos registrales. T 3460 , F 113, S 8, H A 121822, I/A 6 (26.11.12).
19 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: LLORENS AYELA ASUNCION;FORNER MARCO MARIA LORETO. Presidente: LLORENS AYELAASUNCION. Vicepresid.: CARRILLO VALERO ADRIAN. Consejero: POVEDA BROTONS ROSA. Vicepresid.: POVEDA BROTONSROSA. Nombramientos. Consejero: CA脩ADAS GALLARDO SEBASTIAN;BERMEJO CASTELLO JOSE ANTONIO;CUEVAS OLMOJOSE VICENTE. Presidente: CA脩ADAS GALLARDO SEBASTIAN. Datos registrales. T 3460 , F 113, S 8, H A 121822, I/A 5(10.07.12).
17 de Julio de 2012Nombramientos. Auditor: SIGNES SIGNES FRANCISCO ANGEL. Datos registrales. T 3460 , F 113, S 8, H A 121822, I/A 4 (5.07.12).
03 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: SALA PARTOR RAFAEL. Consejero: SALA PARTOR RAFAEL;CA脩ADAS GALLARDOSEBASTIAN;CUEVAS OLMO JOSE VICENTE. Nombramientos. Consejero: POVEDA BROTONS ROSA;BERNABEU LLEDOFRANCISCO MANUEL. Vicepresid.: POVEDA BROTONS ROSA. Modificaciones estatutarias. Art铆culo 17潞. Composici贸n ycondici贸n de los Consejeros. Datos registrales. T 3460 , F 113, S 8, H A 121822, I/A 3 (18.04.11).
26 de Abril de 2011Nombramientos. Vicepresid.: SALA PARTOR RAFAEL;CARRILLO VALERO ADRIAN. SecreNoConsj: SANCHEZ PEREZSALVADOR. Apoderado: ABAD LOPEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 3460 , F 113, S 8, H A 121822, I/A 2 (13.04.11).
28 de Junio de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 1.04.10. Objeto social: 1. La sociedad tendr谩 por objeto social la competencia municipal depromoci贸n y gesti贸n de viviendas dentro de la competencia general establecida en el Art.25/2.d de la ley de Bases de R茅gimen Local,de acuerdo con las directrices municipales y coordinadas por su Consejo de Administraci贸n. Igualment. Domicilio: AVDA CARLOSSOLER 46 - CASA CONSISTORIAL (MUTXAMEL). Capital: 6.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico:EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL. Nombramientos. Consejero: LLORENS AYELA ASUNCION;SALA PARTORRAFAEL;CARRILLO VALERO ADRIAN;FORNER MARCO MARIA LORETO;CA脩ADAS GALLARDO SEBASTIAN;CUEVAS OLMOJOSE VICENTE;CAPDEPON FERNANDEZ ESTEBAN. Presidente: LLORENS AYELA ASUNCION. Datos registrales. T 3460 , F110, S 8, H A 121822, I/A 1 (16.06.10).