Buscador CIF Logo

Actos BORME Emsur-eximpack Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Emsur-eximpack Sl

Actos BORME Emsur-eximpack Sl - B87539441

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Emsur-eximpack Sl con CIF B87539441

🔙 Perfil de Emsur-eximpack Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Emsur-eximpack Sl

26 de Octubre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: GALLARDO ALAMILLO ALBERTO. SecreNoConsj: FERNANDEZ-LOECHES MARTINEZ CARLOS.Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ LOECHES MARTINEZ CARLOS MANUEL. Secretario: FERNANDEZ LOECHESMARTINEZ CARLOS MANUEL. Datos registrales. T 35061 , F 179, S 8, H M 624467, I/A 26 (19.10.23).

31 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apoderado: GARCIA GARCIA MARIA DEL PILAR. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CRIADO SANZRAFAEL;COLMENAREJO ALONSO LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 35061 , F 178, S 8, H M 624467, I/A 25 (24.08.23).

08 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: VAS PIRIS TAMARA;FIGUEROA NAVARRO PILAR. Datos registrales. T 35061 , F 178, S 8, H M624467, I/A 24 ( 1.03.23).

09 de Enero de 2023
Revocaciones. Apoderado: GINES GOMEZ ALVARO. Datos registrales. T 35061 , F 178, S 8, H M 624467, I/A 23 (30.12.22).

03 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: CALVO ANGUIS MARIA GLORIA;GARCIA BELDA MARIA AUXILIADORA;MONTESINOSBALLESTEROS LUIS;LASSALETTA GONZALEZ JUAN MARIA;CRESPO MOTILLA SOLEDAD;VAS PIRIS TAMARA;GARCIAGARCIA MARIA DEL PILAR;ARGILA GARCIA PILAR;FIGUEROA NAVARRO PILAR;BADIOLA MUÑOZ MARIA ARANZAZU;GINESGOMEZ ALVARO. Datos registrales. T 35061 , F 176, S 8, H M 624467, I/A 22 (26.10.22).

26 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: VEGA DE CELIS ANA. Apo.Man.Soli: CALVO ANGUIS MARIA GLORIA;GARCIA BELDA MARIAAUXILIADORA;MONTESINOS BALLESTEROS LUIS;LASSALETTA GONZALEZ JUAN MARIA;RANZ HERRANZ RAUL;VAS PIRISTAMARA;FIGUEROA NAVARRO PILAR;BADIOLA MUÑOZ MARIA ARANZAZU;GINES GOMEZ ALVARO. Apo.Manc.: CRESPOMOTILLA SOLEDAD. Apo.Sol.: CRESPO MOTILLA SOLEDAD. Apoderado: ARGILA GARCIA PILAR. Datos registrales. T 35061 , F176, S 8, H M 624467, I/A 21 (19.10.22).

12 de Julio de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ RUIZ ANGELA. Nombramientos. Apoderado: ARGILA GARCIA PILAR. Datosregistrales. T 35061 , F 175, S 8, H M 624467, I/A 20 ( 5.07.22).

30 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ANGEL OGANDO JAVIER. Nombramientos. Apo.Manc.: CRESPO MOTILLA SOLEDAD. Apo.Sol.:CRESPO MOTILLA SOLEDAD. Datos registrales. T 35061 , F 174, S 8, H M 624467, I/A 19 (23.12.21).

23 de Julio de 2021
Revocaciones. Apoderado: GARCIA BELDA MARIA. Apo.Man.Soli: SANCHEZ RUIZ ANGELA;RANZ HERRANZ RAUL;VAS PIRISTAMARA;GARCIA DE LA FUENTE ROSA MARIA;FIGUEROA NAVARRO PILAR;BADIOLA MUÑOZ MARIA ARANZAZU;GINESGOMEZ ALVARO. Datos registrales. T 35061 , F 172, S 8, H M 624467, I/A 17 (16.07.21).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CALVO ANGUIS MARIA GLORIA;GARCIA BELDA MARIA AUXILIADORA;MONTESINOSBALLESTEROS LUIS;LASSALETTA GONZALEZ JUAN MARIA;RANZ HERRANZ RAUL;VAS PIRIS TAMARA;ANGEL OGANDOJAVIER;SANCHEZ RUIZ ANGELA;FIGUEROA NAVARRO PILAR;BADIOLA MUÑOZ MARIA ARANZAZU;GINES GOMEZ ALVARO.Datos registrales. T 35061 , F 172, S 8, H M 624467, I/A 18 (16.07.21).

22 de Julio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: VEGA DE CELIS ANA. Datos registrales. T 35061 , F 171, S 8, H M 624467, I/A 15 (15.07.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: OSMA HERNANDEZ JORGE. Datos registrales. T 35061 , F 171, S 8, H M 624467, I/A 16 (15.07.21).

06 de Octubre de 2020
Revocaciones. Apo.Sol.: BENEITEZ PANIZO BEATRIZ. Apo.Man.Soli: SANCHEZ RUIZ ANGELA;VAS PIRIS TAMARA;GARCIA DELA FUENTE ROSA MARIA;FIGUEROA NAVARRO PILAR;BADIOLA MUÑOZ MARIA ARANZAZU;GINES GOMEZ ALVARO. Datosregistrales. T 35061 , F 169, S 8, H M 624467, I/A 12 (29.09.20).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA BELDA MARIA. Apo.Man.Soli: SANCHEZ RUIZ ANGELA;RANZ HERRANZ RAUL;VAS PIRISTAMARA;GARCIA DE LA FUENTE ROSA MARIA;FIGUEROA NAVARRO PILAR;BADIOLA MUÑOZ MARIA ARANZAZU;GINESGOMEZ ALVARO. Datos registrales. T 35061 , F 169, S 8, H M 624467, I/A 13 (29.09.20).

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: LANTERO MORENO ANDRES. Nombramientos. Co.De.Ma.So: CARREÑO ALVAREZDANIEL;LANTERO MORENO ANDRES. Datos registrales. T 35061 , F 170, S 8, H M 624467, I/A 14 (29.09.20).

18 de Septiembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ-LOECHES MARTINEZ CARLOS;SEHK SAFWAN. Secretario: FERNANDEZ-LOECHESMARTINEZ CARLOS. Nombramientos. Consejero: CARREÑO ALVAREZ DANIEL;GALLARDO ALAMILLO ALBERTO.SecreNoConsj: FERNANDEZ-LOECHES MARTINEZ CARLOS. Datos registrales. T 35061 , F 169, S 8, H M 624467, I/A 11(11.09.19).

28 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: BENEITEZ PANIZO BEATRIZ. Apo.Man.Soli: SANCHEZ RUIZ ANGELA;VAS PIRIS TAMARA;GARCIADE LA FUENTE ROSA MARIA;FIGUEROA NAVARRO PILAR;BADIOLA MUÑOZ MARIA ARANZAZU;GINES GOMEZ ALVARO.Datos registrales. T 35061 , F 168, S 8, H M 624467, I/A 10 (21.03.19).

26 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ-LOECHES MARTINEZ CARLOS. Datos registrales. T 35061 , F 166, S 8, H M 624467, I/A8 (19.03.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO ANGUIS GLORIA. Datos registrales. T 35061 , F 167, S 8, H M 624467, I/A 9 (19.03.19).

28 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MONEREO VELASCO ANDRES. Consejero: HOLZBACHER VALERO ENRIC;OSETINSKII LEV.Presidente: OSETINSKII LEV. Revocaciones. Apo.Sol.: OSETINSKIY ALEXANDER. Nombramientos. Consejero: CALVO ANGUISGLORIA;FERNANDEZ-LOECHES MARTINEZ CARLOS;SEHK SAFWAN. Presidente: LANTERO MORENO ANDRES. Secretario:FERNANDEZ-LOECHES MARTINEZ CARLOS. Con.Delegado: LANTERO MORENO ANDRES. Modificaciones estatutarias. Semodifica los articulos 6,16º,19º,20º,23º,32º de los estatutos sociales,. Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ 157, 5º(MADRID). Datos registrales. T 35061 , F 163, S 8, H M 624467, I/A 7 (19.12.18).

20 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: VON WOLFFERSDORFF PHILIPP. Nombramientos. SecreNoConsj: MONEREO VELASCOANDRES. Datos registrales. T 35061 , F 163, S 8, H M 624467, I/A 6 (13.07.17).

30 de Enero de 2017
Nombramientos. Consejero: LANTERO MORENO ANDRES;HOLZBACHER VALERO ENRIC. Modificaciones estatutarias.MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 34720 , F 58, S 8, H M 624467, I/A 5 (20.01.17).

04 de Noviembre de 2016
Ampliación de capital. Capital: 250.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 253.000,00 Euros. Datos registrales. T 34720 , F 57, S 8, HM 624467, I/A 4 (27.10.16).

17 de Octubre de 2016
Otros conceptos: Se subsana el apellido del consejero nombrado y su N.I.E., siendo lo correcto, don Alexander Osetinskiy con N.I.E.Y-4670438-A. Datos registrales. T 34720 , F 57, S 8, H M 624467, I/A 3 ( 6.10.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información