Buscador CIF Logo

Actos BORME Emurtel Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Emurtel Sa

Actos BORME Emurtel Sa - A73012569

Tenemos registrados 72 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para Emurtel Sa con CIF A73012569

馃敊 Perfil de Emurtel Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de Emurtel Sa

28 de Noviembre de 2023
Fe de erratas: Al hacer el cambio de socio unico hubo un error al enviar el nuevo siendo el correcto: "Electronic Trafic SA". Datosregistrales. T 3546 , F 56, S 8, H MU 27611, I/A 105 ( 7.08.23).

14 de Agosto de 2023
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ELECTROMUR SA. Datos registrales. T 3546 , F 56, S 8, H MU 27611, I/A 105 (7.08.23).

17 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apoderado: JUAN LOPEZ CHILLON. Datos registrales. T 3546 , F 56, S 8, H MU 27611, I/A 104 ( 7.10.22).

05 de Julio de 2022
Revocaciones. Apoderado: CARLA CASANUEVA MURUAIS. Datos registrales. T 3546 , F 56, S 8, H MU 27611, I/A 103(28.06.22).

17 de Junio de 2022
Nombramientos. Apoderado: MARGARITA GARCIA SANCHEZ. Datos registrales. T 3546 , F 54, S 8, H MU 27611, I/A 102(10.06.22).

01 de Junio de 2022
Nombramientos. Apoderado: LORENZO ARCE SELMA. Datos registrales. T 3546 , F 54, S 8, H MU 27611, I/A 101 (25.05.22).

11 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LORENZO ARCE SELMA;ALBERTO SANZ RUIZ. Datos registrales. T 3546 , F 54, S 8, H MU 27611,I/A 100 ( 4.05.22).

01 de Abril de 2022
Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3546 , F 54, S 8, HMU 27611, I/A 99 (25.03.22).

25 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: GLORIA FERNANDEZ SENAC. Datos registrales. T 3304 , F 74, S 8, H MU 27611, I/A 98 (18.11.21).

16 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: ARIADNA GOMEZ DEL PULGAR FERRERO. Apo.Sol.: ARIADNA GOMEZ DEL PULGAR FERRERO.Datos registrales. T 3304 , F 74, S 8, H MU 27611, I/A 97 ( 9.11.21).

22 de Junio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: ANDREA PENEDO SIENES. Datos registrales. T 3304 , F 73, S 8, H MU 27611, I/A 95 (15.06.21).

Revocaciones. Apoderado: MIGUEL LOPEZ-MEDEL MARINA. Apo.Sol.: MIGUEL LOPEZ-MEDEL MARINA. Datos registrales. T3304 , F 74, S 8, H MU 27611, I/A 96 (15.06.21).

05 de Noviembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: GONZALO JUMILLA HERNANDEZ. Datos registrales. T 3304 , F 72, S 8, H MU 27611, I/A 94(28.10.20).

31 de Diciembre de 2019
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3304 , F 71, S 8, H MU 27611, I/A 92 (21.12.19).

30 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LORENZO ARCE SELMA;JESUS MANZANO DEL POZO. Datos registrales. T 3304 , F 71, S 8, HMU 27611, I/A 91 (23.10.19).

30 de Septiembre de 2019
Reelecciones. Adm. Unico: ELECTRONIC TRAFIC SA. Datos registrales. T 3304 , F 70, S 8, H MU 27611, I/A 90 (23.09.19).

26 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: CARLA CASANUEVA MURUAIS. Datos registrales. T 3304 , F 70, S 8, H MU 27611, I/A 88(19.11.18).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3304 , F 70, S 8, H MU 27611, I/A 89 (19.11.18).

14 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: CARLOS VERCET BOTET;ARIADNA GOMEZ DEL PULGAR FERRERO;MIGUEL LOPEZ-MEDELMARINA. Datos registrales. T 3304 , F 69, S 8, H MU 27611, I/A 87 ( 6.11.18).

06 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: SARA RODRIGUEZ SANCHEZ. Datos registrales. T 3304 , F 68, S 8, H MU 27611, I/A 86 (29.10.18).

08 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: JOSE LOPEZ IZQUIERDO. Datos registrales. T 3304 , F 67, S 8, H MU 27611, I/A 85 ( 1.10.18).

19 de Julio de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FRANCISCO MANUEL FERRANDEZ CAMARA. Apo.Manc.: ENRIQUE GUTIERREZ GARCIA.Datos registrales. T 3304 , F 66, S 8, H MU 27611, I/A 84 (11.07.18).

16 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: JOSE FERNANDO ALBIACH DOMINGO;CESAR GOMEZ PEIRO. Apo.Sol.: JOSE FERNANDOALBIACH DOMINGO;CESAR GOMEZ PEIRO. Datos registrales. T 3304 , F 66, S 8, H MU 27611, I/A 83 (10.07.18).

05 de Abril de 2018
Nombramientos. Apoderado: JESUS MANZANO DEL POZO. Datos registrales. T 3136 , F 152, S 8, H MU 27611, I/A 82(27.03.18).

18 de Enero de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3136 , F 152, S 8, H MU 27611, I/A 81 (12.01.18).

15 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: ALEJANDRA CASTILLO SIERRA. Datos registrales. T 3136 , F 152, S 8, H MU 27611, I/A 80 (7.12.17).

14 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: ARIADNA GOMEZ DEL PULGAR FERRERO. Datos registrales. T 3136 , F 151, S 8, H MU 27611, I/A78 ( 5.12.17).

Nombramientos. Apoderado: MIGUEL LOPEZ-MEDEL MARINA. Datos registrales. T 3136 , F 152, S 8, H MU 27611, I/A 79 (5.12.17).

27 de Julio de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LORENZO ARCE SELMA;ALBERTO SANZ RUIZ. Datos registrales. T 3136 , F 150, S 8, H MU27611, I/A 77 (20.07.17).

11 de Enero de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3136 , F 150, S 8, H MU 27611, I/A 76 ( 3.01.17).

23 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: ALEJANDRA CASTILLO SIERRA. Datos registrales. T 3036 , F 150, S 8, H MU 27611, I/A 75(16.09.16).

10 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apoderado: FRANCISCO MANUEL FERRANDEZ CAMARA. Datos registrales. T 3030 , F 48, S 8, H MU 27611, I/A73 ( 3.03.16).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ CAMARA. Datos registrales. T 3030 , F 48, S 8, H MU 27611,I/A 74 ( 3.03.16).

21 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: FRANCISCO MANUEL FERRANDEZ CAMARA;ENRIQUE GUTIERREZ GARCIA. Apo.Sol.:FRANCISCO MANUEL FERRANDEZ CAMARA. Datos registrales. T 3030 , F 48, S 8, H MU 27611, I/A 72 (14.12.15).

27 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3030 , F 48, S 8, H MU 27611, I/A 71 (20.11.15).

20 de Agosto de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: JOSE PISTON RIBERA;SALVADOR MATEO LOPEZ;ALBERTO GONZALEZ GALVEZ;JOSE ANTONIOLOPEZ ANDREU;FRANCISCO MANUEL FERRANDEZ CAMARA;JOSE MARIA RUBIO HERNANDEZ;ENRIQUE GUTIERREZGARCIA;PEDRO GALINDO MARIN;GINES RUIZ PEREZ;ISABEL ALCARAZ VIDAL;FRANCISCO MANUEL FERRANDEZCAMARA;PEDRO GALINDO MARIN;CARMEN GARCIA ANTON;ANTONIO LOPEZ HERRERO;JOSE MARTINEZHERNANDEZ;JOSE PISTON RIBERA;JERONIMO RODRIGUEZ MARIN;JOSE MARIA RUBIO HERNANDEZ;GINES RUIZPEREZ;JOSE FRANCISCO SANCHEZ MARIN. Apoderado: AURELIO ARUS RODRIGUEZ;JUAN AGUSTIN SANCHEZBERNAL;PEDRO GALINDO MARIN;GINES RUIZ PEREZ;MARIA TERESA MONTERO MORENO;ISABEL ALCARAZVIDAL;FRANCISCA SAEZ ROS;ESTHER PINEDA JIMENO;ANTONIO RAFAEL CAZORLA ABATO;GUILLERMO ESCRIBANOMORALES. Datos registrales. T 3030 , F 48, S 8, H MU 27611, I/A 70 (13.08.15).

07 de Julio de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: SALVADOR MATEO LOPEZ. Apoderado: SALVADOR MATEO LOPEZ. Datos registrales. T 3030 , F 48,S 8, H MU 27611, I/A 69 (30.06.15).

02 de Julio de 2015
Nombramientos. Apoderado: ANTONIO OCHOA FRAILE. Datos registrales. T 3030 , F 46, S 8, H MU 27611, I/A 66 (25.06.15).

Nombramientos. Apoderado: CARMEN MU脩OZ YA脩EZ. Datos registrales. T 3030 , F 47, S 8, H MU 27611, I/A 67 (25.06.15).

Revocaciones. Apoderado: JUAN CARLOS SANCHEZ ESPIN. Datos registrales. T 3030 , F 48, S 8, H MU 27611, I/A 68(25.06.15).

21 de Abril de 2015
Revocaciones. Apoderado: SARA PEREZ GONZALEZ. Datos registrales. T 3030 , F 46, S 8, H MU 27611, I/A 65 (14.04.15).

26 de Enero de 2015
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3030 , F 46, S 8, H MU 27611, I/A 64 (19.01.15).

30 de Octubre de 2014
Cambio de domicilio social. AVDA DEL PALMAR 530 - EL PALMAR (MURCIA). Datos registrales. T 3030 , F 46, S 8, H MU27611, I/A 63 (23.10.14).

12 de Septiembre de 2014
Fe de erratas: Rectificacion de la inscripcion 61& ultima publicada de otorgamiento de poderes a Don Jose Fernando AlbiachDomingo y Don Cesar Gomez Peiro, en el sentido de que es la inscripcion 62&.- Datos registrales. T 3030 , F 46, S 8, H MU 27611,I/A 62 . ( 9.07.14).

16 de Julio de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: JOSE FERNANDO ALBIACH DOMINGO;CESAR GOMEZ PEIRO. Datos registrales. T 3030 , F 46, S 8,H MU 27611, I/A 61 ( 9.07.14).

09 de Abril de 2014
Nombramientos. Apoderado: CARMEN GARCIA ANTON. Datos registrales. T 3001 , F 219, S 8, H MU 27611, I/A 58 ( 2.04.14).

Nombramientos. Apoderado: ANA ISABEL SORIANO LIDON. Datos registrales. T 3001 , F 219, S 8, H MU 27611, I/A 59 (2.04.14).

Nombramientos. Apoderado: JOSE LUIS LOSADA SANZ. Datos registrales. T 3001 , F 220, S 8, H MU 27611, I/A 60 ( 2.04.14).

Nombramientos. Apoderado: JOSE ANTONIO LOPEZ ANDREU. Datos registrales. T 3001 , F 221, S 8, H MU 27611, I/A 61 (2.04.14).

17 de Enero de 2014
Nombramientos. Apoderado: SARA RODRIGUEZ SANCHEZ. Datos registrales. T 2745 , F 60, S 8, H MU 27611, I/A 56 (10.01.14).

Nombramientos. Apoderado: SARA PEREZ GONZALEZ. Datos registrales. T 3001 , F 218, S 8, H MU 27611, I/A 57 (10.01.14).

07 de Enero de 2014
Revocaciones. Apoderado: RAFAEL MONTEAGUDO TORTOLA. Datos registrales. T 2745 , F 60, S 8, H MU 27611, I/A 55(27.12.13).

02 de Enero de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2745 , F 59, S 8, H MU 27611, I/A 54 (24.12.13).

03 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ CAMARA. Datos registrales. T 2745 , F 59, S 8, H MU27611, I/A 53 (26.11.13).

01 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE ANTONIO FERNANDEZ GARCIA. Presidente: JOSE ANTONIO FERNANDEZ GARCIA.Consejero: GINES HEREDIA OLMOS. Vicepresid.: GINES HEREDIA OLMOS. Consejero: JOSE MARIA RODRIGUEZ LATORRE.Cons.Del.Sol: GINES HEREDIA OLMOS;JOSE ANTONIO FERNANDEZ GARCIA. Consejero: CESAR GOMEZ PEIRO;ANTONIOJAVIER ORTIN LOPEZ. Revocaciones. SecreNoConsj: SARA RODRIGUEZ SANCHEZ. Nombramientos. Adm. Unico:ELECTRONIC TRAFIC SA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 2745 , F 58, S 8, H MU 27611, I/A 49 (24.09.13).

Revocaciones. Apoderado: JOSE MARIA RODRIGUEZ LATORRE;GINES HEREDIA OLMOS. Datos registrales. T 2745 , F 59, S 8,H MU 27611, I/A 50 (24.09.13).

Revocaciones. Apoderado: GINES HEREDIA OLMOS. Datos registrales. T 2745 , F 59, S 8, H MU 27611, I/A 51 (24.09.13).

Revocaciones. Apoderado: GINES HEREDIA OLMOS. Datos registrales. T 2745 , F 59, S 8, H MU 27611, I/A 52 (24.09.13).

15 de Julio de 2013
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: JOSE FERNANDO MURGA TOME. Nombramientos. SecreNoConsj: SARA RODRIGUEZSANCHEZ. Datos registrales. T 2745 , F 58, S 8, H MU 27611, I/A 48 ( 9.07.13).

08 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: JUAN ANTONIO MU脩OZ FERNANDEZ. Nombramientos. Consejero: ANTONIO JAVIER ORTINLOPEZ. Datos registrales. T 2745 , F 58, S 8, H MU 27611, I/A 47 ( 1.02.13).

23 de Noviembre de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2745 , F 58, S 8, H MU 27611, I/A 46 (15.11.12).

23 de Mayo de 2012
Otros conceptos: Alta sede electr贸nica: www.emurtel.es. Datos registrales. T 2745 , F 57, S 8, H MU 27611, I/A 42 (20.04.11).

05 de Enero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE HERNANDEZ ALVAREZ. Nombramientos. Consejero: CESAR GOMEZ PEIRO. Datosregistrales. T 2745 , F 58, S 8, H MU 27611, I/A 45 (27.12.11).

10 de Noviembre de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2745 , F 58, S 8, H MU 27611, I/A 44 (28.10.11).

28 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTONIO JESUS MARTINEZ CACHAFEIRO;GINES HEREDIA OLMOS;JOSE MARIA RODRIGUEZLATORRE;CESAR GOMEZ PEIRO;JUAN ANTONIO MU脩OZ FERNANDEZ. Presidente: ANTONIO JESUS MARTINEZCACHAFEIRO. Vicepresid.: GINES HEREDIA OLMOS. Cons.Del.Sol: GINES HEREDIA OLMOS;ANTONIO JESUS MARTINEZCACHAFEIRO. Secretario: JOSE FERNANDO MURGA TOME. Nombramientos. Consejero: JOSE ANTONIO FERNANDEZGARCIA. Presidente: JOSE ANTONIO FERNANDEZ GARCIA. Consejero: GINES HEREDIA OLMOS. Vicepresid.: GINES HEREDIAOLMOS. Consejero: JOSE MARIA RODRIGUEZ LATORRE;JOSE HERNANDEZ ALVAREZ;JUAN ANTONIO MU脩OZFERNANDEZSecreNoConsj: JOSE FERNANDO MURGA TOME. Cons.Del.Sol: GINES HEREDIA OLMOS;JOSE ANTONIOFERNANDEZ GARCIA. Datos registrales. T 2745 , F 57, S 8, H MU 27611, I/A 43 (20.09.11).

03 de Mayo de 2011
Cambio de objeto social. a) El estudio, concesi贸n, construcci贸n y explotaci贸n de toda clase de obras e instalaciones, ya seanp煤blicas o privadas, sin limitaci贸n alguna, ya sean 茅stas civiles, el茅ctricas, energ茅ticas, electr贸nicas, de telecomunicaciones,inform谩ticas, de gas, climatizaci贸n, calefacci贸n, maquinaria, segurida. Datos registrales. T 2745 , F 57, S 8, H MU 27611, I/A 42(20.04.11).

17 de Diciembre de 2010
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2745 , F 56, S 8, H MU 27611, I/A 41 ( 7.12.10).

11 de Mayo de 2010
Nombramientos. Apoderado: GUILLERMO ESCRIBANO MORALES. Datos registrales. T 2161 , F 199, S 8, H MU 27611, I/A 39(30.04.10).

Nombramientos. Apoderado: JUAN CARLOS SANCHEZ ESPIN. Datos registrales. T 2161 , F 200, S 8, H MU 27611, I/A 40(30.04.10).

03 de Mayo de 2010
Nombramientos. Apoderado: ANTONIO RAFAEL CAZORLA ABATO. Datos registrales. T 2161 , F 199, S 8, H MU 27611, I/A 38(22.04.10).

16 de Noviembre de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2161 , F 198, S 8, H MU 27611, I/A 36 ( 4.11.09).

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: GINES HEREDIA OLMOS;ANTONIO JESUS MARTINEZ CACHAFEIRO. Nombramientos.Cons.Del.Sol: GINES HEREDIA OLMOS;ANTONIO JESUS MARTINEZ CACHAFEIRO. Reelecciones. Secretario: JOSEFERNANDO MURGA TOME. Consejero: ANTONIO JESUS MARTINEZ CACHAFEIRO;GINES HEREDIA OLMOS;JOSE MARIARODRIGUEZ LATORRE;CESAR GOMEZ PEIRO;JUAN ANTONIO MU脩OZ FERNANDEZ. Presidente: ANTONIO JESUS MARTINEZCACHAFEIRO. Vicepresid.: GINES HEREDIA OLMOS. Datos registrales. T 2161 , F 198, S 8, H MU 27611, I/A 37 ( 4.11.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n