Actos BORME de Endalia Sl
24 de Octubre de 2023Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4522 , F 186, S 8, H Z 44578, I/A 22 (18.10.23).
21 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: LEGUINA MAZA PABLO. Datos registrales. T 4522 , F 186, S 8, H Z 44578, I/A 21 (14.09.23).
30 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: MOREIRA MORENO JAVIER. Datos registrales. T 4522 , F 184, S 8, H Z 44578, I/A 20 (23.11.22).
22 de Agosto de 2022Reelecciones. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 4522 , F 184, S 8, H Z 44578, I/A 19 (16.08.22).
30 de Mayo de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: CROWELL JOHN DAVID;CUNNINGHAM PHIL;CORTES FRANCO FERNANDO. Apoderado:LEGUINA MAZA PABLO. Datos registrales. T 4522 , F 181, S 8, H Z 44578, I/A 17 (23.05.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CROWELL JOHN DAVID;CUNNINGHMA PHIL;LEGUINA MAZA PABLO. Datos registrales. T 4522, F 181, S 8, H Z 44578, I/A 18 (23.05.22).
13 de Julio de 2021Fe de erratas: Rectificada la inscripci贸n 15陋 en cuanto al NIF del apoderado don PABLO LEGUINA MAZA, que en realidad es14.305.636-G. Datos registrales. T 4522 , F 181, S 8, H Z 44578, I/A 16 ( 6.07.21).
01 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: LEGUINA MAZA PABLO. Datos registrales. T 4522 , F 180, S 8, H Z 44578, I/A 15 (24.06.21).
27 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: CROWELL JOHN DAVID;CUNNINGHAM PHIL;CORTES FRANCO FERNANDO. Datos registrales.T 3546 , F 111, S 8, H Z 44578, I/A 14 (20.04.21).
15 de Febrero de 2021Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: FORAGOLA SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORTES FRANCO FERNANDO.Nombramientos. Adm. Unico: FORAGOLA SL. Modificaciones estatutarias. Art铆culo 7潞 bis. PRENDA DE LAS PARTICIPACIONESSOCIALES.- En caso de prenda de las participaciones sociales de la Sociedad, todos los derechos de socio corresponder谩n alpropietario de dichas participaciones. Sin embargo, los derechos de socio corresponder谩n al acreedor(es) pignoraticio(s) cuando.Datos registrales. T 3546 , F 110, S 8, H Z 44578, I/A 13 ( 8.02.21).
10 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apoderado: GUILLEN MARTINEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 3546 , F 110, S 8, H Z 44578, I/A 12 ( 3.11.20).
12 de Febrero de 2020Nombramientos. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 3546 , F 110, S 8, H Z 44578, I/A 11 ( 5.02.20).
27 de Febrero de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CORTES FRANCO FERNANDO;GUILLEN MARTINEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Unico:CORTES FRANCO FERNANDO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 3546 , F 109, S 8, H Z 44578, I/A 9 (20.02.18).
Nombramientos. Apoderado: GUILLEN MARTINEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 3546 , F 109, S 8, H Z 44578, I/A 10(20.02.18).
13 de Febrero de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.204,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.408,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:1.204,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.612,00 Euros. Datos registrales. T 3546 , F 108, S 8, H Z 44578, I/A 8 ( 3.02.17).
16 de Octubre de 2015Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 19潞.- CARACTER RETRIBUIDO DEL CARGO.- El cargo de Administrador ser谩 retribuido.La retribuci贸n no tendr谩 como base una participaci贸n en los beneficios y ser谩 la cantidad fija que para cada ejercicio acuerde la JuntaGeneral. No obstante, si adem谩s el administrador presta a la Sociedad. Datos registrales. T 3546 , F 108, S 8, H Z 44578, I/A 7 (7.10.15).
23 de Abril de 2015Cambio de domicilio social. AVDA MARIA ZAMBRANO 31 - WORLD TRADE CENTER,TORRE (ZARAGOZA). Datos registrales.T 3546 , F 108, S 8, H Z 44578, I/A 6 (15.04.15).
09 de Julio de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.408,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.612,00 Euros. Datos registrales. T 3546 , F 108, S8, H Z 44578, I/A 5 (28.06.13).
30 de Abril de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.010,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.020,00 Euros. Datos registrales. T 3546 , F 108, S 8, H Z44578, I/A 4 (19.04.13).
08 de Junio de 2010Cambio de domicilio social. CTRA DEL AEROPUERTO Km 4 2& - MODULOS 8, 9 Y 10 (ZARAGOZA). Datos registrales. T 3546 ,F 108, S 8, H Z 44578, I/A 3 (27.05.10).
20 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: GUILLEN RAMO LAURA;RAMO RAMIREZ MARIA ANGELES;ROMAY CARRACEDO ALFONSOJUAN;CORTES FRANCO FERNANDO. Secretario: CORTES FRANCO FERNANDO. Con.Delegado: CORTES FRANCOFERNANDO;GUILLEN MARTINEZ JOSE LUIS. Presidente: GUILLEN MARTINEZ JOSE LUIS. Consejero: GUILLEN MARTINEZ JOSELUIS. Nombramientos. Adm. Solid.: CORTES FRANCO FERNANDO;GUILLEN MARTINEZ JOSE LUIS. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T3546 , F 107, S 8, H Z 44578, I/A 2 (10.03.09).