Buscador CIF Logo

Actos BORME Energetica Tecnologica Castellana Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Energetica Tecnologica Castellana Sa

Actos BORME Energetica Tecnologica Castellana Sa - A09480716

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Burgos para Energetica Tecnologica Castellana Sa con CIF A09480716

🔙 Perfil de Energetica Tecnologica Castellana Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Burgos

Actos BORME de Energetica Tecnologica Castellana Sa

21 de Junio de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: PASCUAL COLINA PEDRO. Co.De.Ma.So: PASCUAL COLINA PEDRO. Vicepresid.: PASCUALCOLINA PEDRO. Nombramientos. Vicepresid.: GOMEZ CAYON RODRIGO. Datos registrales. T 769, L 560, F 14, S 8, H BU12354, I/A 20 (15.06.23).

12 de Agosto de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: SALDAÑA CASADO JOSE IGNACIO. Co.De.Ma.So: SALDAÑA CASADO JOSE IGNACIO.Nombramientos. Consejero: MIGUEL SEDANO CARMELO. Co.De.Ma.So: MIGUEL SEDANO CARMELO. Datos registrales. T 769,L 560, F 13, S 8, H BU 12354, I/A 18 ( 6.08.21).

06 de Febrero de 2020
Reelecciones. Co.De.Ma.So: ZALDO SAIZ MARTIN. Consejero: ZALDO SAIZ MARTIN. Presidente: ZALDO SAIZ MARTIN.Consejero: CASTRILLEJO BARBADILLO ALFREDO. Co.De.Ma.So: CASTRILLEJO BARBADILLO ALFREDO. Vicepresid.:CASTRILLEJO BARBADILLO ALFREDO. Datos registrales. T 758, L 549, F 139, S 8, H BU 12354, I/A 17 (31.01.20).

04 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: AUBA MARTINEZ ROMAN CARLOS;GARCIA HUERTA RAMON. Co.De.Ma.So: AUBA MARTINEZROMAN CARLOS;GARCIA HUERTA RAMON. Vicepresid.: AUBA MARTINEZ ROMAN CARLOS. Secretario: CASTRILLEJOBARBADILLO ALFREDO. Nombramientos. Vicepresid.: CASTRILLEJO BARBADILLO ALFREDO. Consejero: GARCIA AUSINALVARO;GOMEZ CAYON RODRIGO. Secretario: GARCIA AUSIN ALVARO. Co.De.Ma.So: GARCIA AUSIN ALVARO;GOMEZCAYON RODRIGO. Datos registrales. T 715, L 506, F 99, S 8, H BU 12354, I/A 16 (29.05.19).

02 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ ARNAIZ JUAN JOSE. Co.De.Ma.So: GOMEZ ARNAIZ JUAN JOSE. Nombramientos.Consejero: PASCUAL COLINA PEDRO. Co.De.Ma.So: PASCUAL COLINA PEDRO. Cambio de domicilio social. AVDACANTABRIA 41 - ENTREPLANTA, OFICINA 13 (BURGOS). Datos registrales. T 715, L 506, F 98, S 8, H BU 12354, I/A 15(26.06.18).

13 de Junio de 2017
Reducción de capital. Importe reducción: 2.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.200.000,00 Euros. Datos registrales. T 715, L506, F 97, S 8, H BU 12354, I/A 14 ( 7.06.17).

30 de Agosto de 2016
Nombramientos. Co.De.Ma.So: SALDAÑA CASADO JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 678, L 469, F 191, S 8, H BU 12354, I/A13 (24.08.16).

12 de Julio de 2016
Nombramientos. Consejero: SALDAÑA CASADO JOSE IGNACIO. Modificaciones estatutarias. Se modifican los artículos 8º y 9ºrelativos al régimen de transmisión participaciones; el artículo 11º sobre derecho preferente de la sociedad en caso de embargo deacciones; el artículo 14º sobre el sistema de convocatoria de la Junta, y se crea el artículo 14 Bis sobre comunicaciones.. Ampliaciondel objeto social. Explotación agrícola y de derechos de regadío, así como arrendamiento de fincas rústicas. Página web de lasociedad. Creación de la página web corporativa: www.etcsa.es. Datos registrales. T 678, L 469, F 190, S 8, H BU 12354, I/A 12 (6.07.16).

25 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ ALONSO JOSE ANTONIO;RUIZ MARTINEZ ISIDRO. Secretario: MARTINEZ ALONSOJOSE ANTONIO. Co.De.Ma.So: MARTINEZ ALONSO JOSE ANTONIO;RUIZ MARTINEZ ISIDRO. Presidente: AUBA MARTINEZROMAN CARLOS. Vicepresid.: GARCIA HUERTA RAMON. Nombramientos. Presidente: ZALDO SAIZ MARTIN. Vicepresid.: AUBAMARTINEZ ROMAN CARLOS. Secretario: CASTRILLEJO BARBADILLO ALFREDO. Otros conceptos: Los consejeros delegadosmancomunados nombrados en consejo de 23 de mayo de 2014 mantienen las mismas facultades cambiando su forma de actuación.Datos registrales. T 678, L 469, F 189, S 8, H BU 12354, I/A 11 (19.05.15).

10 de Julio de 2014
Reelecciones. Consejero: AUBA MARTINEZ ROMAN CARLOS;MARTINEZ ALONSO JOSE ANTONIO;GARCIA HUERTARAMON;GOMEZ ARNAIZ JUAN JOSE;CASTRILLEJO BARBADILLO ALFREDO. Secretario: MARTINEZ ALONSO JOSE ANTONIO.Co.De.Ma.So: AUBA MARTINEZ ROMAN CARLOS;MARTINEZ ALONSO JOSE ANTONIO;GARCIA HUERTA RAMON;GOMEZARNAIZ JUAN JOSE;CASTRILLEJO BARBADILLO ALFREDO. Consejero: RUIZ MARTINEZ ISIDRO. Presidente: AUBA MARTINEZROMAN CARLOS. Vicepresid.: GARCIA HUERTA RAMON. Co.De.Ma.So: RUIZ MARTINEZ ISIDRO;ZALDO SAIZ MARTIN.Consejero: ZALDO SAIZ MARTIN. Datos registrales. T 640, L 431, F 169, S 8, H BU 12354, I/A 10 ( 4.07.14).

10 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: AUBA MARTINEZ GABRIEL. Consejero: AUBA MARTINEZ GABRIEL. Nombramientos.Co.De.Ma.So: ZALDO SAIZ MARTIN. Consejero: ZALDO SAIZ MARTIN. Datos registrales. T 640, L 431, F 169, S 8, H BU 12354, I/A9 ( 4.06.13).

30 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Consejero: AUBA MARTINEZ GABRIEL. Datos registrales. T 579, L 370, F 85, S 8, H BU 12354, I/A 7 (21.11.11).

Nombramientos. Co.De.Ma.So: RUIZ MARTINEZ ISIDRO;AUBA MARTINEZ GABRIEL. Datos registrales. T 579, L 370, F 85, S 8,H BU 12354, I/A 8 (21.11.11).

05 de Octubre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA DEL PINO JUAN CARLOS. Presidente: GARCIA DEL PINO JUAN CARLOS. Co.De.Ma.So:GARCIA DEL PINO JUAN CARLOS;GONZALEZ HURTADO JOSE ELOY. Consejero: GONZALEZ HURTADO JOSE ELOY.Vicepresid.: AUBA MARTINEZ ROMAN CARLOS. Nombramientos. Consejero: RUIZ MARTINEZ ISIDRO. Presidente: AUBAMARTINEZ ROMAN CARLOS. Vicepresid.: GARCIA HUERTA RAMON. Datos registrales. T 579, L 370, F 84, S 8, H BU 12354, I/A 6(27.09.11).

19 de Octubre de 2010
Cambio de domicilio social. CTRA MADRID-IRUN Km 244 - CENTRO EUROPEO DE EMPRES (BURGOS). Datos registrales. T579, L 370, F 84, S 8, H BU 12354, I/A 5 ( 7.10.10).

15 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA DEL PINO JUAN CARLOS;AUBA MARTINEZ ROMAN CARLOS;MARTINEZ ALONSO JOSEANTONIO;GARCIA HUERTA RAMON;DOMINGO LAZARO AURELIO;ZALDO SAIZ MARTIN;GOMEZ ARNAIZ JUAN JOSE.Secretario: MARTINEZ ALONSO JOSE ANTONIO. Presidente: GARCIA DEL PINO JUAN CARLOS. Vicepresid.: AUBA MARTINEZROMAN CARLOS. Cons.Del.Man: GARCIA DEL PINO JUAN CARLOS;AUBA MARTINEZ ROMAN CARLOS;MARTINEZ ALONSOJOSE ANTONIO;GARCIA HUERTA RAMON;DOMINGO LAZARO AURELIO;ZALDO SAIZ MARTIN;GOMEZ ARNAIZ JUAN JOSE.Nombramientos. Consejero: GARCIA DEL PINO JUAN CARLOS;AUBA MARTINEZ ROMAN CARLOS;MARTINEZ ALONSO JOSEANTONIO;GARCIA HUERTA RAMON;GONZALEZ HURTADO JOSE ELOY;GOMEZ ARNAIZ JUAN JOSE;CASTRILLEJOBARBADILLO ALFREDO. Presidente: GARCIA DEL PINO JUAN CARLOS. Vicepresid.: AUBA MARTINEZ ROMAN CARLOS.Secretario: MARTINEZ ALONSO JOSE ANTONIO. Co.De.Ma.So: GARCIA DEL PINO JUAN CARLOS;AUBA MARTINEZ ROMANCARLOS;MARTINEZ ALONSO JOSE ANTONIO;GARCIA HUERTA RAMON;GONZALEZ HURTADO JOSE ELOY;GOMEZ ARNAIZJUAN JOSE;CASTRILLEJO BARBADILLO ALFREDO. Ampliación de capital. Suscrito: 2.716.000,00 Euros. Desembolsado:2.716.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.200.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 3.200.000,00 Euros. Modificacionesestatutarias. 8.- Modificación del régimen para la transmisión de las acciones.. Datos registrales. T 579, L 370, F 81, S 8, H BU

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información