Actos BORME de Energias Renovables De Gladiateur 18 Sl
14 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: SILVAN GONZALEZ MARIA;AURIA CABALLERO MARIA;CERVERA CORTEZO BEATRIZ;PALACIOSVICENTE ESTHER. Datos registrales. T 37976 , F 203, S 8, H M 676202, I/A 21 ( 6.11.23).
21 de Abril de 2023Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ TREJO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 37976 , F 203, S 8, H M 676202, I/A 20(14.04.23).
12 de Abril de 2023Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Datos registrales. T 37976 , F 203, S 8, H M 676202, I/A 19 (
10 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORTEZON SANTACLARA JULIO. Nombramientos. Adm. Unico: PEDROSA GOMEZ ENRIQUE.Datos registrales. T 37976 , F 202, S 8, H M 676202, I/A 18 ( 3.02.23).
23 de Enero de 2023Nombramientos. Apoderado: VILLORIA MARTINEZ MIGUEL. Datos registrales. T 37976 , F 202, S 8, H M 676202, I/A 17(16.01.23).
09 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: BRETON LESMES JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 37976 , F 201, S 8, H M 676202, I/A 15(30.11.22).
Nombramientos. Apoderado: BRETON LESMES JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 37976 , F 201, S 8, H M 676202, I/A 16(30.11.22).
05 de Octubre de 2022Otros conceptos: Se subsana el segundo apellido del apoderado nombrado, siendo el correcto DON JOSE IGNACIO BRETONLESMES. Datos registrales. T 37976 , F 201, S 8, H M 676202, I/A 14 (28.09.22).
22 de Agosto de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: AGUADO AGUADO JUSTO. Datos registrales. T 37976 , F 200, S 8, H M 676202, I/A 12 (12.08.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: BRETON LEDESMA JOSE IGNACIO;PEDROSA GOMEZ ENRIQUE;GOMEZ REDONDO SERGIOALFONSO;GARCIA ALAJARIN PAZ. Datos registrales. T 37976 , F 200, S 8, H M 676202, I/A 13 (12.08.22).
10 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: BENITO ZAMARRIEGO MARIANO;ROSAS RODRIGO ALMUDENA. Nombramientos. Apo.Manc.:GOMEZ REDONDO SERGIO ALONSO;DE LA LAMA ALCAIDE JOSE MANUEL. Datos registrales. T 37976 , F 174, S 8, H M676202, I/A 11 ( 3.02.22).
12 de Enero de 2022Cambio de domicilio social. C/ MENDEZ ALVARO 44 (MADRID). Datos registrales. T 37976 , F 174, S 8, H M 676202, I/A 10 (4.01.22).
06 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Datos registrales. T 37976 , F 174, S 8, H M 676202, I/A 9(29.06.21).
03 de Marzo de 2021Cambio de domicilio social. C/ GENERAL LACY 23 (MADRID). Datos registrales. T 37976 , F 174, S 8, H M 676202, I/A 8(24.02.21).
17 de Septiembre de 2020Nombramientos. Apoderado: MOURILLE CASTIÑEIRAS SANTOS;PEINADO BALDRICH IRENE;DE MIGUEL CALABIA CRISTINA.Datos registrales. T 37976 , F 172, S 8, H M 676202, I/A 6 (10.09.20).
Nombramientos. Apoderado: NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO;BENITO ZAMARRIEGO MARIANO;ROSASRODRIGO ALMUDENA;SEIJAS UZQUIZA IGNACIO. Datos registrales. T 37976 , F 172, S 8, H M 676202, I/A 7 (10.09.20).
22 de Mayo de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDO SOL SL. Representan: SAMPER RIVAS FERNANDO. Nombramientos. Adm. Unico:CORTEZON SANTACLARA JULIO. Datos registrales. T 37976 , F 171, S 8, H M 676202, I/A 3 (14.05.20).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: REPSOL RENOVABLES SL. Datos registrales. T 37976 , F 171, S8, H M 676202, I/A 4 (14.05.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO;GOMEZ-ACEBO MUNTAÑOLA PABLO. Datosregistrales. T 37976 , F 171, S 8, H M 676202, I/A 5 (14.05.20).
05 de Marzo de 2020Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: FERNANDO SOL SL. Datos registrales. T 37976 , F 171, S 8, H M
31 de Julio de 2018Constitución. Comienzo de operaciones: 10.07.18. Objeto social: LA PRODUCCION, VENTA , ALMACENAMIENTO YCOMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA Y TERMICA DE ORIGEN RENOVABLE. Domicilio: C/ JOSE ORTEGA Y GASSET,20, 2ª PLANTA. (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: NEARCO RENOVABLES SL.Nombramientos. Representan: SAMPER RIVAS FERNANDO. Adm. Unico: FERNANDO SOL SL. Datos registrales. T 37976 , F169, S 8, H M 676202, I/A 1 (23.07.18).