Buscador CIF Logo

Actos BORME Energias Renovables Del Duero Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Energias Renovables Del Duero Sl

Actos BORME Energias Renovables Del Duero Sl - B47569413

Tenemos registrados 38 Actos BORME del Registro Mercantil de Valladolid para Energias Renovables Del Duero Sl con CIF B47569413

馃敊 Perfil de Energias Renovables Del Duero Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Valladolid

Actos BORME de Energias Renovables Del Duero Sl

11 de Diciembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SAN EMETERIO SIMON JESUS;JIMENEZ GOMEZ LEONOR. Revocaciones. Apoderado:

28 de Agosto de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ASR WIND SL. Representan: TELLO GARCIA CARLOS. Nombramientos. Adm. Solid.: SANEMETERIO SIMON JESUS;JIMENEZ GOMEZ LEONOR. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador煤nico a Administradores solidarios. Cambio de domicilio social. AVDA DE AMERICA 38 (MADRID). Datos registrales. T 39351 , F76, S 8, H M 522675, I/A 31 (21.08.23).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANZ CARRASQUE脩O ALVARO;ANGOITIA GRIJALBA JUAN;SAALFELD REIS DIOGO;TELLOGARCIA CARLOS;ALCOCER RAMON LACA LETICIA;BALDERO SESMA DIANA;NU脩EZ BEJARANO ESTHER;VARELAULLASTRES SANTIAGO;SANZ CARRASQUE脩O ALVARO;ANGOITIA GRIJALBA JUAN;SAALFELD REIS DIOGO. Apoderado:ALCOCER RAMON LACA LETICIA;BALDERO SESMA DIANA;NU脩EZ BEJARANO ESTHER. Datos registrales. T 39351 , F 77, S 8,H M 522675, I/A 32 (21.08.23).

Nombramientos. Apoderado: MARCO NOAIN MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 39351 , F 77, S 8, H M 522675, I/A 33(21.08.23).

Nombramientos. Apoderado: ALBA VALMORISCO RICARDO;FERRERO CARBAJO JUAN. Datos registrales. T 39351 , F 77, S 8,H M 522675, I/A 34 (21.08.23).

Nombramientos. Apoderado: BARREDO LOPEZ JORGE;LEMA CIRONE GABRIEL;OLMO JIMENEZ ANDRES;MARCO NOAINMARIA CRISTINA;CANO CARO ANA. Datos registrales. T 39351 , F 78, S 8, H M 522675, I/A 35 (21.08.23).

23 de Agosto de 2023
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 39351 , F 76, S 8, H M 522675, I/A30 (16.08.23).

11 de Mayo de 2023
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 2潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Cambio de objeto social. a)la promoci贸n, dise帽o, construcci贸n, instalaci贸n, montaje, puesta en marcha, gesti贸n, explotaci贸n, operaci贸n, mantenimiento,conservaci贸n, guarda y custodia de instalaciones de producci贸n de energ铆a el茅ctrica, especialmente a partir de fuentes de energ铆as

02 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 39351 , F 75, S 8, H M 522675, I/A28 (25.11.22).

29 de Septiembre de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VARELA ULLASTRES SANTIAGO;SANZ CARRASQUE脩O ALVARO;ANGOITIA GRIJALBAJUAN;SAALFELD REIS DIOGO. Apoderado: ALCOCER RAMON LACA LETICIA;BALDERO SESMA DIANA;NU脩EZ BEJARANOESTHER. Datos registrales. T 39351 , F 74, S 8, H M 522675, I/A 27 (22.09.21).

07 de Septiembre de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 39351 , F 74, S 8, H M 522675, I/A26 (31.08.21).

18 de Febrero de 2020
Modificaciones estatutarias. 7. Modificaci贸n del texto del art铆culo 7 de los estatutos. . 9bis. Inclusi贸n de nuevo art铆culo 9 bis en losestatutos. . Datos registrales. T 39351 , F 73, S 8, H M 522675, I/A 25 (11.02.20).

03 de Febrero de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 39351 , F 73, S 8, H M 522675, I/A24 (28.01.20).

09 de Octubre de 2019
Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 60 - 3陋 (MADRID). Datos registrales. T 39351 , F 73, S 8, H M 522675,I/A 23 ( 2.10.19).

24 de Septiembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: OLEA AVILES JOSE MANUEL;RUIJS EDUARD. Nombramientos. Adm. Unico: ASR WIND SL.Representan: TELLO GARCIA CARLOS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunadosa Administrador 煤nico. Datos registrales. T 39351 , F 71, S 8, H M 522675, I/A 20 (17.09.19).

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ASR WIND SL. Datos registrales. T 39351 , F 71, S 8, H M 522675,I/A 21 (17.09.19).

Revocaciones. Apoderado: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS. Apo.Sol.: OLEA AVILES JOSE MANUEL;MARTIN-PE脩ATOECHEVARRIA TOMAS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANZ CARRASQUE脩O ALVARO;ANGOITIA GRIJALBA JUAN;SAALFELDREIS DIOGO;TELLO GARCIA CARLOS;ALCOCER RAMON LACA LETICIA;BALDERO SESMA DIANA;NU脩EZ BEJARANO ESTHER.Datos registrales. T 39351 , F 71, S 8, H M 522675, I/A 22 (17.09.19).

16 de Septiembre de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.828.983,50 Euros. Resultante Suscrito: 3.998.243,00 Euros. Datos registrales. T 29024, F 225, S 8, H M 522675, I/A 19 ( 9.09.19).

24 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: FIDLER EDUARD-BENJAMIN. Nombramientos. Adm. Mancom.: RUIJS EDUARD. Datosregistrales. T 29024 , F 225, S 8, H M 522675, I/A 18 (16.04.18).

22 de Marzo de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Revocaciones. Apo.Sol.: GALOBART SANCHEZMARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: OLEA AVILES JOSE MANUEL. Apo.Sol.: OLEAAVILES JOSE MANUEL;MARTIN-PE脩ATO ECHEVARRIA TOMAS. Datos registrales. T 29024 , F 223, S 8, H M 522675, I/A 17(14.03.18).

16 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BARRY JOHN RICHARD. Nombramientos. Adm. Mancom.: FIDLER EDUARD-BENJAMIN.Datos registrales. T 29024 , F 223, S 8, H M 522675, I/A 16 ( 8.05.17).

12 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 29024 , F 222, S 8, H M 522675,I/A 15 (30.11.16).

15 de Enero de 2016
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 29024 , F 222, S 8, H M 522675, I/A 14 ( 5.01.16).

22 de Enero de 2015
Reelecciones. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 29024 , F 222, S 8, H M 522675, I/A 13 (15.01.15).

20 de Noviembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Nombramientos. Adm. Mancom.: GALOBARTSANCHEZ MARCO JAIME. Datos registrales. T 29024 , F 222, S 8, H M 522675, I/A 12 (13.11.14).

19 de Mayo de 2014
Reelecciones. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 29024 , F 221, S 8, H M 522675, I/A 11 ( 8.05.14).

14 de Junio de 2013
Revocaciones. Apo.Manc.: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO;MORO GONZALEZ LUIS CARLOS. Apo.Sol.: SANCHEZ SEARAJOSE MARIA;CALERO BRAZALEZ JUAN JOSE;ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO;MORO GONZALEZ LUIS CARLOS. Datosregistrales. T 29024 , F 221, S 8, H M 522675, I/A 10 ( 7.06.13).

15 de Enero de 2013
Reelecciones. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 29024 , F 221, S 8, H M 522675, I/A 9 ( 4.01.13).

26 de Octubre de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Datos registrales. T 29024 , F198, S 8, H M 522675, I/A 8 (16.10.12).

15 de Octubre de 2012
Nombramientos. Apoderado: SANMARTIN DE CASTRO JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 29024 , F 197, S 8, H M 522675, I/A7 (27.09.12).

02 de Octubre de 2012
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: RENOVALIA RESERVE SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: MORO GONZALEZLUIS CARLOS;ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO;ASTALS COMA PEDRO. Presidente: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO.Consejero: BARRY JOHN RICHARD;RENOVALIA RESERVE SL. Secretario: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Representan:ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Nombramientos. Adm. Mancom.: BARRY JOHN RICHARD;ORTEGA MARTINEZ JUANDOMINGO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradoresmancomunados. Datos registrales. T 29024 , F 197, S 8, H M 522675, I/A 6 (20.09.12).

21 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ ORTEGA CARLOS;ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Nombramientos. Representan:ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Consejero: BARRY JOHN RICHARD;RENOVALIA RESERVE SL. Datos registrales. T29024 , F 196, S 8, H M 522675, I/A 5 ( 9.03.12).

15 de Septiembre de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 390.450,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.827.226,50 Euros. Escisi贸n parcial.Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: PROYECTO CAECIUS SL. Datos registrales. T 29024 , F 196, S 8, H M 522675, I/A 4(19.08.11).

17 de Agosto de 2011
Ceses/Dimisiones. Presidente: MORO GONZALEZ LUIS CARLOS. Vicepresid.: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO.Nombramientos. Presidente: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Datos registrales. T 29024 , F 193, S 8, H M 522675, I/A 3 (5.08.11).

16 de Agosto de 2011
Cambio de domicilio social. C/ MARIA DE MOLINA - N脩UMERO 54, 9& PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 29024 , F 193, S8, H M 522675, I/A 2 ( 3.08.11).

21 de Julio de 2011
Nombramientos. Consejero: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA;DIAZ ORTEGA CARLOS. Reelecciones. Auditor: BDOAUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 1199 , F 28, S 8, H VA 17909, I/A 10 (12.07.11).

01 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Secretario: CALERO BRAZALEZ JUAN JOSE. Nombramientos. Secretario: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR.Datos registrales. T 1199 , F 28, S 8, H VA 17909, I/A 9 (21.06.11).

16 de Abril de 2009
Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 1199 , F28, S 8, H VA 17909, I/A 8 ( 3.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n