Buscador CIF Logo

Actos BORME Energya Vm Gestion De Energia Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Energya Vm Gestion De Energia Sl

Actos BORME Energya Vm Gestion De Energia Sl - B83393066

Tenemos registrados 56 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Energya Vm Gestion De Energia Sl con CIF B83393066

🔙 Perfil de Energya Vm Gestion De Energia Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Energya Vm Gestion De Energia Sl

15 de Septiembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: BUENO GARCIA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 43761 , F 136, S 8, H M 311077, I/A 73 (8.09.23).

03 de Agosto de 2023
Nombramientos. Apo.Manc.: ROBLES ALVAREZ OSCAR;RUIZ FERNANDEZ NATALIA;GOMEZ BUENO ANTONIO-GABRIEL.Datos registrales. T 43761 , F 135, S 8, H M 311077, I/A 70 (27.07.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FRIAS GARCIA JESUS MARIA;DIAZ MARTIN MARIA DEL MAR;MARTINEZ HENAO RAQUEL.Datos registrales. T 43761 , F 136, S 8, H M 311077, I/A 71 (27.07.23).

Revocaciones. Apoderado: NOFUENTES CABALLERO MANUEL. Apo.Man.Soli: POLLOCK ANDREW TODD. Apo.Manc.: RUIZFERNANDEZ NATALIA;GARCIA LENDINES FRANCISCO JUAN;NOFUENTES CABALLERO MANUEL;GOMEZ BUENO ANTONIO-GABRIEL. Apo.Sol.: POLLOCK ANDREW TODD. Apo.Man.Soli: FRIAS GARCIA JESUS MARIA. Apo.Manc.: GOMEZ BUENOANTONIO-GABRIEL;POLLOCK ANDREW TODD. Datos registrales. T 43761 , F 136, S 8, H M 311077, I/A 72 (27.07.23).

18 de Abril de 2023
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 43761 , F 135, S 8, H M 311077, I/A 69 (11.04.23).

12 de Abril de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ MARIN GABRIEL. Apo.Sol.: MARTINEZ MARIN GABRIEL. Apo.Man.Soli: MARTINEZMARIN GABRIEL. Apo.Manc.: MARTINEZ MARIN GABRIEL. Datos registrales. T 43761 , F 135, S 8, H M 311077, I/A 68 ( 3.04.23).

17 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apoderado: ROBLES ALVAREZ OSCAR. Datos registrales. T 43761 , F 133, S 8, H M 311077, I/A 67 (10.02.23).

27 de Enero de 2023
Nombramientos. Apoderado: CANO ASUA IÑIGO. Datos registrales. T 43761 , F 132, S 8, H M 311077, I/A 66 (20.01.23).

17 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ-ALLER HORRILLO PABLO. Datos registrales. T 43761 , F 132, S 8, H M 311077, I/A65 ( 8.11.22).

20 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apoderado: HUIDOBRO ARREBA MARIA LUISA. Datos registrales. T 43761 , F 131, S 8, H M 311077, I/A 64(13.10.22).

24 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ-ALLER HORRILLO PABLO. Datos registrales. T 43761 , F 130, S 8, H M 311077, I/A63 (17.08.22).

22 de Agosto de 2022
Ceses/Dimisiones. Representan: HUIDOBRO ARREBA MARIA LUISA. Nombramientos. Representan: GARRIDO Y RUANOMANUEL. Datos registrales. T 18000 , F 218, S 8, H M 311077, I/A 62 (12.08.22).

10 de Junio de 2022
Nombramientos. Apoderado: RUIZ FERNANDEZ NATALIA. Datos registrales. T 18000 , F 218, S 8, H M 311077, I/A 61 ( 3.06.22).

30 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ BUENO ANTONIO-GABRIEL;GARCIA LENDINES FRANCISCO JUAN. Datos registrales. T18000 , F 218, S 8, H M 311077, I/A 60 (23.05.22).

15 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apoderado: BUENO GARCIA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 18000 , F 217, S 8, H M 311077, I/A 59 (8.03.22).

07 de Septiembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: OGUETA SAN VICENTE MARTIN. Datos registrales. T 18000 , F 217, S 8, H M 311077, I/A 58(31.08.21).

10 de Agosto de 2021
Cambio de objeto social. 1. La actividad principal consistirá en el ejercicio de la siguiente actividad: CNAE 3514 - Comercio deenergía eléctrica. 2. El objeto social consistirá en el ejercicio de las siguientes actividades: a) La adquisición, tenencia, gestión,administración y enajenación de acciones y participaciones... Datos registrales. T 18000 , F 216, S 8, H M 311077, I/A 56 ( 3.08.21).

Nombramientos. Apoderado: ALONSO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 18000 , F 217, S 8, H M 311077, I/A 57( 3.08.21).

06 de Julio de 2021
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EL NOMBRE DE LA CALLE COMO "FEDERICO MOMOPOU" SIENDO LO CORRECTO"FEDERICO MOMPOU". Datos registrales. T 18000 , F 216, S 8, H M 311077, I/A 55 (25.06.21).

02 de Julio de 2021
Cambio de domicilio social. C/ FEDERICO MOMOPOU 5 4º - EDIFICIO 1ª (MADRID). Datos registrales. T 18000 , F 216, S 8, HM 311077, I/A 55 (25.06.21).

10 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apoderado: VILLENA ADIEGO FERNANDO. Datos registrales. T 18000 , F 216, S 8, H M 311077, I/A 54 ( 3.03.21).

03 de Septiembre de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ VILLARES MONICA. Datos registrales. T 18000 , F 215, S 8, H M 311077, I/A 52(27.08.20).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MAESO PLAZA MANUEL RAFAEL. Datos registrales. T 18000 , F 216, S 8, H M 311077, I/A 53(27.08.20).

29 de Julio de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FRIAS GARCIA JESUS MARIA. Apo.Manc.: MARTINEZ MARIN GABRIEL;GOMEZ BUENOANTONIO-GABRIEL;POLLOCK ANDREW TODD. Datos registrales. T 18000 , F 215, S 8, H M 311077, I/A 51 (22.07.20).

29 de Mayo de 2020
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: ENERGYA VM GENERACION SL. Datos registrales. T 18000 , F214, S 8, H M 311077, I/A 49 (22.05.20).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 18000 , F 214, S 8, H M 311077, I/A 50 (22.05.20).

18 de Diciembre de 2019
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 18000 , F 214, S 8, H M 311077, I/A 48 (11.12.19).

17 de Octubre de 2019
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ BUENO ANTONIO-GABRIEL. Datos registrales. T 18000 , F 213, S 8, H M 311077, I/A 46(10.10.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ BUENO ANTONIO-GABRIEL. Datos registrales. T 18000 , F 213, S 8, H M 311077, I/A 47(10.10.19).

16 de Septiembre de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MAESO PLAZA MANUEL RAFAEL;MARTINEZ MARIN GABRIEL. Apo.Manc.: RUIZ FERNANDEZNATALIA;GARCIA LENDINES FRANCISCO JUAN;NOFUENTES CABALLERO MANUEL;GOMEZ BUENO ANTONIO-GABRIEL.Datos registrales. T 18000 , F 212, S 8, H M 311077, I/A 45 ( 9.09.19).

08 de Julio de 2019
Revocaciones. Apoderado: ESTANCONA DIEZ ALVARO;ESTANCONA DIEZ ALVARO. Apo.Man.Soli: SANCHEZ PEREAIGNACIO;ESTANCONA DIEZ ALVARO. Apoderado: ESTANCONA DIEZ ALVARO;SANCHEZ PEREA IGNACIO;CHIVITEFERNANDEZ SANTIAGO. Otros conceptos: Revocado el poder y facultades otorgado a Don Alvaro Estancona Diez, en escrituraautorizada por el notario de Madrid Don Martin Maria Recarte Casanova, el día 24 de febrero de 2016 con el número 481 de suprotocolo. Datos registrales. T 18000 , F 211, S 8, H M 311077, I/A 44 ( 1.07.19).

22 de Abril de 2019
Nombramientos. Apoderado: OGUETA SAN VICENTE MARTIN. Datos registrales. T 18000 , F 210, S 8, H M 311077, I/A 42(11.04.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: POLLOCK ANDREW TODD;MARTINEZ MARIN GABRIEL. Apo.Manc.: RUIZ FERNANDEZNATALIA;GARCIA LENDINES FRANCISCO JUAN;NOFUENTES CABALLERO MANUEL;GOMEZ BUENO ANTONIO-GABRIEL.Apo.Sol.: POLLOCK ANDREW TODD;MARTINEZ MARIN GABRIEL. Datos registrales. T 18000 , F 211, S 8, H M 311077, I/A 43(11.04.19).

10 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apoderado: VELASCO FERNANDEZ JORGE;CHIVITE FERNANDEZ SANTIAGO. Apo.Manc.: NUÑO DE LA MOTACARLOS;ESTEVES FERNANDES DA COSTA RODOLFO;LOPEZ CARRACELAS ANA. Apoderado: VELASCO FERNANDEZ JORGE.Datos registrales. T 18000 , F 210, S 8, H M 311077, I/A 41 ( 2.02.17).

24 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: CHIVITE FERNANDEZ SANTIAGO. Datos registrales. T 18000 , F 210, S 8, H M 311077, I/A 40(16.11.16).

16 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apoderado: ESTANCONA DIEZ ALVARO. Datos registrales. T 18000 , F 208, S 8, H M 311077, I/A 38 ( 7.03.16).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ PEREA IGNACIO. Datos registrales. T 18000 , F 209, S 8, H M 311077, I/A 39 ( 7.03.16).

18 de Enero de 2016
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 18000 , F 208, S 8, H M 311077, I/A 37 (11.01.16).

30 de Diciembre de 2015
Revocaciones. Apoderado: ORTIZ LOPEZ JOSE-IGNACIO. Datos registrales. T 18000 , F 208, S 8, H M 311077, I/A 36 (22.12.15).

11 de Febrero de 2015
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 18000 , F 208, S 8, H M 311077,I/A 35 ( 3.02.15).

28 de Febrero de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 18000 , F 207, S 8, H M 311077,I/A 34 (21.02.14).

27 de Enero de 2014
Revocaciones. Apoderado: GARCIA DIAZ PABON IGNACIO. Datos registrales. T 18000 , F 207, S 8, H M 311077, I/A 33(16.01.14).

04 de Octubre de 2013
Nombramientos. Apoderado: VELASCO FERNANDEZ JORGE;GOMEZ BUENO ANTONIO-GABRIEL. Datos registrales. T 18000 ,F 207, S 8, H M 311077, I/A 32 (27.09.13).

02 de Octubre de 2013
Nombramientos. Apoderado: ORTIZ LOPEZ JOSE-IGNACIO. Datos registrales. T 18000 , F 206, S 8, H M 311077, I/A 30(24.09.13).

Revocaciones. Apoderado: HUERTAS RUBIO ALFREDO;HUERTAS RUBIO ALFREDO;HUERTAS RUBIO ALFREDO;HUERTASRUBIO ALFREDO;HUERTAS RUBIO ALFREDO. Datos registrales. T 18000 , F 207, S 8, H M 311077, I/A 31 (24.09.13).

01 de Octubre de 2013
Nombramientos. Apoderado: CHIVITE FERNANDEZ SANTIAGO. Datos registrales. T 18000 , F 206, S 8, H M 311077, I/A 28(24.09.13).

Nombramientos. Apo.Manc.: NUÑO DE LA MOTA CARLOS;ESTEVES FERNANDES DA COSTA RODOLFO;LOPEZ CARRACELASANA. Datos registrales. T 18000 , F 206, S 8, H M 311077, I/A 29 (24.09.13).

09 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ PEREA IGNACIO;ESTANCONA DIEZ ALVARO. Datos registrales. T 18000 , F 205, S 8,H M 311077, I/A 27 ( 2.09.13).

13 de Junio de 2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 18000 , F 205, S 8, H M 311077,I/A 26 ( 5.06.13).

24 de Abril de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: VILLAR MIR ENERGIA SL. Representan: GONZALEZ-HABA GONZALEZ JOSE LUIS.Nombramientos. Representan: HUIDOBRO ARREBA MARIA LUISA. Adm. Unico: VILLAR MIR ENERGIA SL. Datos registrales. T18000 , F 204, S 8, H M 311077, I/A 25 (17.04.13).

20 de Marzo de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 18000 , F 204, S 8, H M 311077,I/A 24 ( 7.03.12).

17 de Febrero de 2012
Fe de erratas: SE PUBLICARON POR ERROR LAS INSCRIPCIONES 26&, 27& Y 28& SIENDO LAS CORRECTAS LA 21&, 22& Y23&. Datos registrales. T 18000 , F 201, S 8, H M 311077, I/A 21 (11.11.10).

18 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: NOFUENTES CABALLERO MANUEL. Datos registrales. T 18000 , F 204, S 8, H M 311077, I/A 28 (7.11.11).

08 de Noviembre de 2011
Cambio de objeto social. LA ADQUISICION, TENENCIA, GESTION, ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE ACCIONES YPARTICIPACIONES, TITULOS, VALORES ASI COM ODE INMUEBLES Y DE CUALQUIER OTRO ACTIVO INMOBILIARIO. Datosregistrales. T 18000 , F 203, S 8, H M 311077, I/A 27 (26.10.11).

23 de Noviembre de 2010
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: VILLAR MIR ENERGIA SL. Datos registrales. T 18000 , F 201, S 8,H M 311077, I/A 20 (11.11.10).

Nombramientos. Apoderado: HUIDOBRO ARREBA MARIA LUISA. Datos registrales. T 18000 , F 201, S 8, H M 311077, I/A 26(11.11.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información