Buscador CIF Logo

Actos BORME Enerhold Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Enerhold Sl

Actos BORME Enerhold Sl - B64377203

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Enerhold Sl con CIF B64377203

馃敊 Perfil de Enerhold Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Enerhold Sl

13 de Mayo de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 120,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.542.280,00 Euros. Datos registrales. T 44283 , F 64,S 8, H B 346583, I/A 24 ( 5.05.16).

04 de Marzo de 2016
Revocaciones. CONSEJERO: GIMENEZ FRADERA MERCEDES. PRESIDENTE: GIMENEZ FRADERA MERCEDES.Nombramientos. PRESIDENTE: CASANOVAS GIMENEZ JACINTO. Datos registrales. T 44283 , F 64, S 8, H B 346583, I/A 22(25.02.16).

Revocaciones. APODERAD.SOL: GIMENEZ FRADERA MERCEDES. Datos registrales. T 44283 , F 64, S 8, H B 346583, I/A 23(25.02.16).

25 de Mayo de 2015
Revocaciones. CONS.DEL.M/S: CASANOVAS GIMENEZ ALFONSO. Nombramientos. CONS.DEL.M/S: CASANOVAS GIMENEZALFONSO. Datos registrales. T 44283 , F 63, S 8, H B 346583, I/A 21 (15.05.15).

23 de Octubre de 2014
Revocaciones. CONS. DELEG.: CASANOVAS GIMENEZ ALFONSO. Nombramientos. CONS.DEL.M/S: CASANOVAS GIMENEZALFONSO. Datos registrales. T 44283 , F 63, S 8, H B 346583, I/A 20 (16.10.14).

20 de Agosto de 2014
Revocaciones. CONS. DELEG.: CASANOVAS GIMENEZ JACINTO. Nombramientos. CONS. DELEG.: CASANOVAS GIMENEZALFONSO. Datos registrales. T 44283 , F 62, S 8, H B 346583, I/A 19 (12.08.14).

15 de Abril de 2014
Nombramientos. APODERAD.SOL: GIMENEZ FRADERA MERCEDES. Datos registrales. T 40866 , F 40, S 8, H B 346583, I/A 17 (7.04.14).

Nombramientos. APOD.MANCOMU: CASANOVAS GIMENEZ MARIA ANTONIA;CASANOVAS GIMENEZ LOURDES;CASANOVASGIMENEZ VIRGINIA. Datos registrales. T 44283 , F 61, S 8, H B 346583, I/A 18 ( 7.04.14).

02 de Abril de 2014
Otros conceptos: PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD. Datos registrales. T 40866 , F 40, S 8, H B 346583, I/A 15 (25.03.14).

Revocaciones. CONS. DELEG.: GIMENEZ FRADERA MERCEDES. CONS.DEL.MAN: CASANOVAS GIMENEZJACINTO;CASANOVAS GIMENEZ MARIA ANTONIA;CASANOVAS GIMENEZ CARLOS;CASANOVAS GIMENEZALFONSO;CASANOVAS GIMENEZ LOURDES;CASANOVAS GIMENEZ VIRGINIA. Nombramientos. CONS. DELEG.:CASANOVAS GIMENEZ JACINTO. Modificaciones estatutarias. ART.20.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DEADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 40866 , F 40, S 8, H B 346583, I/A 16 (25.03.14).

25 de Julio de 2013
Cambio de domicilio social. CL TRAVESERA DE GRACIA Num.81 P.BJ (BARCELONA). Datos registrales. T 40866 , F 40, S 8, HB 346583, I/A 14 (17.07.13).

10 de Febrero de 2012
Revocaciones. ADM.UNICO: GIMENEZ FRADERA MERCEDES. Nombramientos. CONSEJERO: GIMENEZ FRADERAMERCEDES. PRESIDENTE: GIMENEZ FRADERA MERCEDES. CONS. DELEG.: GIMENEZ FRADERA MERCEDES. CONSEJERO:CASANOVAS GIMENEZ JACINTO. CONS.DEL.MAN: CASANOVAS GIMENEZ JACINTO. CONSEJERO: CASANOVAS GIMENEZMARIA ANTONIA. CONS.DEL.MAN: CASANOVAS GIMENEZ MARIA ANTONIA. CONSEJERO: CASANOVAS GIMENEZ CARLOS.CONS.DEL.MAN: CASANOVAS GIMENEZ CARLOS. CONSEJERO: CASANOVAS GIMENEZ ALFONSO. CONS.DEL.MAN:CASANOVAS GIMENEZ ALFONSO. CONSEJERO: CASANOVAS GIMENEZ LOURDES. CONS.DEL.MAN: CASANOVAS GIMENEZLOURDES. CONSEJERO: CASANOVAS GIMENEZ VIRGINIA. CONS.DEL.MAN: CASANOVAS GIMENEZ VIRGINIA. SECRETARIO:CASANOVAS GIMENEZ ALFONSO. Modificaciones estatutarias. ART.20.-SISTEMA RETRIBUTIVO MIEMBROS ORGANOS DEADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 40866 , F 39, S 8, H B 346583, I/A 13 (31.01.12).

20 de Junio de 2011
Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES EN FECHA 01/04/2011. Fusi贸n porabsorci贸n. Sociedades absorbidas: CARINA INVESTMENT SA. Datos registrales. T 40866 , F 35, S 8, H B 346583, I/A 12 (8.06.11).

27 de Julio de 2010
Cambio de domicilio social. CL TUSET NUM.5 PTA.5 LOCAL 2 (BARCELONA). Datos registrales. T 40866 , F 34, S 8, H B346583, I/A 11 (15.07.10).

12 de Mayo de 2009
Nombramientos. APODERADO: CASANOVAS GIMENEZ ALFONSO;CASANOVAS GIMENEZ JACINTO;CASANOVAS GIMENEZCARLOS. Datos registrales. T 40866 , F 32, S 8, H B 346583, I/A 9 (29.04.09).

Nombramientos. APODERADO: VILADEGUT BLANCH JAVIER;CASANOVAS GIMENEZ ALFONSO;CASANOVAS GIMENEZJACINTO;CASANOVAS GIMENEZ CARLOS. Datos registrales. T 40866 , F 33, S 8, H B 346583, I/A 10 (29.04.09).

04 de Mayo de 2009
Revocaciones. CONSEJERO: GIMENEZ FRADERA MERCEDES. PRESIDENTE: GIMENEZ FRADERA MERCEDES. CONSEJERO:CASANOVAS GIMENEZ JACINTO. CONS.DEL.MAN: CASANOVAS GIMENEZ JACINTO. CONSEJERO: CASANOVAS GIMENEZCARLOS. CONS.DEL.MAN: CASANOVAS GIMENEZ CARLOS. CONSEJERO: CASANOVAS GIMENEZ ALFONSO. SECRETARIO:CASANOVAS GIMENEZ ALFONSO. CONS.DEL.MAN: CASANOVAS GIMENEZ ALFONSO. Nombramientos. ADM.UNICO:GIMENEZ FRADERA MERCEDES. Modificaciones estatutarias. ART.20.- DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DELCARGO DEADMINISTRADOR. Datos registrales. T 40866 , F 31, S 8, H B 346583, I/A 8 (21.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n