Buscador CIF Logo

Actos BORME Entidad Idv Madrid Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Entidad Idv Madrid Sociedad Limitada

Actos BORME Entidad Idv Madrid Sociedad Limitada - B13514070

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Entidad Idv Madrid Sociedad Limitada con CIF B13514070

馃敊 Perfil de Entidad Idv Madrid Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Entidad Idv Madrid Sociedad Limitada

17 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ ADAME JORGE LUIS;PEREZ REDONDO MERCEDES;DE CABO LARA MARIAARANZAZU;ARISMENDI ABASTIDA RAQUEL;CARRASCO CARMONA MARCOS;RODRIGUEZ MOLINA MARIA JESUS;PACHONCORZO ALICIA. Apo.Manc.: AMIGO I CASAS JOAN;OCHOA RODRIGUEZ JAVIER;CAMBRON MELLADO JOSE LUIS. Datosregistrales. T 43499 , F 11, S 8, H M 504427, I/A 28 (10.03.23).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ADAME JORGE LUIS;PACHON CORZO ALICIA;DE CABO LARA MARIAARANZAZU;ARISMENDI ABASTIDA RAQUEL;BARRIOS BARBERO ROSA MARIA;APONTE DIAZ NURIA;RODRIGUEZ MOLINAMARIA JESUS;CARRASCO CARMONA MARCOS;CAMACHO MAILLO GISELA PALOMA;MARTINEZ COLADO IGNACIO;ARENAZAIBARRA YON AINGERU;DE UNAMUNO MORENO JULIAN JOSE;OCHOA RODRIGUEZ JAVIER;CAMBRON MELLADO JOSE LUIS.Datos registrales. T 43499 , F 11, S 8, H M 504427, I/A 29 (10.03.23).

Nombramientos. Apoderado: DE UNAMUNO MORENO JULIAN JOSE. Datos registrales. T 43499 , F 12, S 8, H M 504427, I/A 30(10.03.23).

03 de Febrero de 2023
Revocaciones. Auditor: BELLO & GIMENEZ AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: CROWE AUDITORES ESPA脩A SLP.Datos registrales. T 43499 , F 10, S 8, H M 504427, I/A 27 (27.01.23).

13 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apoderado: BASABE ARMIJO FERNANDO. Nombramientos. Apoderado: AMIGO CASAS JOAN. Datosregistrales. T 43499 , F 9, S 8, H M 504427, I/A 26 ( 5.10.22).

17 de Mayo de 2022
Ceses/Dimisiones. Representan: GARCIA BASCHWITZ CRISTINA. Nombramientos. Representan: RETES AGUADO AITOR.Datos registrales. T 43499 , F 9, S 8, H M 504427, I/A 25 ( 9.05.22).

10 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: ARGILES MALONDA EVA;CASALS NOGUER ANGELA;DIAZ GUTIERREZ VALENTIN. Datosregistrales. T 43499 , F 3, S 8, H M 504427, I/A 18 ( 3.05.22).

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ MEANA CALDERON JAIME FRANCISCO. Datos registrales. T 43499 , F 4, S 8, H M504427, I/A 19 ( 3.05.22).

Nombramientos. Apoderado: DIAZ ORPINELL ANNA. Datos registrales. T 43499 , F 5, S 8, H M 504427, I/A 20 ( 3.05.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: BLANCO LOPEZ FEDERICO;GOMEZ MEANA CALDERON JAIME FRANCISCO. Datos registrales. T43499 , F 6, S 8, H M 504427, I/A 21 ( 3.05.22).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ ADAME JORGE LUIS;PEREZ REDONDO MERCEDES;DE CABO LARA MARIAARANZAZU;ARISMENDI ABASTIDA RAQUEL;CARRASCO CARMONA MARCOS;RODRIGUEZ MOLINA MARIA JESUS;PACHONCORZO ALICIA. Apo.Manc.: AMIGO I CASAS JOAN;OCHOA RODRIGUEZ JAVIER;CAMBRON MELLADO JOSE LUIS. Datosregistrales. T 43499 , F 6, S 8, H M 504427, I/A 22 ( 3.05.22).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: RETES AGUADO AITOR;RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN;VERNET COMAS NOHEMI;ELVIRARODRIGO ALBERTO;URBANO LOPEZ JUAN CARLOS. Apo.Sol.: ARTERO ROYUELA RAQUEL;MARIN FERNANDEZNOELIA;ROMERO LAGE JOAQUIN;ORELLANA MANOSALBAS GUILLERMO JOSE. Apo.Man.Soli: ESTEBAN FRAILE CARLOS.Apoderado: BASABE ARMIJO FERNANDO. Datos registrales. T 43499 , F 7, S 8, H M 504427, I/A 23 ( 3.05.22).

Revocaciones. Apoderado: DELGADO VILLENA ANA ISABEL;DELGADO VILLENA GONZALO. Datos registrales. T 43499 , F 9, S

09 de Mayo de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: LARA PORRAS DIONISIO;DELGADO VILLENA ANA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico:APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL. Representan: GARCIA BASCHWITZ CRISTINA. Modificaciones estatutarias. DEROGACIONDEL ACTUAL TEXTO VIGENTE DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y APROBACION DE UN NUEVO TEXTO REFUNDIDO.. Art铆culode los estatutos: 2. Objeto social.-. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministrador 煤nico. Cambio de objeto social. : a) La explotaci贸n de estaciones de inspecci贸n t茅cnica de veh铆culos, situadas encualquier punto del territorio nacional e internacional; b) La realizaci贸n de auditor铆as t茅cnicas de toda clase de instalaciones dedicadasa la inspecci贸n t茅cnica o de control de veh铆culos, etc. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.grupoidv.com. Datos registrales. T 27991 , F 121, S 8, H M 504427, I/A 14 (29.04.22).

Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL. Datos registrales. T 43499 , F 2, S 8, H M504427, I/A 15 (29.04.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: AMIGO CASAS JOAN. Datos registrales. T 43499 , F 2, S 8, H M 504427, I/A 16 (29.04.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: CAMBRON MELLADO JOSE LUIS. Datos registrales. T 43499 , F 3, S 8, H M 504427, I/A 17 (29.04.22).

13 de Octubre de 2021
Revocaciones. Apoderado: NAVARRO SANCHEZ ANA MARIA. Datos registrales. T 27991 , F 120, S 8, H M 504427, I/A 13 (5.10.21).

04 de Agosto de 2021
Reelecciones. Auditor: BELLO & GIMENEZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 27991 , F 120, S 8, H M 504427, I/A 12(28.07.21).

12 de Septiembre de 2018
Reelecciones. Auditor: BELLO & GIMENEZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 27991 , F 120, S 8, H M 504427, I/A 11 (5.09.18).

28 de Agosto de 2017
Nombramientos. Apoderado: NAVARRO SANCHEZ ANA MARIA. Datos registrales. T 27991 , F 120, S 8, H M 504427, I/A 10(16.08.17).

23 de Julio de 2015
Nombramientos. Auditor: BELLO & GIMENEZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 27991 , F 119, S 8, H M 504427, I/A 9(13.07.15).

20 de Enero de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 120.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 280.000,00 Euros. Datos registrales. T 27991 , F 119, S 8,H M 504427, I/A 8 ( 9.01.14).

13 de Mayo de 2013
Ampliaci贸n de capital. Capital: 100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 160.000,00 Euros. Datos registrales. T 27991 , F 118, S 8,H M 504427, I/A 7 (30.04.13).

19 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: DELGADO MECO ANTONIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: DELGADO VILLENA ANAISABEL. Datos registrales. T 27991 , F 118, S 8, H M 504427, I/A 6 (11.03.13).

19 de Febrero de 2013
Nombramientos. Apoderado: DELGADO VILLENA GONZALO. Datos registrales. T 27991 , F 117, S 8, H M 504427, I/A 5(11.02.13).

08 de Noviembre de 2012
Cambio de domicilio social. POLIG EL CARRALERO - CALLE FRESA, 12 (MAJADAHONDA). Datos registrales. T 27991 , F 117,S 8, H M 504427, I/A 4 (24.10.12).

03 de Enero de 2012
Cambio de domicilio social. AVDA PAPA NEGRO 20 - PISO 104-105 (MADRID). Datos registrales. T 27991 , F 116, S 8, H M504427, I/A 3 (22.12.11).

26 de Agosto de 2010
Cambio de domicilio social. PLAZA DE CASTILLA, NUMERO 3, PISO 8潞, PUERTA E1 (MADRID). Datos registrales. T 27991 , F116, S 8, H M 504427, I/A 2 (17.08.10).

02 de Agosto de 2010
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 13.07.10. Objeto social: La Inspecci贸n T茅cnica de Veh铆culos en Estaciones de ITV enR茅gimen de autorizaci贸n o Concesi贸n Administrativa. Domicilio: C/ CAMPO, 58 - BAJO (TOMELLOSO). Capital: 60.000,00 Euros.Nombramientos. Adm. Mancom.: DELGADO MECO ANTONIO;LARA PORRAS DIONISIO. D. Gerente: DELGADO VILLENA ANAISABEL. Datos registrales. T 521 , F 159, S 8, H CR 20568, I/A 1 (20.07.10).

Nombramientos. Apoderado: DELGADO VILLENA ANA ISABEL. Datos registrales. T 521 , F 161, S 8, H CR 20568, I/A 2(20.07.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n