Actos BORME de Entidad Idv Madrid Sociedad Limitada
17 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ ADAME JORGE LUIS;PEREZ REDONDO MERCEDES;DE CABO LARA MARIAARANZAZU;ARISMENDI ABASTIDA RAQUEL;CARRASCO CARMONA MARCOS;RODRIGUEZ MOLINA MARIA JESUS;PACHONCORZO ALICIA. Apo.Manc.: AMIGO I CASAS JOAN;OCHOA RODRIGUEZ JAVIER;CAMBRON MELLADO JOSE LUIS. Datosregistrales. T 43499 , F 11, S 8, H M 504427, I/A 28 (10.03.23).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ADAME JORGE LUIS;PACHON CORZO ALICIA;DE CABO LARA MARIAARANZAZU;ARISMENDI ABASTIDA RAQUEL;BARRIOS BARBERO ROSA MARIA;APONTE DIAZ NURIA;RODRIGUEZ MOLINAMARIA JESUS;CARRASCO CARMONA MARCOS;CAMACHO MAILLO GISELA PALOMA;MARTINEZ COLADO IGNACIO;ARENAZAIBARRA YON AINGERU;DE UNAMUNO MORENO JULIAN JOSE;OCHOA RODRIGUEZ JAVIER;CAMBRON MELLADO JOSE LUIS.Datos registrales. T 43499 , F 11, S 8, H M 504427, I/A 29 (10.03.23).
Nombramientos. Apoderado: DE UNAMUNO MORENO JULIAN JOSE. Datos registrales. T 43499 , F 12, S 8, H M 504427, I/A 30(10.03.23).
03 de Febrero de 2023Revocaciones. Auditor: BELLO & GIMENEZ AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: CROWE AUDITORES ESPA脩A SLP.Datos registrales. T 43499 , F 10, S 8, H M 504427, I/A 27 (27.01.23).
13 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: BASABE ARMIJO FERNANDO. Nombramientos. Apoderado: AMIGO CASAS JOAN. Datosregistrales. T 43499 , F 9, S 8, H M 504427, I/A 26 ( 5.10.22).
17 de Mayo de 2022Ceses/Dimisiones. Representan: GARCIA BASCHWITZ CRISTINA. Nombramientos. Representan: RETES AGUADO AITOR.Datos registrales. T 43499 , F 9, S 8, H M 504427, I/A 25 ( 9.05.22).
10 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: ARGILES MALONDA EVA;CASALS NOGUER ANGELA;DIAZ GUTIERREZ VALENTIN. Datosregistrales. T 43499 , F 3, S 8, H M 504427, I/A 18 ( 3.05.22).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ MEANA CALDERON JAIME FRANCISCO. Datos registrales. T 43499 , F 4, S 8, H M504427, I/A 19 ( 3.05.22).
Nombramientos. Apoderado: DIAZ ORPINELL ANNA. Datos registrales. T 43499 , F 5, S 8, H M 504427, I/A 20 ( 3.05.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: BLANCO LOPEZ FEDERICO;GOMEZ MEANA CALDERON JAIME FRANCISCO. Datos registrales. T43499 , F 6, S 8, H M 504427, I/A 21 ( 3.05.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ ADAME JORGE LUIS;PEREZ REDONDO MERCEDES;DE CABO LARA MARIAARANZAZU;ARISMENDI ABASTIDA RAQUEL;CARRASCO CARMONA MARCOS;RODRIGUEZ MOLINA MARIA JESUS;PACHONCORZO ALICIA. Apo.Manc.: AMIGO I CASAS JOAN;OCHOA RODRIGUEZ JAVIER;CAMBRON MELLADO JOSE LUIS. Datosregistrales. T 43499 , F 6, S 8, H M 504427, I/A 22 ( 3.05.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RETES AGUADO AITOR;RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN;VERNET COMAS NOHEMI;ELVIRARODRIGO ALBERTO;URBANO LOPEZ JUAN CARLOS. Apo.Sol.: ARTERO ROYUELA RAQUEL;MARIN FERNANDEZNOELIA;ROMERO LAGE JOAQUIN;ORELLANA MANOSALBAS GUILLERMO JOSE. Apo.Man.Soli: ESTEBAN FRAILE CARLOS.Apoderado: BASABE ARMIJO FERNANDO. Datos registrales. T 43499 , F 7, S 8, H M 504427, I/A 23 ( 3.05.22).
Revocaciones. Apoderado: DELGADO VILLENA ANA ISABEL;DELGADO VILLENA GONZALO. Datos registrales. T 43499 , F 9, S
09 de Mayo de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: LARA PORRAS DIONISIO;DELGADO VILLENA ANA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico:APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL. Representan: GARCIA BASCHWITZ CRISTINA. Modificaciones estatutarias. DEROGACIONDEL ACTUAL TEXTO VIGENTE DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y APROBACION DE UN NUEVO TEXTO REFUNDIDO.. Art铆culode los estatutos: 2. Objeto social.-. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministrador 煤nico. Cambio de objeto social. : a) La explotaci贸n de estaciones de inspecci贸n t茅cnica de veh铆culos, situadas encualquier punto del territorio nacional e internacional; b) La realizaci贸n de auditor铆as t茅cnicas de toda clase de instalaciones dedicadasa la inspecci贸n t茅cnica o de control de veh铆culos, etc. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.grupoidv.com. Datos registrales. T 27991 , F 121, S 8, H M 504427, I/A 14 (29.04.22).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL. Datos registrales. T 43499 , F 2, S 8, H M504427, I/A 15 (29.04.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: AMIGO CASAS JOAN. Datos registrales. T 43499 , F 2, S 8, H M 504427, I/A 16 (29.04.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: CAMBRON MELLADO JOSE LUIS. Datos registrales. T 43499 , F 3, S 8, H M 504427, I/A 17 (29.04.22).
13 de Octubre de 2021Revocaciones. Apoderado: NAVARRO SANCHEZ ANA MARIA. Datos registrales. T 27991 , F 120, S 8, H M 504427, I/A 13 (5.10.21).
04 de Agosto de 2021Reelecciones. Auditor: BELLO & GIMENEZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 27991 , F 120, S 8, H M 504427, I/A 12(28.07.21).
12 de Septiembre de 2018Reelecciones. Auditor: BELLO & GIMENEZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 27991 , F 120, S 8, H M 504427, I/A 11 (5.09.18).
28 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: NAVARRO SANCHEZ ANA MARIA. Datos registrales. T 27991 , F 120, S 8, H M 504427, I/A 10(16.08.17).
23 de Julio de 2015Nombramientos. Auditor: BELLO & GIMENEZ AUDITORES SLP. Datos registrales. T 27991 , F 119, S 8, H M 504427, I/A 9(13.07.15).
20 de Enero de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 120.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 280.000,00 Euros. Datos registrales. T 27991 , F 119, S 8,H M 504427, I/A 8 ( 9.01.14).
13 de Mayo de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 160.000,00 Euros. Datos registrales. T 27991 , F 118, S 8,H M 504427, I/A 7 (30.04.13).
19 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: DELGADO MECO ANTONIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: DELGADO VILLENA ANAISABEL. Datos registrales. T 27991 , F 118, S 8, H M 504427, I/A 6 (11.03.13).
19 de Febrero de 2013Nombramientos. Apoderado: DELGADO VILLENA GONZALO. Datos registrales. T 27991 , F 117, S 8, H M 504427, I/A 5(11.02.13).
08 de Noviembre de 2012Cambio de domicilio social. POLIG EL CARRALERO - CALLE FRESA, 12 (MAJADAHONDA). Datos registrales. T 27991 , F 117,S 8, H M 504427, I/A 4 (24.10.12).
03 de Enero de 2012Cambio de domicilio social. AVDA PAPA NEGRO 20 - PISO 104-105 (MADRID). Datos registrales. T 27991 , F 116, S 8, H M504427, I/A 3 (22.12.11).
26 de Agosto de 2010Cambio de domicilio social. PLAZA DE CASTILLA, NUMERO 3, PISO 8潞, PUERTA E1 (MADRID). Datos registrales. T 27991 , F116, S 8, H M 504427, I/A 2 (17.08.10).
02 de Agosto de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 13.07.10. Objeto social: La Inspecci贸n T茅cnica de Veh铆culos en Estaciones de ITV enR茅gimen de autorizaci贸n o Concesi贸n Administrativa. Domicilio: C/ CAMPO, 58 - BAJO (TOMELLOSO). Capital: 60.000,00 Euros.Nombramientos. Adm. Mancom.: DELGADO MECO ANTONIO;LARA PORRAS DIONISIO. D. Gerente: DELGADO VILLENA ANAISABEL. Datos registrales. T 521 , F 159, S 8, H CR 20568, I/A 1 (20.07.10).
Nombramientos. Apoderado: DELGADO VILLENA ANA ISABEL. Datos registrales. T 521 , F 161, S 8, H CR 20568, I/A 2(20.07.10).