Actos BORME de Eolica Del Guadiana Sl
10 de Agosto de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: ECHANOVE SANCHEZ FERNANDO. Apo.Manc.: TURU I TARRE ANNA. Datos registrales. T 26248 , F208, S 8, H M 472985, I/A 38 ( 3.08.23).
06 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: EJEA LAFUENTE NOELIA. Apoderado: PLAZAS REQUENA JAVIER. Nombramientos. Apo.Manc.:REYES ASENSIO JUAN JOSE. Datos registrales. T 26248 , F 207, S 8, H M 472985, I/A 37 (27.02.23).
14 de Febrero de 2023Revocaciones. Apoderado: GARCIA IGLESIAS EDUARDO. Apo.Sol.: MILLAN RESA MIRIAN. Nombramientos. Apo.Manc.:TABOADA DIAZ-RINCON YOLANDA;TURU I TARRE ANNA;SOLIS ALVAREZ SANDRA;EJEA LAFUENTE NOELIA;LOPEZ ROMANCARMEN MARINA. Apo.Sol.: RUBIO GARCIA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 26248 , F 205, S 8, H M 472985, I/A 36 (7.02.23).
02 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: ECHANOVE SANCHEZ FERNANDO;MARTIN MARTINEZ JORGE;CACERES SALAZAR PEDRO;BELDAMARIN RAFAEL. Datos registrales. T 26248 , F 204, S 8, H M 472985, I/A 35 (25.10.22).
24 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26248 , F 204, S 8, H M 472985, I/A 34 (17.10.22).
27 de Junio de 2022Revocaciones. Apoderado: RUS OZAEZ ANTONIO. Datos registrales. T 26248 , F 204, S 8, H M 472985, I/A 33 (20.06.22).
22 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ FERNANDEZ IRENE. Datos registrales. T 26248 , F 203, S 8, H M 472985, I/A 32(15.11.21).
19 de Febrero de 2021Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 26248 , F 202, S 8, H M 472985, I/A 31 (12.02.21).
05 de Enero de 2021Nombramientos. Apoderado: AGUADO MONTALVO DAVID. Datos registrales. T 26248 , F 200, S 8, H M 472985, I/A 29(28.12.20).
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO;PEREZ DE LEMA DE LA MATA ALVARO;DEL VALLE CALVOMARIA DOLORES. Apo.Sol.: LOPEZ ROMAN CARMEN MARINA;DEL VALLE CALVO MARIA DOLORES;RUS OZAEZANTONIO;GARCIA IGLESIAS EDUARDO;FERNANDEZ PEREZ LUIS ALBERTO;GONZALEZ HIERRO FRANCISCO;PEREZ DE
16 de Julio de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26248 , F 199, S 8, H M 472985, I/A 28 (10.07.19).
09 de Julio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: BARDAJI GARCIA LUIS;MILLAN RESA MIRIAN. Datos registrales. T 26248 , F 199, S 8, H M 472985,I/A 27 ( 3.07.19).
08 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS. Nombramientos. Representan: PEREZ DE LEMA DE LAMATA ALVARO. Datos registrales. T 26248 , F 199, S 8, H M 472985, I/A 26 (28.12.18).
08 de Octubre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ ROMAN CARMEN MARINA;DEL VALLE CALVO MARIA DOLORES;RUS OZAEZANTONIO;GARCIA IGLESIAS EDUARDO;FERNANDEZ PEREZ LUIS ALBERTO;GONZALEZ HIERRO FRANCISCO;PEREZ DELEMA DE LA MATA ALVARO;SALVADOR DE SANCHO RAUL. Datos registrales. T 26248 , F 197, S 8, H M 472985, I/A 25 (1.10.18).
25 de Agosto de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26248 , F 197, S 8, H M 472985, I/A 24 (16.08.17).
21 de Diciembre de 2016Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26248 , F 197, S 8, H M 472985, I/A 23 ( 9.12.16).
12 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO;PEREZ DE LEMA DE LA MATA ALVARO;DEL VALLE CALVOMARIA DOLORES. Datos registrales. T 26248 , F 196, S 8, H M 472985, I/A 22 ( 1.12.16).
25 de Junio de 2015Cambio de domicilio social. AVDA DE BURGOS 16 D (MADRID). Datos registrales. T 26248 , F 195, S 8, H M 472985, I/A 21(18.06.15).
04 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ENERGIA Y RECURSOS AMBIENTALES SA. Representan: REIN ROJO LUIS. Nombramientos.Adm. Unico: SAETA YIELD SA. Representan: MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS. Datos registrales. T 26248 , F 195, S 8, H M472985, I/A 20 (23.02.15).
16 de Enero de 2015Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SAETA YIELD SA. Datos registrales. T 26248 , F 195, S 8, H M 472985, I/A 19 (7.01.15).
19 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Representan: JIMENEZ SERRANO RAMON. Nombramientos. Representan: REIN ROJO LUIS. Datosregistrales. T 26248 , F 195, S 8, H M 472985, I/A 18 (12.12.14).
14 de Marzo de 2014Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26248 , F 195, S 8, H M 472985, I/A 17 ( 7.03.14).
07 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apoderado: PEREZ LORENZO JAVIER. Datos registrales. T 26248 , F 194, S 8, H M 472985, I/A 16 (25.10.12).
16 de Julio de 2012Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ GONZALEZ ALBO JUAN MANUEL;GOMEZ ZAMORA ANTONIO. Datos registrales. T 26248 ,F 194, S 8, H M 472985, I/A 15 ( 5.07.12).
06 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Representan: GOMEZ ZAMORA ANTONIO. Nombramientos. Representan: JIMENEZ SERRANO RAMON.Datos registrales. T 26248 , F 194, S 8, H M 472985, I/A 14 (22.06.12).
24 de Enero de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.772.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.280.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: Art铆culo 5潞. Capital Social. Datos registrales. T 26248 , F 193, S 8, H M 472985, I/A 13 (12.01.12).
26 de Septiembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.688.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.508.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.- 5. Capital.-. Datos registrales. T 26248 , F 193, S 8, H M 472985, I/A 12 (13.09.11).
16 de Marzo de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.688.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.615.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 26248 , F 192, S 8, H M 472985, I/A 10 ( 3.03.11).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.205.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.820.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 26248 , F 192, S 8, H M 472985, I/A 11 ( 3.03.11).
02 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Representan: GARCIA ARENAL RODRIGUEZ PABLO. Nombramientos. Representan: GOMEZ ZAMORAANTONIO. Datos registrales. T 26248 , F 192, S 8, H M 472985, I/A 9 (18.02.11).
25 de Noviembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.827.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.927.000,00 Euros. Datos registrales. T 26248 , F 191, S8, H M 472985, I/A 8 (16.11.10).
19 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apoderado: IGLESIA LACHICA LEOPOLDO. Datos registrales. T 26248 , F 191, S 8, H M 472985, I/A 7 (10.11.10).
22 de Junio de 2009Nombramientos. Apoderado: GOMEZ ZAMORA ANTONIO. Datos registrales. T 26248 , F 190, S 8, H M 472985, I/A 6 (10.06.09).
25 de Mayo de 2009Nombramientos. Apoderado: PEREZ LORENZO JAVIER. Datos registrales. T 26248 , F 186, S 8, H M 472985, I/A 3 (13.05.09).
Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ GONZALEZ ALBO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 26248 , F 188, S 8, H M 472985, I/A4 (13.05.09).
Nombramientos. Apoderado: IGLESIA LACHICA LEOPOLDO. Datos registrales. T 26248 , F 189, S 8, H M 472985, I/A 5(13.05.09).
16 de Abril de 2009Cambio de domicilio social. C/ CARDENAL MARCELO SPINOLA 10 (MADRID). Datos registrales. T 26248 , F 186, S 8, H M472985, I/A 2 ( 2.04.09).
16 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MARIN ALMODOVAR ANTONIO;FERNANDEZ TRESGALLO GUSTAVO. Nombramientos.Adm. Unico: ENERGIA Y RECURSOS AMBIENTALES SA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores mancomunados a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 684 , F 143, S 8, H H 11432,H , I/ 5 .(24.02.09).
16 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: HORCHE TRUEBA JOSE IGNACIO;GRANELL GASCO JUAN JOSE;MARIN ALMODOVARANTONIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: MARIN ALMODOVAR ANTONIO;FERNANDEZ TRESGALLO GUSTAVO.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administradores mancomunados.Datos registrales. T 684 , F 143, S 8, H H 11432,H , I/ 4 .(13.01.09).