Buscador CIF Logo

Actos BORME Epsilon Communication Solutions Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Epsilon Communication Solutions Sl

Actos BORME Epsilon Communication Solutions Sl - B86920550

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Epsilon Communication Solutions Sl con CIF B86920550

馃敊 Perfil de Epsilon Communication Solutions Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Epsilon Communication Solutions Sl

22 de Diciembre de 2021
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 36314 , F 65, S 8, H M 572578, I/A 23 (15.12.21).

03 de Junio de 2021
Revocaciones. Apoderado: ARNALDO ALBUJAR JOSE ANTONIO;SANCHEZ HIJANO MARIA DE LAS MERCEDES. Datosregistrales. T 36314 , F 64, S 8, H M 572578, I/A 22 (27.05.21).

17 de Febrero de 2021
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CERRILLO ARIAS PATRICIA. Revocaciones. Apo.Sol.: CERRILLO ARIAS PATRICIA.Nombramientos. Secretario: ORPEZ UCEDA JOSE LUIS. Apoderado: VIADA FRAILE DAMERIS. Datos registrales. T 36314 , F 64,S 8, H M 572578, I/A 21 (10.02.21).

18 de Septiembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: KENNEDY BRYAN JAMES;DUNDON PAUL. Nombramientos. Consejero: BOYLE GERARDPAUL;DUNDON PAUL;KENNEDY BRYAN JAMES. Presidente: BOYLE GERARD PAUL. Vicepresid.: DUNDON PAUL. SecreNoConsj:CERRILLO ARIAS PATRICIA. VsecrNoConsj: CAMARERO MARTIN OLGA. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 36314 , F 63, S 8, H M 572578, I/A 20(11.09.20).

11 de Septiembre de 2020
Revocaciones. Apo.Sol.: KENNEDY BRYAN JAMES;DUNDON PAUL. Nombramientos. Apo.Manc.: BOYLE GERARDPAUL;DUNDON PAUL;KENNEDY BRYAN JAMES;SIMONS MATTHEW JON;VAZQUEZ MARCELO. Apoderado: LION RESOURCESIBERIA SL;LION RESOURCES IBERIA SL. Datos registrales. T 36314 , F 61, S 8, H M 572578, I/A 19 ( 4.09.20).

19 de Febrero de 2020
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: MULTI MARKET SERVICES SPAIN HOLDINGS SL. Datosregistrales. T 36314 , F 60, S 8, H M 572578, I/A 18 (12.02.20).

18 de Febrero de 2020
Cambio de domicilio social. AVDA DEL PARTENON 12-14 (MADRID). Datos registrales. T 36314 , F 60, S 8, H M 572578, I/A 17(11.02.20).

05 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: CAMARERO MARTIN OLGA;CERRILLO ARIAS PATRICIA. Datos registrales. T 36314 , F 60, S 8, H M572578, I/A 16 (29.01.20).

19 de Septiembre de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: MIRANDA RIERA DAVID;BARONA CONESA SARA;COURREGE CATHERINE;DE LA CRUZ GALANLAURA;CALSAMIGLIA MENDLEWICZ OSCAR;DE NORIEGA QUINTANILLA ISABEL;BELTRAN YTURRIAGA JAVIER;JAMESHEFFERNAN EDWARD;BRIAN MAASHOFF JOSEPH;LESTER HORN CHARLES;JAMES HEFFERNAN EDWARD;BRIANMAASHOFF JOSEPH;LESTER HORN CHARLES;LYNN FAIR JEFFREY;HAGEMAN CYNTHIA LOU;MORALES GABALDONJAVIER;CLARK ELIZABETH ANNE;CHESNUT JOHN JEFFREY. Apoderado: MOTES III JOSEPH LAFAYETTE. Apo.Sol.: HAGEMANCYNTHIA LOU;MOTES III JOSEPH LAFAYETTE;CHESNUT JOHN JEFFREY;CLARK ELIZABETH ANNE;MAASHOFF JOSEPHBRIAN;HORN CHARLES LESTER. Datos registrales. T 36314 , F 59, S 8, H M 572578, I/A 15 (12.09.19).

13 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: FRAWLEY ANDREW JON;POWERS DOMINIC EDMUND;PATTON FITZGERALD JEANETTE;ABLCARLY;ARRIETA LARRAZ IGNACIO. Nombramientos. Apo.Sol.: HAGEMAN CYNTHIA LOU;MOTES III JOSEPHLAFAYETTE;CHESNUT JOHN JEFFREY;CLARK ELIZABETH ANNE;MAASHOFF JOSEPH BRIAN;HORN CHARLES LESTER.Datos registrales. T 31817 , F 214, S 8, H M 572578, I/A 14 ( 2.11.17).

28 de Agosto de 2017
Cambio de domicilio social. C/ FUENCARRAL, 119, 2潞 A. (MADRID). Datos registrales. T 31817 , F 214, S 8, H M 572578, I/A 13(10.08.17).

09 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: ARNALDO ALBUJAR JOSE ANTONIO;SANCHEZ HIJANO MARIA DE LAS MERCEDES. Datosregistrales. T 31817 , F 214, S 8, H M 572578, I/A 12 ( 1.06.17).

11 de Enero de 2017
Cambio de domicilio social. C/ CAPITAL HAYA 1 - PLANTA 15 (MADRID). Datos registrales. T 31817 , F 214, S 8, H M 572578,I/A 11 ( 2.01.17).

28 de Abril de 2016
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: MIRANDA RIERA DAVID. Consejero: DUNDON PAUL;KENNEDY BRYAN JAMES. Presidente:KENNEDY BRYAN JAMES. Consejero: FITZGERALD JEANETTE PATTON. Secretario: FITZGERALD JEANETTE PATTON.Nombramientos. Adm. Solid.: KENNEDY BRYAN JAMES;DUNDON PAUL. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 31817 , F 213, S 8, H M 572578, I/A 10(20.04.16).

09 de Febrero de 2016
Cambio de domicilio social. C/ PINAR 5 (MADRID). Datos registrales. T 31817 , F 213, S 8, H M 572578, I/A 9 ( 1.02.16).

20 de Noviembre de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: EPPERSON LEIGH ANN K. Nombramientos. Apoderado: MOTES III JOSEPH LAFAYETTE. Datosregistrales. T 31817 , F 212, S 8, H M 572578, I/A 8 (12.11.15).

04 de Septiembre de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: BENNETT GORE BRIAN;BARNES BOBBY;BENNETT GORE BRIAN;BARNES BOBBY. Nombramientos.Apo.Sol.: CLARK ELIZABETH ANNE;CHESNUT JOHN JEFFREY;ARRIETA LARRAZ IGNACIO. Datos registrales. T 31817 , F 211,S 8, H M 572578, I/A 7 (28.08.15).

28 de Julio de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 109.956,00 Euros. Datos registrales. T 31817 , F 211, S 8,H M 572578, I/A 6 (20.07.15).

18 de Junio de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: JAMES HEFFERNAN EDWARD;BENNETT GORE BRIAN;BRIAN MAASHOFF JOSEPH;BARNESBOBBY;LESTER HORN CHARLES;KENNEDY BRYAN JAMES;FRAWLEY ANDREW JON;POWERS DOMINIC EDMUND;DUNDONPAUL;PATTON FITZGERALD JEANETTE;LYNN FAIR JEFFREY;EPPERSON LEIGH ANN K;HAGEMAN CYNTHIA LOU;MORALESGABALDON JAVIER;ABL CARLY. Datos registrales. T 31817 , F 208, S 8, H M 572578, I/A 5 (11.06.14).

08 de Abril de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: MIRANDA RIERA DAVID;BARONA CONESA SARA;COURREGE CATHERINE;DE LA CRUZ GALAN

Nombramientos. Apo.Sol.: JAMES HEFFERNAN EDWARD;BENNETT GORE BRIAN;BRIAN MAASHOFF JOSEPH;BARNESBOBBY;LESTER HORN CHARLES. Datos registrales. T 31817 , F 207, S 8, H M 572578, I/A 4 ( 1.04.14).

25 de Marzo de 2014
Nombramientos. VsecrNoConsj: MIRANDA RIERA DAVID. Datos registrales. T 31817 , F 206, S 8, H M 572578, I/A 2 (18.03.14).

05 de Febrero de 2014
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 8.01.14. Objeto social: i) desarrollar, promocionar y comercializar soluciones y tecnolog铆asde marketing basadas principalmente en el uso del correo electr贸nico; (ii) la venta de todo tipo de productos relacionados con el env铆ode comunicaciones comerciales a trav茅s de medios tecnol贸gicos; y (iii) la prestaci贸n de servici. Domicilio: PASEO DE LACASTELLANA 52 - PLANTA 6 (MADRID). Capital: 9.956,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ALLIANCEDATA FHC INC. Nombramientos. Consejero: DUNDON PAUL;KENNEDY BRIAN JAMES. Presidente: KENNEDY BRIAN JAMES.Consejero: FITZGERALD JEANETTE PATTON. Secretario: FITZGERALD JEANETTE PATTON. Datos registrales. T 31817 , F 205,S 8, H M 572578, I/A 1 (29.01.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n