Actos BORME de Equifax Fraude Sl
10 de Mayo de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: SILVELA DIAZ-CRIADO JAIME ANTONIO. Datos registrales. T 22015 , F 192, S 8, H M 392422, I/A 43( 3.05.23).
25 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: PEREZ CALDERON ALBERTO. Apo.Manc.: RIOS ZAMARRO ANTONIO. Apo.Sol.: RIOS ZAMARROANTONIO. Datos registrales. T 22015 , F 192, S 8, H M 392422, I/A 42 (18.08.22).
10 de Mayo de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: DIAZ CONDE CARLOS. Datos registrales. T 22015 , F 192, S 8, H M 392422, I/A 41 (30.04.21).
19 de Septiembre de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: RIOS ZAMARRO ANTONIO. Apo.Sol.: RIOS ZAMARRO ANTONIO. Apo.Manc.: SILVELA DIAZ-CRIADO JAIME ANTONIO;DIAZ CONDE CARLOS. Datos registrales. T 22015 , F 191, S 8, H M 392422, I/A 40 (12.09.19).
08 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO ELIZO JOSE MARIA. Vicepresid.: ALONSO ELIZO JOSE MARIA. Revocaciones.Apoderado: FERNANDEZ GARCIA JUAN JOSE;CONTRERAS VICENTE DANIEL;DE LA PEÑA SPAGNOLETTA DANIELENRIQUE;FERNANDEZ GARCIA JUAN JOSE;CONTRERAS VICENTE DANIEL;DE LA PEÑA SPAGNOLETTA DANIEL ENRIQUE.Apo.Man.Soli: ALONSO ELIZO JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: AUSIN REVILLA SOFIA. Vicepresid.: AUSIN REVILLASOFIA. Datos registrales. T 22015 , F 191, S 8, H M 392422, I/A 39 ( 1.02.19).
02 de Febrero de 2018Nombramientos. Apoderado: AUSIN REVILLA SOFIA;MOLINA EXPOSITO ISABEL. Datos registrales. T 22015 , F 189, S 8, H M392422, I/A 38 (26.01.18).
01 de Septiembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: HARTMAN JOHN THOMAS. Vicepresid.: HARTMAN JOHN THOMAS. VsecrNoConsj: ENCINASPEREZ ALMUDENA. Revocaciones. Apoderado: SALVADOR BARROSO BERNARDO LUIS;PEREZ TRIGO JAVIER.Nombramientos. Consejero: ALONSO ELIZO JOSE MARIA. Vicepresid.: ALONSO ELIZO JOSE MARIA. Ampliacion del objetosocial. b) En la prestacion de servicios en materia de prevencion de blanqu. Datos registrales. T 22015 , F 189, S 8, H M 392422,I/A 37 (24.08.17).
26 de Julio de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO ELIZO JOSE MARIA. Datos registrales. T 22015 , F 188, S 8, H M 392422, I/A 36(18.07.17).
28 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: DO REGO BARROS PAULINO. Vicepresid.: DO REGO BARROS PAULINO. Nombramientos.Consejero: HARTMAN JOHN THOMAS. Vicepresid.: HARTMAN JOHN THOMAS. Apoderado: MOLINA EXPOSITO ISABEL. Datosregistrales. T 22015 , F 187, S 8, H M 392422, I/A 35 (17.06.16).
03 de Febrero de 2016Cambio de domicilio social. C/ GOYA 29 (MADRID). Datos registrales. T 22015 , F 187, S 8, H M 392422, I/A 34 (27.01.16).
23 de Octubre de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: CONTRERAS VICENTE DANIEL. Apoderado: ALONSO MARTINEZ CARLOS;SALVADOR BARROSOBERNARDO LUIS;ROJO SAIZ BELEN. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GARCIA JUAN JOSE;ALONSO MARTINEZCARLOS;CONTRERAS VICENTE DANIEL;DE LA PEÑA SPAGNOLETTA DANIEL ENRIQUE;FERNANDEZ GARCIA JUANJOSE;ALONSO MARTINEZ CARLOS;CONTRERAS VICENTE DANIEL;DE LA PEÑA SPAGNOLETTA DANIEL ENRIQUE;SALVADORBARROSO BERNARDO LUIS;GOMEZ BLAZQUEZ LORENZO;PEREZ TRIGO JAVIER;PEREZ CALDERON ALBERTO. Datosregistrales. T 22015 , F 186, S 8, H M 392422, I/A 33 (15.10.15).
15 de Septiembre de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ CAÑADA LEONARDO JOSE. Datos registrales. T 22015 , F 186, S 8, H M 392422, I/A32 ( 4.09.14).
27 de Febrero de 2014Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: EQUIFAX SPAIN HOLDINGS SL. Datos registrales. T 22015 , F185, S 8, H M 392422, I/A 30 (20.02.14).
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: RUIZ CEBRIAN HONORIO. Nombramientos. VsecrNoConsj: ENCINAS PEREZ ALMUDENA.Presidente: REMON PATRICIO. Datos registrales. T 22015 , F 185, S 8, H M 392422, I/A 31 (20.02.14).
31 de Octubre de 2013Declaración de unipersonalidad. Socio único: EQUIFAX IBERICA SL. Datos registrales. T 22015 , F 185, S 8, H M 392422, I/A 29(23.10.13).