Actos BORME de Equipamientos Urbanos Del Sur Sl
08 de Octubre de 2018Otros conceptos: QUEDA DISUELTA LA SOCIEDAD AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD DOMICILIADA ENMADRID, DENOMINADA "CLEAR CHANNEL ESPA脩A, SL".- Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 32630 , F 49, S8, H M 587334, I/A 12 (27.09.18).
23 de Julio de 2018Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CLEAR CHANNEL ESPA脩A SL. Datos registrales. T 32630 , F 49, S 8, H M587334, I/A 11 (13.07.18).
24 de Marzo de 2017Nombramientos. Cons.Del.Sol: HERNANDEZ VALER CESAR;ALMARCHA BARRIOS JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 32630 ,F 47, S 8, H M 587334, I/A 10 (15.03.17).
17 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: MORALES SANCHEZ JOSE. Co.De.Ma.So: MORALES SANCHEZ JOSE. Consejero: GRUPO DEEMPRESAS CAJASUR SL;COLUMBA 2010 SL. Presidente: MORALES SANCHEZ JOSE. SecreNoConsj: GARCIA GONZALEZIGNACIO. Representan: GOMEZ AGUILAR JUAN;DEL REY RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER. Revocaciones. Apo.Manc.:COLUMBA 2010 SL;GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SL;MORALES SANCHEZ JOSE. Apo.Sol.: HERNANDEZ VALER CESAR.Apo.Manc.: HERNANDEZ VALER CESAR;ALMARCHA BARRIOS JOSE IGNACIO;GRUPO DE EMPRESAS CAJASURSA;COLUMBIA 2010 SLU. Nombramientos. Consejero: GARCIA GONZALEZ IGNACIO. Presidente: HERNANDEZ VALER CESAR.Secretario: GARCIA GONZALEZ IGNACIO. Datos registrales. T 32630 , F 47, S 8, H M 587334, I/A 9 ( 9.01.17).
16 de Enero de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 30.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 663.750,00 Euros. Datos registrales. T 32630 , F46, S 8, H M 587334, I/A 8 ( 4.01.17).
24 de Noviembre de 2016Reelecciones. Auditor: SANCHEZ JIMENEZ SALVADOR. Aud.Supl.: AUDITORES DEL SUR SL. Datos registrales. T 32630 , F 46,S 8, H M 587334, I/A 7 (16.11.16).
21 de Julio de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 303.997,50 Euros. Resultante Suscrito: 694.350,00 Euros. Datos registrales. T 32630 , F45, S 8, H M 587334, I/A 6 (13.07.16).
22 de Abril de 2016Nombramientos. Aud.Supl.: AUDITORES DEL SUR SL. Reelecciones. Auditor: SANCHEZ JIMENEZ SALVADOR. Reducci贸n decapital. Importe reducci贸n: 83.475,00 Euros. Resultante Suscrito: 998.347,50 Euros. Datos registrales. T 32630 , F 45, S 8, H M587334, I/A 5 (15.04.16).
15 de Enero de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: JUAN GARCIA ARISTOBULO;USALLAN ORTIZ AGUSTIN. Datos registrales. T 32630 , F 44, S 8, H M587334, I/A 4 ( 8.01.16).
03 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Secretario: CRUZ SERNA TOMAS. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA GONZALEZ IGNACIO. Datosregistrales. T 32630 , F 44, S 8, H M 587334, I/A 3 (22.05.15).
18 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: USALLAN ORTIZ AGUSTIN. Presidente: USALLAN ORTIZ AGUSTIN. Co.De.Ma.So: USALLANORTIZ AGUSTIN. Nombramientos. Consejero: ALMARCHA BARRIOS JOSE IGNACIO. Presidente: MORALES SANCHEZ JOSE.Apo.Sol.: HERNANDEZ VALER CESAR. Apo.Manc.: HERNANDEZ VALER CESAR;ALMARCHA BARRIOS JOSE IGNACIO;DEL REYRODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER;GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA;COLUMBIA 2010 SLU. Cambio de domicilio social. C/ARTURO SORIA , 336, 1& (MADRID). Datos registrales. T 32630 , F 44, S 8, H M 587334, I/A 2 (10.09.14).
29 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: JUAN GARCIA ARISTOBULO. Co.De.Ma.So: JUAN GARCIA ARISTOBULO. Nombramientos.Consejero: HERNANDEZ VALER CESAR. Datos registrales. T 1411 , F 125, S 8, H CO 13506, I/A 29 (21.04.14).
04 de Febrero de 2014Nombramientos. Auditor: SANCHEZ JIMENEZ SALVADOR. Aud.Supl.: TRUJILLO FUENTES RAFAEL. Datos registrales. T 1411 ,F 125, S 8, H CO 13506, I/A 28 (28.01.14).
29 de Octubre de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: ROLDAN AGUILAR MANUEL LAUREANO. Nombramientos. Apo.Manc.: COLUMBA 2010 SL;GRUPO DEEMPRESAS CAJASUR SA;MORALES SANCHEZ JOSE;JUAN GARCIA ARISTOBULO;USALLAN ORTIZ AGUSTIN. Datosregistrales. T 1411 , F 124, S 8, H CO 13506, I/A 27 (22.10.13).
20 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA. Nombramientos. Consejero:COLUMBA 2010 SL. Reelecciones. Auditor: VASCO MARTINEZ JOSE MANUEL. Aud.Supl.: GISBERT BARBUDO JOAQUIN.Datos registrales. T 1411 , F 123, S 8, H CO 13506, I/A 25 (13.06.13).
17 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: GRUPO DE COMUNICACION DEL SUR SL. Consejero: GRUPO DE COMUNICACION DEL SURSL. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Consejero: CAJA DE AHORROS YMONTE DE PIEDAD DE CORDOBA. Auditor: VASCO MARTINEZ JOSE MANUEL. Aud.Supl.: GISBERT BARBUDO JOAQUIN.Cambio de domicilio social. PSAJE JOSE AUMENTE BAENA 3 3 (CORDOBA). Datos registrales. T 1411 , F 123, S 8, H CO13506, I/A 23 ( 9.05.11).
04 de Enero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: ORTIZ CANTERO FRANCISCO JULIAN. Co.De.Ma.So: ORTIZ CANTERO FRANCISCO JULIAN.Nombramientos. Consejero: GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA. Datos registrales. T 1411 , F 122, S 8, H CO 13506, I/A 22(22.12.09).