Actos BORME de Eres Paris Sl
17 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: DE BERTRAND PIBRAC PAULINE DENISE JACQUELINE. Nombramientos. Apoderado: FREDYVINCENT JEAN BERNARD;FERNIER DOROTHEE MARIE LAURE. Datos registrales. T 23494 , F 170, S 8, H M 421465, I/A 11 (7.10.22).
14 de Julio de 2020Cambio de domicilio social. C/ CLAUDIO COELLO, 75, LOCAL 2 (MADRID). Datos registrales. T 23494 , F 170, S 8, H M 421465,I/A 10 ( 8.07.20).
25 de Septiembre de 2019Revocaciones. Apoderado: JOURDAN CAMILLE. Nombramientos. Apo.Sol.: DE BERTRAND PIBRAC PAULINE DENISEJACQUELINE. Datos registrales. T 23494 , F 169, S 8, H M 421465, I/A 9 (18.09.19).
24 de Abril de 2019Revocaciones. Apoderado: KIRBY ANNA. Nombramientos. Apoderado: VANROYEN FLORENCE MARIE DANIELE. Datosregistrales. T 23494 , F 168, S 8, H M 421465, I/A 8 (15.04.19).
15 de Septiembre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: NICOLAS OLIVIER PHILIPPE. Apoderado: MAUNY OLIVIER JEAN LOUIS AUGUSTE. Nombramientos.Apoderado: JOURDAN CAMILLE;KIRBY ANNA. Datos registrales. T 23494 , F 167, S 8, H M 421465, I/A 7 ( 8.09.15).
02 de Febrero de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: COMBREDET GILLES GEORGES. Datos registrales. T 23494 , F 166, S 8, H M 421465, I/A 6 (24.01.12).
27 de Mayo de 2011Nombramientos. Apoderado: MAUNY OLIVIER JEAN LOUIS AUGUSTE;DERUY STEPHANE;BABOULENE BRIGITTE;LEULIERANNE SOPHIE;DELECROIX GERALDINE. Cambio de domicilio social. C/ CLAUDIO COELLO 85 (MADRID). Datos registrales. T23494 , F 165, S 8, H M 421465, I/A 5 (17.05.11).