Actos BORME de Escola Gremial Delectricitat I Fontaneria De Barcelona Sl
25 de Marzo de 2020Revocaciones. ADM.CONJUNTO: ALCAIDE GARRIGA JAIME. Nombramientos. ADM.CONJUNTO: MARTINEZ SABADELLMIGUEL ALFREDO. Datos registrales. T 35209 , F 104, S 8, H B 259776, I/A 10 (17.03.20).
14 de Marzo de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 147.354,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros. Datos registrales. T 35209 , F104, S 8, H B 259776, I/A 9 ( 7.03.18).
10 de Mayo de 2013Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: CASALS MAESTU JOAN. Datos registrales. T 35209 , F 103, S 8, H B 259776, I/A 7 (30.04.13).
Nombramientos. ADM.CONJUNTO: CARRASCO ALTIMIRAS DANIEL;ALCAIDE GARRIGA JAIME;SORIANO RULL ALBERTO.Modificaciones estatutarias. ART.17.- MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.Datos registrales. T 35209 , F 104, S 8, H B 259776, I/A 8 (30.04.13).
05 de Abril de 2013Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: PUERTOLAS MARROCO ANA MARIA. Datos registrales. T 35209 , F 103, S 8, H B 259776, I/A 6(25.03.13).
08 de Noviembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 204.347,00 Euros. Resultante Suscrito: 207.354,00 Euros. Datos registrales. T 35209 , F 103, S 8,H B 259776, I/A 5 (26.10.11).
21 de Abril de 2010Modificaciones estatutarias. ART.20.-ATRIBUCION DE CARACTER GRATUITO AL CARGO DE ADMINISTRADOR. Datosregistrales. T 35209 , F 103, S 8, H B 259776, I/A 4 ( 9.04.10).
03 de Julio de 2009Revocaciones. ADM.UNICO: ALSINA OLLER DELFI. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: CASALS MAESTU JOAN;PUERTOLASMARROCO ANA MARIA. Datos registrales. T 35209 , F 102, S 8, H B 259776, I/A 3 (22.06.09).