Buscador CIF Logo

Actos BORME Esindus Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Esindus Sa

Actos BORME Esindus Sa - A28058758

Tenemos registrados 46 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Esindus Sa con CIF A28058758

馃敊 Perfil de Esindus Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Esindus Sa

05 de Diciembre de 2023
Cambio de denominaci贸n social. JOHN COCKERILL HAMON SA. Datos registrales. T 24715 , F 46, S 8, H M 118183, I/A 151(28.11.23).

26 de Septiembre de 2023
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 24715 , F46, S 8, H M 118183, I/A 150 (19.09.23).

22 de Mayo de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: ORBAN FABRICE VICTOR SUZANNE. Presidente: ORBAN FABRICE VICTOR SUZANNE.Consejero: BINARD ERIC EDOUARD JEAN MARIE;BIART QUENTIN MICHEL PASCAL. Nombramientos. Consejero: L HONHONYVES ERNEST;LAIME ANNE FRANSCOISE MARIE YVONNE GHISLAINE;SARDO CARINA SUTERA. Presidente: L HONHON YVESERNEST. Datos registrales. T 24715 , F 45, S 8, H M 118183, I/A 149 (12.05.23).

12 de Abril de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: MORERA ESCRIGAS VICENTE;MONTALVO PALOMINO SILVIA. Datos registrales. T 24715 , F 45, S8, H M 118183, I/A 148 ( 5.04.22).

25 de Marzo de 2022
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 24715 , F45, S 8, H M 118183, I/A 147 (18.03.22).

07 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ VALLE CHAVARRI MARTIN. Datos registrales. T 24715 , F 45, S 8, H M 118183, I/A146 (30.09.21).

06 de Octubre de 2021
Otros conceptos: EMISION DE UN TITULO MULTIPLE NOMINATIVO. Datos registrales. T 24715 , F 44, S 8, H M 118183, I/A145M (29.09.21).

25 de Agosto de 2021
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.355,48 Euros. Resultante Suscrito: 414.683,15 Euros. Modificaciones estatutarias. HAQUEDADO REDUCIDO EL CAPITAL SOCIAL Y HAN QUEDADO MODIFICADOS LOS ARTICULOS 5 Y 8 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES.-. Datos registrales. T 24715 , F 44, S 8, H M 118183, I/A 145 (18.08.21).

30 de Junio de 2021
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ESINDUS HOLDCO SL. Datos registrales. T 24715 , F 43, S 8, H M 118183, I/A143 (23.06.21).

Nombramientos. Consejero: DELTENRE ANDRE GERARD A.;DENIS CHRISTOPHE. Datos registrales. T 24715 , F 44, S 8, H M118183, I/A 144 (23.06.21).

26 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apoderado: FERRERAS MATILLA LUIS. Datos registrales. T 24715 , F 43, S 8, H M 118183, I/A 142 (18.03.21).

25 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ DEL VALLE Y CHAVARRI MARTIN. Nombramientos. Apoderado: LLAMAS ARJONAJOSE ANTONIO. Datos registrales. T 24715 , F 43, S 8, H M 118183, I/A 141 (17.03.21).

02 de Marzo de 2021
Modificaciones estatutarias. Modificacion de los art铆culos 26, 27 y 30 de los estatutos sociales. Supresi贸n del art铆culo 37 de losestatutos y renumeraci贸n de los art铆culos 38 a 40. . Datos registrales. T 24715 , F 42, S 8, H M 118183, I/A 140 (23.02.21).

23 de Febrero de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: FIGAR VELASCO ARTURO;SANCHO MARQUEZ JAIME;FIGAR PIDAL SANTIAGO. Presidente:GONZALEZ DEL VALLE Y CHAVARRI MARTIN. Consejero: GONZALEZ DEL VALLE Y CHAVARRI MARIA;GONZALEZ DEL VALLEY CHAVARRI TRISTAN;CARUANA FIGAR JOSE. SecreNoConsj: RODRIGUEZ SANTOS FRANCISCO JAVIER. Nombramientos.SecreNoConsj: ARMENDIA FERNANDEZ DE VIANA I脩AKI. Presidente: ORBAN FABRICE VICTOR SUZANNE. Datos registrales. T24715 , F 42, S 8, H M 118183, I/A 139 (16.02.21).

28 de Septiembre de 2020
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 24715 , F42, S 8, H M 118183, I/A 138 (22.09.20).

26 de Agosto de 2020
Cambio de domicilio social. C/ MANOTERAS 50 (MADRID). Datos registrales. T 24715 , F 41, S 8, H M 118183, I/A 136(19.08.20).

Nombramientos. Consejero: S. ORBAN FABRICE VICTOR;P. BIART QUENTIN MICHEL. Datos registrales. T 24715 , F 41, S 8, HM 118183, I/A 137 (19.08.20).

04 de Agosto de 2020
Otros conceptos: EMISION DE TITULOS MULTIPLES REPRESENTATIVOS DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LASOCIEDAD. Datos registrales. T 24715 , F 27, S 8, H M 118183, I/A117 M (28.07.20).

28 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: LECLERCQ CHRISTIAN;GOBLET BERNARD MARIE CHRISTIAN PAUL. Vicepresid.: GOBLETBERNARD MARIE CHRISTIAN PAUL. Datos registrales. T 24715 , F 41, S 8, H M 118183, I/A 135 (21.07.20).

31 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: LLAMAS ARJONA JOSE ANTONIO;RODRIGUEZ PEREZ EVA-MARIA. Datos registrales. T 24715 , F40, S 8, H M 118183, I/A 134 (24.10.19).

10 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 24715 , F40, S 8, H M 118183, I/A 133 ( 3.10.19).

07 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: EXNER RODICA. Nombramientos. Consejero: LECLERCQ CHRISTIAN. Datos registrales. T24715 , F 39, S 8, H M 118183, I/A 132 (30.09.19).

12 de Abril de 2019
Revocaciones. Apoderado: RIVAS ZARAGUETA JOSE LUIS;LLEDO GARCIA ANTONIO;FERNANDEZ SEDANOAGUSTIN;GONZALEZ DEL VALLE Y CHAVARRI MARTIN;LLAMAS ARJONA JOSE ANTONIO;LLEDO GARCIA ANTONIO;FIGARPIDAL SANTIAGO;GONZALEZ DEL VALLE Y CHAVARRI MARTIN;LLAMAS ARJONA JOSE ANTONIO;FIGAR PIDALSANTIAGO;RODRIGUEZ PEREZ EVA-MARIA. Datos registrales. T 24715 , F 39, S 8, H M 118183, I/A 131 ( 5.04.19).

16 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ DEL VALLE Y CHAVARRI MARTIN;LLAMAS ARJONA JOSE ANTONIO;RODRIGUEZPEREZ EVA-MARIA;FERNANDEZ DE MERA NAVARRO EMMA;LLAMAS ARJONA JOSE ANTONIO;RODRIGUEZ PEREZ EVA-MARIA;MONTALVO PALOMINO SILVIA;RODRIGUEZ GANZO FRANCISCO JAVIER;LLAMAS ARJONA JOSEANTONIO;RODRIGUEZ PEREZ EVA-MARIA;MORERA ESCRIGAS VICENTE;FERRERAS MATILLA LUIS;UTRERA GARITAGOITIAIGNACIO;LLAMAS ARJONA JOSE ANTONIO;MORERA ESCRIGAS VICENTE;LLAMAS ARJONA JOSE ANTONIO;RODRIGUEZPEREZ EVA-MARIA;MORERA ESCRIGAS VICENTE;FERRERAS MATILLA LUIS;UTRERA GARITAGOITIA IGNACIO;LLAMASARJONA JOSE ANTONIO;RODRIGUEZ PEREZ EVA-MARIA;LLAMAS ARJONA JOSE ANTONIO;FERNANDEZ DE MERA NAVARROEMMA;RODRIGUEZ PEREZ EVA-MARIA. Datos registrales. T 24715 , F 36, S 8, H M 118183, I/A 130 ( 8.11.18).

27 de Septiembre de 2018
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 24715 , F36, S 8, H M 118183, I/A 129 (17.09.18).

21 de Septiembre de 2018
Reelecciones. Consejero: GONZALEZ DEL VALLE Y CHAVARRI TRISTAN;CARUANA FIGAR JOSE. Datos registrales. T 24715 ,F 36, S 8, H M 118183, I/A 128 (14.09.18).

30 de Enero de 2018
Ampliacion del objeto social. Ejecutar obras de tratamiento de aguas, de 谩mbito p煤blico o privado, y cualquier otro tipo de obra civilpor cuenta propia o de terceros,incluyendo construcci贸n, montaje, desmontaje, transformaci贸n, rehabilitaci贸n, acondicionamiento..Cambio de domicilio social. AVDA DE MANOTERAS NUMERO 42 (MADRID). Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas:ESINDUS SERVICIOS SL. Datos registrales. T 24715 , F 31, S 8, H M 118183, I/A 127 (19.01.18).

01 de Septiembre de 2017
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 24715 , F31, S 8, H M 118183, I/A 126 (23.08.17).

11 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: LAMBILLIOTTE FRANCIS. Vicepresid.: LAMBILLIOTTE M FRANCIS. Nombramientos. Consejero:BINARD ERIC EDOUARD J.;GOBLET BERNARD MARIE CHRISTIAN PAUL. Vicepresid.: GOBLET BERNARD MARIE CHRISTIANPAUL. Reelecciones. Consejero: SANCHO MARQUEZ JAIME;FIGAR PIDAL SANTIAGO;GONZALEZ VALLE CHAVARRI MARTIN.Presidente: GONZALEZ DEL VALLE Y CHAVARRI MARTIN. Consejero: GONZALEZ DEL VALLE Y CHAVARRI MARIA. Datosregistrales. T 24715 , F 31, S 8, H M 118183, I/A 125 ( 4.08.17).

28 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: LAMBILLIOTTE ALINE PATRICIA. Nombramientos. Consejero: GOBLET BERNARD MARIECHRISTIAN PAUL. Datos registrales. T 24715 , F 30, S 8, H M 118183, I/A 124 (21.06.17).

31 de Enero de 2017
Otros conceptos: Se declara que el auditor nombrado ha sido sustituido por "AUREN AUDITORES SP, SLP" como consecuencia dela escritura de fusi贸n y segregaci贸n que caus贸 la inscripci贸n 1陋 de la hoja 624.626. Datos registrales. T 24715 , F 30, S 8, H M118183, I/A 122M (16.01.17).

20 de Octubre de 2016
Reelecciones. Consejero: LAMBILLIOTTE FRANCIS;FIGAR VELASCO ARTURO. Vicepresid.: LAMBILLIOTTE M FRANCIS. Datosregistrales. T 24715 , F 30, S 8, H M 118183, I/A 123 ( 7.10.16).

11 de Octubre de 2016
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES MAD SLP. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES MAD SLP. Datos registrales. T 24715 ,F 30, S 8, H M 118183, I/A 122 ( 3.10.16).

09 de Diciembre de 2015
Reelecciones. Consejero: EXNER RODICA;LAMBILLIOTTE ALINE PATRICIA. Datos registrales. T 24715 , F 29, S 8, H M 118183,I/A 121 ( 1.12.15).

16 de Noviembre de 2015
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 26.-. Datos registrales. T 24715 , F 29, S 8, H M 118183, I/A 120 ( 5.11.15).

13 de Noviembre de 2015
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES MAD SLP. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES MAD SLP. Datos registrales. T 24715 ,F 29, S 8, H M 118183, I/A 119 ( 5.11.15).

05 de Diciembre de 2014
Reelecciones. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES MAD SL. Auditor: AUREN AUDITORES MAD SL. Datos registrales. T 24715 , F27, S 8, H M 118183, I/A 118 (27.11.14).

31 de Diciembre de 2013
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ DEL VALLE Y CHAVARRI MARTIN;FIGAR PIDAL SANTIAGO;LLAMAS ARJONA JOSEANTONIO;LLEDO GARCIA ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ DEL VALLE Y CHAVARRI MARTIN;LLAMASARJONA JOSE ANTONIO;FIGAR PIDAL SANTIAGO;RODRIGUEZ PEREZ EVA-MARIA. Datos registrales. T 24715 , F 27, S 8, H M118183, I/A 117 (20.12.13).

31 de Octubre de 2013
Reelecciones. Consejero: GONZALEZ DEL VALLE Y CHAVARRI TRISTAN. Otros conceptos: RATIFICACION DELNOMBRAMIENTO POR COOPTACION DE DON JOSE CARUANA FIGAR EN JUNTA GENERAL DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2013.Datos registrales. T 24715 , F 26, S 8, H M 118183, I/A 116 (24.10.13).

16 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: FIGAR ALVAREZ CANDIDO. Nombramientos. Consejero: CARUANA FIGAR JOSE. Datosregistrales. T 24715 , F 26, S 8, H M 118183, I/A 115 ( 7.05.13).

07 de Septiembre de 2012
Reelecciones. Consejero: SANCHO MARQUEZ JAIME;FIGAR PIDAL SANTIAGO;GONZALEZ VALLE CHAVARRI MARTIN.Presidente: GONZALEZ DEL VALLE Y CHAVARRI MARTIN. Consejero: GONZALEZ DEL VALLE Y CHAVARRI MARIA. Datosregistrales. T 24715 , F 26, S 8, H M 118183, I/A 114 (27.08.12).

11 de Junio de 2012
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: GILBERT JEAN. Datos registrales. T 7294 , F 224, S 8, H M 118183, I/A98 m (30.05.12).

12 de Diciembre de 2011
Reelecciones. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES MADRID SL. Datos registrales. T 24715 , F 25, S 8, H M 118183, I/A 113(24.11.11).

04 de Noviembre de 2011
Reelecciones. Consejero: LAMBILLIOTTE FRANCIS;FIGAR VELASCO ARTURO. Datos registrales. T 24715 , F 25, S 8, H M118183, I/A 112 (24.10.11).

03 de Febrero de 2011
Reelecciones. Consejero: LAMBILLIOTTE ALINE PATRICIA. Datos registrales. T 24715 , F 25, S 8, H M 118183, I/A 111(24.01.11).

15 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Consejero: EXNER RODICA. Datos registrales. T 24715 , F 25, S 8, H M 118183, I/A 110 (29.10.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n