Actos BORME de Espace Tecno Agricola Sl
03 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: PONTE GOMEZ FEDERICO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: POMARES ALONSO PABLO. Datosregistrales. T 10488, L 7769, F 222, S 8, H V 152657, I/A 21 (26.09.23).
31 de Marzo de 2021Fe de erratas: Se otorga poder a: Antonio González Rodríguez, y no a la propia sociedad como se publicó en el Boletín 91 de fecha17/05/17 y referencia 02044402017. Datos registrales. T 9591, L 6873, F 223, S 8, H V 152657, I/A 12 ( 9.05.17).
Revocaciones. Apoderado: BAS MARIN FERNANDO. Apo.Man.Soli: GONZALEZ RODRIGUEZ ANTONIO;PONTE GOMEZFEDERICO. Apoderado: GONZALEZ RODRIGUEZ ANTONIO. Datos registrales. T 10488, L 7769, F 221, S 8, H V 152657, I/A 19(24.03.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ RODRIGUEZ ANTONIO;PONTE GOMEZ FEDERICO;BAS MARIN FERNANDO. Datosregistrales. T 10488, L 7769, F 221, S 8, H V 152657, I/A 20 (24.03.21).
05 de Marzo de 2021Revocaciones. Apoderado: PALLARES MARIA DIANA. Datos registrales. T 10488, L 7769, F 220, S 8, H V 152657, I/A 18(26.02.21).
18 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 10488, L 7769, F 220, S 8, H V 152657, I/A 17 (11.12.20).
23 de Julio de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ RODRIGUEZ ANTONIO;PONTE GOMEZ FEDERICO. Datos registrales. T 9591, L6873, F 225, S 8, H V 152657, I/A 16 (16.07.18).
15 de Febrero de 2018Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: AGRICOLA SIERRA DE MARIA SL. SIEMBRA VIDA SL. HORTICULTURAINDUSTRIALIZADA SL. Datos registrales. T 9591, L 6873, F 224, S 8, H V 152657, I/A 15 ( 8.02.18).
13 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 9591, L 6873, F 224, S 8, H V 152657, I/A 14 ( 4.12.17).
28 de Noviembre de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: GAC SERVICIOS CORPORATIVOS SL. Datos registrales. T 9591,L 6873, F 224, S 8, H V 152657, I/A 13 (21.11.17).
17 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: ESPACE TECNO AGRICOLA SL. Datos registrales. T 9591, L 6873, F 223, S 8, H V 152657, I/A 12 (9.05.17).
13 de Marzo de 2017Revocaciones. Apoderado: LLOPIS MAGRANER FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: PALLARES MARIA DIANA;BASMARIN FERNANDO. Datos registrales. T 9591, L 6873, F 223, S 8, H V 152657, I/A 11 ( 6.03.17).
29 de Diciembre de 2016Cambio de domicilio social. AVDA DELS GREMIS. PARCELA 28 - POL. IND. SECTOR 1 (RIBA-ROJA DE TURIA). Datosregistrales. T 9591, L 6873, F 223, S 8, H V 152657, I/A 10 (21.12.16).
11 de Marzo de 2015Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 9591, L 6873, F 222, S 8, H V 152657, I/A 9 ( 4.03.15).
03 de Noviembre de 2014Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: GRUPO ALIMENTARIO CITRUS SL. Datos registrales. T 9591, L6873, F 222, S 8, H V 152657, I/A 8 (27.10.14).
23 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: HOLD AGRO ALIMENTARIO SL. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO ALIMENTARIO CITRUSSL. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: ARTICULO 15º. CIERRE ANUAL. El ejercicio social comienza el 1 deenero y termina el 31 de diciembre.. Otros conceptos: La entidad "Grupo Alimentario Citrus, SL" nombrada administradora unica, hadesignado como su persona fisica representante a don Joaquin Ballester Martinavarro. Cambio de domicilio social. C/ BALEARESS/N - PARCELA A-3. POLIGONO INDUSTRIAL (RIBA-ROJA DE TURIA). Datos registrales. T 9591, L 6873, F 222, S 8, H V 152657,I/A 7 (16.10.14).
29 de Mayo de 2014Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 15. Cierre del Ejercicio.- El ejercicio social comienza el 1 de junio y termina el31 de mayo del año siguiente.. Datos registrales. T 9591, L 6873, F 222, S 8, H V 152657, I/A 6 (22.05.14).
07 de Abril de 2014Cambio de domicilio social. C/ FORMENTERA 2 - LOCAL 15 -CENTRO NEGOCIOS- POL. (RIBA-ROJA DE TURIA). Datosregistrales. T 9591, L 6873, F 222, S 8, H V 152657, I/A 5 (31.03.14).
23 de Enero de 2014Revocaciones. Apoderado: LLOPIS MAGRANER FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: LLOPIS MAGRANER FRANCISCO.Datos registrales. T 9591, L 6873, F 221, S 8, H V 152657, I/A 4 (16.01.14).
09 de Mayo de 2013Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: HOLD AGRO ALIMENTARIO SL. Datos registrales. T 9591, L6873, F 220, S 8, H V 152657, I/A 2 (30.04.13).
Nombramientos. Apoderado: LLOPIS MAGRANER FRANCISCO. Datos registrales. T 9591, L 6873, F 220, S 8, H V 152657, I/A 3(30.04.13).
04 de Marzo de 2013Constitución. Comienzo de operaciones: 1.02.13. Objeto social: ARTICULO 2.- OBJETO.- La Sociedad tiene por objeto: 1) Laproducción, venta y comercialización de productos hortofrutícolas y la compraventa de maquinaria industrial. 2) La compra, venta yarrendamiento de bienes inmuebles, rústicos o urbanos, salvo el arrendamiento financiero. 3) la realización de. Domicilio: C/BALEARES - PARCELA A-3, POLIGONO INDUSTRIAL P (RIBA-ROJA DE TURIA). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración deunipersonalidad. Socio único: BALLESTER MARTINAVARRO ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: HOLD AGROALIMENTARIO SL. Otros conceptos: SE DESIGNA PERSONA FISICA REPRESENTANTE DEL ADMINISTRADOR UNICO A DONJOAQUIN BALLESTER MARTINAVARRO. Datos registrales. T 9591, L 6873, F 218, S 8, H V 152657, I/A 1 (25.02.13).