Buscador CIF Logo

Actos BORME Espacio Living Homes Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Espacio Living Homes Sl

Actos BORME Espacio Living Homes Sl - B83962225

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Espacio Living Homes Sl con CIF B83962225

馃敊 Perfil de Espacio Living Homes Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Espacio Living Homes Sl

08 de Junio de 2023
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 878.016,00 Euros. Resultante Suscrito: 671.424,00 Euros. Datos registrales. T 19927 , F217, S 8, H M 351324, I/A 58 ( 1.06.23).

31 de Enero de 2023
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ PAREDES ALFONSO. Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ FERNANDEZ ELENA.Datos registrales. T 19927 , F 217, S 8, H M 351324, I/A 57 (24.01.23).

17 de Agosto de 2022
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.012.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.549.440,00 Euros. Datos registrales. T 19927, F 216, S 8, H M 351324, I/A 56 ( 9.08.22).

18 de Julio de 2022
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.012.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.562.240,00 Euros. Datos registrales. T 19927, F 215, S 8, H M 351324, I/A 55 (11.07.22).

18 de Mayo de 2022
Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 19927 , F 215, S 8, H M 351324, I/A 54 (10.05.22).

17 de Mayo de 2022
Modificaciones estatutarias. 15. Organo de administraci贸n. Datos registrales. T 19927 , F 214, S 8, H M 351324, I/A 53 ( 9.05.22).

03 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: GUTIERREZ DE MESA VAZQUEZ GONZALO. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 50陋 lapublicaci贸n de la revocacion de GUTIERREZ DE MESA VAZQUEZ GONZALO como Apoderado Solidario. Datos registrales. T19927 , F 212, S 8, H M 351324, I/A 50 (19.11.20).

07 de Octubre de 2021
Cambio de domicilio social. PASEO DEL CLUB DEPORTIVO 1 - EDIFICIO 11, PARQUE E (POZUELO DE ALARCON). Datosregistrales. T 19927 , F 214, S 8, H M 351324, I/A 52 (30.09.21).

15 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apoderado: URIARTE GOICOECHEA ASIER. Datos registrales. T 19927 , F 212, S 8, H M 351324, I/A 51 (8.03.21).

26 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: GUTIERREZ DE MESA VAZQUEZ GONZALO. Datos registrales. T 19927 , F 212, S 8, H M 351324, I/A50 (19.11.20).

28 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apoderado: ESPIRITO SANTO SILVA NUNO MARIA DE FARIA;GALOBART JUSTE JUAN IGNACIO. Datosregistrales. T 19927 , F 209, S 8, H M 351324, I/A 49 (21.10.20).

28 de Mayo de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUTIERREZ DE MESA VAZQUEZ GONZALO. Nombramientos. Consejero: ESPIRITO SANTOSILVA NUNO MARIA DE FARIA. Datos registrales. T 19927 , F 209, S 8, H M 351324, I/A 48 (21.05.20).

12 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ PE脩IN ALBERTO;MARTINEZ PAREDES ALFONSO;PATON VILLARROYA MARIAJOSE;HERNANDEZ CAMARA OLGA. Datos registrales. T 19927 , F 208, S 8, H M 351324, I/A 47 ( 5.02.20).

08 de Julio de 2019
Nombramientos. Apoderado: PATON VILLAROYA MARIA JOSE. Datos registrales. T 19927 , F 208, S 8, H M 351324, I/A 46 (1.07.19).

07 de Mayo de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ GALLAR JOSE ANTONIO. Nombramientos. Consejero: HERNANDEZ CAMARAOLGA. Datos registrales. T 19927 , F 208, S 8, H M 351324, I/A 45 (26.04.19).

06 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ GALLAR JOSE ANTONIO. Apo.Manc.: FERNANDEZ GALLAR JOSE ANTONIO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ CAMARA OLGA. Datos registrales. T 19927 , F 205, S 8, H M 351324, I/A 44(29.10.18).

28 de Junio de 2018
Modificaciones estatutarias. Modificados los art铆culos 5潞, 13潞 y 15潞 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 19927 , F 204, S8, H M 351324, I/A 43 (20.06.18).

26 de Junio de 2018
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 19927 , F 200, S 8, H M 351324, I/A 40 (19.06.18).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PROMOCIONES Y PROPIEDADES INMOBILIARIAS ESPACIO SL. Representan: FERNANDEZGALLAR JOSE ANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj: HERNANDEZ CAMARA OLGA. Consejero: GUTIERREZ DE MESAVAZQUEZ GONZALO;PARREIRA JONET FRANCISCO MARIA;DE ALMEIDA CABRAL PINTO RAVARA NUNO;FERNANDEZGALLAR JOSE ANTONIO;MU脩OZ PE脩IN ALBERTO. Presidente: PARREIRA JONET FRANCISCO MARIA. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 19927 , F 200, S 8, HM 351324, I/A 41 (19.06.18).

Revocaciones. Apoderado: AROSTEGUI ESCRIBANO ALBINO;SUAREZ SAIZ MONICA;DIAZ ESTAN GREGORIO;MARTINEZPAREDES ALFONSO;AROSTEGUI ESCRIBANO ALBINO;HERNANDEZ CAMARA OLGA;AROSTEGUI ESCRIBANO ALBINO.Nombramientos. Apo.Manc.: PROMOCIONES Y PROPIEDADES INMOBILIARIAS ESPACIO SL. Apo.Sol.: PROMOCIONES YPROPIEDADES INMOBILIARIAS ESPACIO SL;FERNANDEZ GALLAR JOSE ANTONIOApo.Manc.: FERNANDEZ GALLAR JOSEANTONIO;MU脩OZ PE脩IN ALBERTO. Apo.Sol.: MU脩OZ PE脩IN ALBERTO;PARREIRA JONET FRANCISCO MARIA. Apo.Manc.:PARREIRA JONET FRANCISCO MARIA;GUTIERREZ DE MESA VAZQUEZ GONZALO. Apo.Sol.: GUTIERREZ DE MESA VAZQUEZGONZALO;SARMENTO DE MATOS PAIVA RAPOSO MANUEL. Apo.Manc.: SARMENTO DE MATOS PAIVA RAPOSO MANUEL;DEALMEIDA CABRAL PINTO RAVARA NUNO. Apo.Sol.: DE ALMEIDA CABRAL PINTO RAVARA NUNO. Datos registrales. T 19927 ,F 201, S 8, H M 351324, I/A 42 (19.06.18).

18 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apoderado: AROSTEGUI ESCRIBANO ALBINO. Datos registrales. T 19927 , F 199, S 8, H M 351324, I/A 39(10.05.18).

08 de Mayo de 2018
Ampliaci贸n de capital. Capital: 364.813,55 Euros. Resultante Suscrito: 7.575.040,00 Euros. Datos registrales. T 19927 , F 199, S 8,H M 351324, I/A 38 (27.04.18).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n