Actos BORME de Espumalia Sl
31 de Diciembre de 2020Nombramientos. APODERAD.SOL: ORTI ORTIZ JAVIER. Datos registrales. T 43912 , F 139, S 8, H B 441679, I/A 9 (18.12.20).
07 de Agosto de 2020Revocaciones. ADM.UNICO: CREMADES TORRADEFLOT JOSE ANTONIO. APODERAD.SOL: ORTIZ LAZARO EUSEBIA.Nombramientos. ADM.UNICO: ORTIN ORTIZ ALEIX. Datos registrales. T 43912 , F 138, S 8, H B 441679, I/A 8 (30.07.20).
02 de Abril de 2019Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: DOMINGUEZ LOPEZ JORDI;CREMADES TORRADEFLOT JOSE ANTONIO. Nombramientos.ADM.UNICO: CREMADES TORRADEFLOT JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 43912 , F 137, S 8, H B 441679, I/A 6 (25.03.19).
Nombramientos. APODERAD.SOL: ORTIZ LAZARO EUSEBIA. Datos registrales. T 43912 , F 137, S 8, H B 441679, I/A 7(25.03.19).
09 de Mayo de 2016Cambio de domicilio social. CR DEL MIG Num.186 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L'). Datos registrales. T 43912 , F 137, S 8,H B 441679, I/A 5 (29.04.16).
24 de Abril de 2015Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: ORTIZ LAZARO EUSEBIA. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: CREMADES TORRADEFLOTJOSE ANTONIO. Datos registrales. T 43912 , F 137, S 8, H B 441679, I/A 4 (17.04.15).
10 de Diciembre de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 59.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 68.200,00 Euros. Datos registrales. T 43912 , F 136, S 8, H B441679, I/A 3 (29.11.13).
26 de Noviembre de 2013Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: GARCIA CASTA脩O MERCEDES. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: ORTIZ LAZARO EUSEBIA.Datos registrales. T 43912 , F 136, S 8, H B 441679, I/A 2 (18.11.13).
04 de Septiembre de 2013Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 5.08.13. Objeto social:ADQUISICION,COMPRA,MANIPULACION,TRANSFORMACION,ALMACENAMIENTO,COMERCIALIZACION Y VENTA DEESPUMAS SINTETICAS Y SUS DERIVADOS,Y CUANTAS OPERACIONES TENGAN RELACION CON EL FIN EXPRESADO.Domicilio: AV DE LA FAMA, 121, NAVE INDUSTRIAL 1 (CORNELLA DE LLOBREGAT). Capital: 9.000,00 Euros. Nombramientos.ADM.SOLIDAR.: GARCIA CASTA脩O MERCEDES;DOMINGUEZ LOPEZ JORDI. Datos registrales. T 43912 , F 135, S 8, H B441679, I/A 1 (27.08.13).