Actos BORME de Esrei Group Sociedad Limitada
17 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MICO ALOS JORGE;FRANCO MONZO LUIS VICENTE. Nombramientos. Consejero: MICO ALOSJORGE;FRANCO MONZO LUIS VICENTE;MENGUAL SIREROL MARIA TERESA;MARTINEZ CLAVEL MARTINEZ CELIA;VAZQUEZPERIS JAVIER;FRANCO MENGUAL LUIS JOSE. Presidente: FRANCO MONZO LUIS VICENTE. Secretario: MICO ALOS JORGE.Cons.Del.Sol: VAZQUEZ PERIS JAVIER;FRANCO MENGUAL LUIS JOSE. Modificaciones estatutarias. Modificado el art. 16 de losEstatutos, relativo a la retribuci贸n del 贸rgano de Administraci贸n.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 9959, L 7241, F 17, S 8, H V 115707, I/A 9 (10.09.15).
25 de Mayo de 2015Revocaciones. Apoderado: BASTANTE GONZALEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 8504, L 5794, F 67, S 8, H V 115707, I/A 7(18.05.15).
Nombramientos. Apoderado: FRANCO MENGUAL LUIS JOSE. Datos registrales. T 8504, L 5794, F 67, S 8, H V 115707, I/A 8(18.05.15).
11 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ PERIS JAVIER. Datos registrales. T 8504, L 5794, F 66, S 8, H V 115707, I/A 6 ( 4.04.14).
02 de Diciembre de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 220.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.404.800,00 Euros. Datos registrales. T 8504, L5794, F 66, S 8, H V 115707, I/A 5 (25.11.13).
14 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: MENGUAL SIREROL MARIA TERESA;MARTINEZ CLAVEL Y MARTINEZ CELIA. Datos registrales. T8504, L 5794, F 65, S 8, H V 115707, I/A 4 ( 2.11.11).
04 de Marzo de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 375.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.625.000,00 Euros. Datos registrales. T 8504, L5794, F 65, S 8, H V 115707, I/A 3 (23.02.11).
09 de Enero de 2009Nombramientos. Apoderado: BASTANTE GONZALEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 8504, L 5794, F 64, S 8, H V 115707, I/A2 (26.12.08).