Actos BORME de Establecimientos Culturales Y Recreativos Premia Sa
19 de Septiembre de 2022Nombramientos. CONSEJERO: CARBONEL PINTANEL JOSE CARLOS;FREIXA SERRA MIQUEL. SECR.NO CONS:XALABARDER VOLTAS JOAQUIN. Datos registrales. T 28823 , F 147, S 8, H B 63958, I/A 75 ( 8.09.22).
08 de Agosto de 2022Revocaciones. CONSEJERO: GUILLEN BARONA JAVIER;SANCHEZ GARCIA TEOFILO. APOD.MANCOMU: GUILLEN BARONAJAVIER;SANCHEZ GARCIA TEOFILO. Datos registrales. T 28823 , F 147, S 8, H B 63958, I/A 74 (29.07.22).
15 de Junio de 2021Revocaciones. CONSEJERO: SANLLEHI CASTELLA AGUSTIN. VICEPRESIDEN: SANLLEHI CASTELLA AGUSTIN.APOD.MANCOMU: SANLLEHI CASTELLA AGUSTIN. Nombramientos. CONSEJERO: CRESPO ALAMILLO JOSE JUAN.VICEPRESIDEN: CRESPO ALAMILLO JOSE JUAN. Otros conceptos: EN FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2020 SE DELEGA ALORGANO DE ADMINISTRACION PARA AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL. Datos registrales. T 28823 , F 147, S 8, H B 63958, I/A73 ( 7.06.21).
02 de Octubre de 2020Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 583.518,00 Euros. Desembolsado: 583.518,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.629.337,00 Euros.Resultante Desembolsado: 6.629.337,00 Euros. Datos registrales. T 28823 , F 146, S 8, H B 63958, I/A 72 (23.09.20).
23 de Diciembre de 2019Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 530.847,00 Euros. Desembolsado: 530.847,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.045.819,00 Euros.Resultante Desembolsado: 6.045.819,00 Euros. Datos registrales. T 28823 , F 145, S 8, H B 63958, I/A 71 (13.12.19).
05 de Octubre de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 316.389,00 Euros. Desembolsado: 316.389,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.514.972,00 Euros.Resultante Desembolsado: 5.514.972,00 Euros. Datos registrales. T 28823 , F 144, S 8, H B 63958, I/A 70 (27.09.18).
25 de Octubre de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 289.848,00 Euros. Desembolsado: 289.848,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.198.583,00 Euros.Resultante Desembolsado: 5.198.583,00 Euros. Datos registrales. T 28823 , F 143, S 8, H B 63958, I/A 69 (17.10.17).
21 de Agosto de 2017Revocaciones. CONSEJERO: MOLINS GIL JOAQUIN MARIA. APODERADO: CARBONEL PINTANEL JOSE CARLOS;SANLLEHICASTELLA AGUSTIN;GUILLEN BARONA JAVIER;SANCHEZ GARCIA TEOFILO;MOLINS GIL JOAQUIN MARIA;XALABARDERVOLTAS JOAQUIN. Nombramientos. CONSEJERO: CARBONEL PINTANEL JOSE CARLOS. PRESIDENTE: CARBONELPINTANEL JOSE CARLOS. CONSEJERO: SANLLEHI CASTELLA AGUSTIN. VICEPRESIDEN: SANLLEHI CASTELLA AGUSTIN.CONSEJERO: GUILLEN BARONA JAVIER;SANCHEZ GARCIA TEOFILO. SECR.NO CONS: XALABARDER VOLTAS JOAQUIN.CONSEJERO: FREIXA SERRA MIQUEL. Datos registrales. T 28823 , F 142, S 8, H B 63958, I/A 67 (10.08.17).
Nombramientos. APOD.MANCOMU: CARBONEL PINTANEL JOSE CARLOS;SANLLEHI CASTELLA AGUSTIN;GUILLEN BARONAJAVIER;SANCHEZ GARCIA TEOFILO;CRESPO ALAMILLO JOSE JUAN;FREIXA SERRA MIQUEL;XALABARDER VOLTASJOAQUIN. Datos registrales. T 28823 , F 142, S 8, H B 63958, I/A 68 (10.08.17).
16 de Diciembre de 2015Revocaciones. CONSEJERO: BABOT DASCA MANUEL. APODERADO: BABOT DASCA MANUEL. Nombramientos.CONSEJERO: CRESPO ALAMILLO JOSE JUAN. Otros conceptos: DELEGACION AL ORGANO DE ADMINISTRACION PARAAUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL. Datos registrales. T 28823 , F 141, S 8, H B 63958, I/A 66 ( 7.12.15).
26 de Febrero de 2015Modificaciones estatutarias. ART.11: CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS GENERALES. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n dela p谩gina web corporativa: www.premiasa.com. Datos registrales. T 28823 , F 141, S 8, H B 63958, I/A 65 (19.02.15).
04 de Septiembre de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 45.000,00 Euros. Desembolsado: 45.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.908.735,00 Euros.Resultante Desembolsado: 4.908.735,00 Euros. Modificaciones estatutarias. SUPRESION DE LA DISPOSICION TRANSITORIA
16 de Octubre de 2012Nombramientos. APODERADO: CARBONEL PINTANEL JOSE CARLOS;SANLLEHI CASTELLA AGUSTIN;GUILLEN BARONAJAVIER;SANCHEZ GARCIA TEOFILO;MOLINS GIL JOAQUIN MARIA;BABOT DASCA MANUEL;XALABARDER VOLTAS JOAQUIN.Datos registrales. T 28823 , F 139, S 8, H B 63958, I/A 63 ( 3.10.12).
10 de Agosto de 2012Revocaciones. CONSEJERO: CARBONEL PINTANEL JOSE CARLOS. PRESIDENTE: CARBONEL PINTANEL JOSE CARLOS.CONSEJERO: SANCHEZ GARCIA TEOFILO. VICEPRESIDEN: SANCHEZ GARCIA TEOFILO. CONSEJERO: MOLINS GIL JOAQUINMARIA;GUILLEN BARONA JAVIER;BABOT DASCA MANUEL. SECRETARIO: BABOT DASCA MANUEL. Nombramientos.CONSEJERO: CARBONEL PINTANEL JOSE CARLOS. PRESIDENTE: CARBONEL PINTANEL JOSE CARLOS. CONSEJERO:SANLLEHI CASTELLA AGUSTIN. VICEPRESIDEN: SANLLEHI CASTELLA AGUSTIN. CONSEJERO: GUILLEN BARONAJAVIER;SANCHEZ GARCIA TEOFILO;MOLINS GIL JOAQUIN MARIA;BABOT DASCA MANUEL. SECR.NO CONS: XALABARDERVOLTAS JOAQUIN. Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL Num.426 P.2 PTA.2 (BARCELONA). Datos registrales. T 28823 ,F 138, S 8, H B 63958, I/A 62 ( 1.08.12).
16 de Abril de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 81.660,00 Euros. Desembolsado: 81.660,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.863.735,00 Euros.Resultante Desembolsado: 4.863.735,00 Euros. Datos registrales. T 28823 , F 138, S 8, H B 63958, I/A 61 ( 1.04.09).