Actos BORME de Estacion Alpina De Cotos Sa
25 de Septiembre de 2020Reelecciones. Consejero: MORETE LOPEZ PALOMA. Cons.Del.Sol: MORETE LOPEZ PALOMA. Datos registrales. T 1880 , F 215,S 8, H M 33784, I/A 58 (18.09.20).
10 de Septiembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DE LA FUENTE JOSE. Presidente: GONZALEZ DE LA FUENTE JOSE.Nombramientos. Consejero: GONZALEZ GARRIDO FERNANDO. Presidente: GONZALEZ GARRIDO FERNANDO. Otrosconceptos: Ratificado el nombramiento de Don Fernando Gonzalez Garrido como Consejero, designado por cooptacion. Datosregistrales. T 1880 , F 214, S 8, H M 33784, I/A 57 ( 3.09.19).
07 de Agosto de 2017Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: GONZALEZ GARRIDO FERNANDO;GONZALEZ GARRIDO MARIATERESA. Con.Delegado: GONZALEZ GARRIDO FERNANDO. Secretario: GONZALEZ GARRIDO MARIA TERESA. Nombramientos.SecreNoConsj: GONZALEZ GARRIDO MARIA TERESA. Reelecciones. Consejero: GONZALEZ DE LA FUENTE JOSE;GARRIDOHENARES MARIA TERESA;GONZALEZ HERNANZ MERCEDES. Presidente: GONZALEZ DE LA FUENTE JOSE. Datos registrales.
05 de Agosto de 2014Nombramientos. Consejero: MORETE LOPEZ PALOMA. Cons.Del.Sol: MORETE LOPEZ PALOMA. Modificaciones estatutarias.Modificado el art铆culo 11潞 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 1880 , F 213, S 8, H M 33784, I/A 55 (29.07.14).
19 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ MORETE ALFONSO. Cons.Del.Sol: GONZALEZ MORETE ALFONSO. Datosregistrales. T 1880 , F 213, S 8, H M 33784, I/A 54 ( 9.05.14).
16 de Octubre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ GARRIDO DIEGO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ MORETE ALFONSO.Cons.Del.Sol: GONZALEZ MORETE ALFONSO. Otros conceptos: LIMITADAS LAS FACULTADES DEL CONSEJERODELEGADO. Datos registrales. T 1880 , F 213, S 8, H M 33784, I/A 53 ( 2.10.12).
09 de Agosto de 2012Modificaciones estatutarias. 9. Administraci贸n y Representacion.-. Otros conceptos: Alta sede electr贸nica: www.valdesqui.es.Datos registrales. T 1880 , F 212, S 8, H M 33784, I/A 52 (26.07.12).
20 de Diciembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.013.150,97 Euros. Desembolsado: 2.013.150,97 Euros. Resultante Suscrito: 2.141.650,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.141.650,00 Euros. Datos registrales. T 1880 , F 211, S 8, H M 33784, I/A 51 ( 7.12.11).
04 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GONZALEZ GARRIDO MARIA TERESA. Nombramientos. Auditor: MARIJUAN ORDO脩EZJOSE MARIA. Aud.Supl.: DIEGUEZ DIAZ VALERO LUIS. Reelecciones. Consejero: GONZALEZ DE LA FUENTE JOSE;GARRIDOHENARES MARIA TERESA;GONZALEZ HERNANZ MERCEDES;GONZALEZ GARRIDO FERNANDO;GONZALEZ GARRIDO MARIATERESA. Presidente: GONZALEZ DE LA FUENTE JOSE. Secretario: GONZALEZ GARRIDO MARIA TERESA. Consejero:GONZALEZ GARRIDO DIEGO. Con.Delegado: GONZALEZ GARRIDO FERNANDO JOSE. Datos registrales. T 1880 , F 211, S 8, HM 33784, I/A 50 (22.09.11).
11 de Junio de 2010Nombramientos. Con.Delegado: GONZALEZ GARRIDO FERNANDO JOSE. Otros conceptos: SE ACEPTA LA DIMISION DEDO脩A MARIA TERESA GARRIDO HENARES A SU CARGO DE CONSEJERA DELEGADA, CONTINUANDO COMO CONSEJERADELA SOCIEDAD. Datos registrales. T 1880 , F 211, S 8, H M 33784, I/A 49 (31.05.10).
10 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GARRIDO DIEGO MARCO. Datos registrales. T 1880 , F 210, S 8, H M 33784, I/A 48(28.05.10).