Actos BORME de Estacion De Autobuses De Avila Sl
01 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: IGNACIO CESAR GARCIA DE LEANIZ CANOSA. Datos registrales. T 185, L 143, F 171, S 8, H AV3040, I/A 31 (27.11.23).
16 de Marzo de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MARIA ELENA LOPEZ CANUTO. Datos registrales. T 174, L 132, F 140, S 8, H AV 3040, I/A 30 (9.03.23).
07 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: IGNACIO CESAR GARCIA DE LEANIZ CANOSA. Datos registrales. T 174, L 132, F 139, S 8, H AV3040, I/A 29 (30.01.20).
31 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ELOY FERNANDEZ OJEDA. Nombramientos. Adm. Mancom.: LUIS ROMAN SANCHEZ-RUBIO. Datos registrales. T 174, L 132, F 139, S 8, H AV 3040, I/A 28 (22.10.19).
12 de Agosto de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: ELOY FERNANDEZ OJEDA. Datos registrales. T 174, L 132, F 137, S 8, H AV 3040, I/A 26(30.07.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SERGIO GONZALEZ BRAVO. Datos registrales. T 174, L 132, F 137, S 8, H AV 3040, I/A 27(30.07.19).
17 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO SOROA VALENTIN. Datos registrales. T 171, L 129, F 185, S 8, H AV 3040, I/A 24 (7.05.19).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO SOROA VALENTIN;LOZANO BONFIL LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 174, L 132,F 137, S 8, H AV 3040, I/A 25 ( 7.05.19).
04 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Presidente: LLORENTE BUS SL. Consejero: LLORENTE BUS SL;AUTO RES SL;MU脩OZ GARCIA JAIME.SecreNoConsj: MONICA MANTECA MARTINEZ. VsecrNoConsj: JOSE MARIA HERREROS SIERRA. Nombramientos. Adm.Mancom.: ALONSO SOROA VALENTIN;MARTHA ANGELICA DURAN REGIS;ELOY FERNANDEZ OJEDA. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 171, L129, F 185, S 8, H AV 3040, I/A 23 (26.12.18).
07 de Noviembre de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 302.880,00 Euros. Resultante Suscrito: 321.810,00 Euros. Datos registrales. T 171, L 129, F 184, S8, H AV 3040, I/A 22 (24.10.18).
10 de Agosto de 2018Nombramientos. Apoderado: ALBERTO TRIGUEROS RODRIGUEZ. Datos registrales. T 171, L 129, F 183, S 8, H AV 3040, I/A 21(27.07.18).
09 de Julio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO SOROA VALENTIN. Presidente: ALONSO SOROA VALENTIN. SecreNoConsj: PATRICIAALVAREZ MIGUEL. Nombramientos. Consejero: LLORENTE BUS SL. Presidente: LLORENTE BUS SL. VsecrNoConsj: JOSEMARIA HERREROS SIERRA. SecreNoConsj: MONICA MANTECA MARTINEZ. Otros conceptos: Se d谩 nueva redacci贸n a losEstatutos Sociales. Cambio de objeto social. a) La explotaci贸n de estaciones de autobuses, intercambiadores de transporte, centrosde distribuci贸n de mercanc铆as y agencias de transporte en todas las modalidades, estaciones de servicio, aparcamientos de veh铆culos,garajes y talleres en su forma m谩s amplia y completa. b) La prestaci贸n y explotac. Datos registrales. T 166, L 124, F 224, S 8, H AV3040, I/A 14 (29.06.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTHA ANGELICA DURAN REGIS. Datos registrales. T 171, L 129, F 177, S 8, H AV 3040, I/A17 (29.06.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ELOY FERNANDEZ OJEDA. Datos registrales. T 171, L 129, F 179, S 8, H AV 3040, I/A 18(29.06.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ENRIQUE SANCHEZ FERNANDEZ. Datos registrales. T 171, L 129, F 181, S 8, H AV 3040, I/A 19( 2.07.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LUIS ALBERTO DOMINGUEZ RODRIGUEZ;JOSE MANUEL PEREZ MARTINEZ;PEDRO RAMONGOMEZ ABAD. Datos registrales. T 171, L 129, F 182, S 8, H AV 3040, I/A 20 ( 2.07.18).
15 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Secretario: HERREROS SIERRA JOSE MARIA. Nombramientos. SecreNoConsj: PATRICIA ALVAREZMIGUEL. Datos registrales. T 159, L 117, F 6, S 8, H AV 3040, I/A 13 (30.01.17).
22 de Mayo de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO SOROA VALENTIN;LOZANO BONFIL LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 159, L117, F 6, S 8, H AV 3040, I/A 12 (13.05.15).
08 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ TORRALBA FLORENTINO JESUS. Presidente: LOPEZ TORRALBA FLORENTINO JESUS.Con.Delegado: LOPEZ TORRALBA FLORENTINO JESUS. Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ TORRALBA FLORENTINOJESUS. Nombramientos. Consejero: ALONSO SOROA VALENTIN. Presidente: ALONSO SOROA VALENTIN. Datos registrales. T159, L 117, F 6, S 8, H AV 3040, I/A 11 (21.04.15).
21 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN BLANCO CRISTINA;LOPEZ TORRALBA FLORENTINO JESUS. Datos registrales. T 148,L 106, F 131, S 8, H AV 3040, I/A 9 ( 5.11.14).
Revocaciones. Apoderado: GALAN CALLE JESUS GABRIEL. Datos registrales. T 148, L 106, F 131, S 8, H AV 3040, I/A 10 (5.11.14).
22 de Abril de 2014Cambio de domicilio social. AVDA JUAN CARLOS I S/N (AVILA). Datos registrales. T 148, L 106, F 131, S 8, H AV 3040, I/A 7 (8.04.14).
05 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: HIDALGO SALCEDO JOSE LUIS. Datos registrales. T 100, L 58, F 20, S 8, H AV 3040, I/A 6(20.02.12).