Actos BORME de Estacion De Servicio Macar Sa
13 de Julio de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 15.025,30 Euros. Resultante Suscrito: 237.399,78 Euros. Datos registrales. T 40678 , F 1,S 8, H M 49358, I/A 26 ( 6.07.20).
14 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TRINCADO BOVILLE AUGUSTO LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: TRINCADO BOVILLEAUGUSTO LUIS. Datos registrales. T 2871 , F 161, S 8, H M 49358, I/A 25 ( 7.10.19).
13 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: TRINCADO MATEO AUGUSTO. Datos registrales. T 2871 , F 160, S 8, H M 49358, I/A 23 ( 5.12.18).
Nombramientos. Apoderado: NAVARRO RUBIO JOSE JOAQUIN. Datos registrales. T 2871 , F 161, S 8, H M 49358, I/A 24 (5.12.18).
27 de Febrero de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 42.070,85 Euros. Resultante Suscrito: 252.425,08 Euros. Datos registrales. T 2871 , F159, S 8, H M 49358, I/A 22 (20.02.17).
12 de Agosto de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 6.010,12 Euros. Resultante Suscrito: 294.495,93 Euros. Otros conceptos:SUBSANACION DEL VALOR DE LAS ACCIONES SOCIALES. Ampliacion del objeto social. LA SOCIEDAD TENDRA POROBJETO LA EXPLOTACION DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES YSERVICIOS RELACIONADOS CON VEHICULOS DE TODA CLASE. CON CARACTER ACCESORIO LA SOCIEDAD TENDRA POROBJETO LA REALIZACION DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, DE CONSTRUCCION. Datos registrales. T 2871, F 158, S 8, H M 49358, I/A 21 ( 4.08.16).
13 de Septiembre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: TRINCADO MATEO AINHOA;TRINCADO MATEO JAVIER. Datos registrales. T 2871 , F 158, S 8, H M49358, I/A 20 ( 5.09.13).
13 de Junio de 2013Nombramientos. Apoderado: NAVARRO RUBIO ANTOLIN JOSE. Datos registrales. T 2871 , F 135, S 8, H M 49358, I/A 17 (5.06.13).
Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ CARRON JOSE ANTONIO;MATEO CERRADA ANTONIO;RODRIGUEZ GOMEZ JOSEANTONIO;MATEO CERRADA MANUEL. Datos registrales. T 2871 , F 136, S 8, H M 49358, I/A 18 ( 5.06.13).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MATEO CERRADA MANUEL;MATEO CERRADA ANTONIO FERMIN;TRINCADO BOVILLEAUGUSTO LUIS;PLATERO PARADA RAMON;RUFFIN VILLAOSLADA JOSE IGNACIO;SANZ CID JOSE LUIS. Presidente:TRINCADO BOVILLE AUGUSTO LUIS. Secretario: PLATERO PARADA RAMON. Con.Delegado: TRINCADO BOVILLE AUGUSTOLUIS. Nombramientos. Adm. Unico: TRINCADO BOVILLE AUGUSTO LUIS. Auditor: CAUDISA MGC COMPA脩IA DE AUDITORESSLP. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico.COMO
05 de Octubre de 2012Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: CERRADA HUETE-HUERTA ANTONIA;MATEO CERRADA MARIADOLORES. Nombramientos. Consejero: TRINCADO BOVILLE AUGUSTO LUIS;PLATERO PARADA RAMON;RUFFIN
Nombramientos. Presidente: TRINCADO BOVILLE AUGUSTO LUIS. Secretario: PLATERO PARADA RAMON. Con.Delegado:TRINCADO BOVILLE AUGUSTO LUIS. Datos registrales. T 2871 , F 135, S 8, H M 49358, I/A 15 (26.09.12).
25 de Abril de 2012Otros conceptos: Anotaci贸n preventiva de la demanda rectora del procedimiento de medidas cautelares n潞 5/2011 acordadomediante auto de fecha 18 de julio de 2011, por el Juzgado de lo Mercantil n潞7 de Madrid. Datos registrales. T 2871 , F 133, S 8, H M49358, I/A A (10.04.12).
25 de Enero de 2011Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: CERRADA HUETE-HUERTA ANTONIA. Datos registrales. T 2871 , F 133, S 8, H M 49358, I/A13 (14.01.11).