Actos BORME de Este Castillo Property Sl
22 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO. Vicesecret.: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO. Datosregistrales. T 44664 , F 58, S 8, H M 686362, I/A 10 (15.09.23).
09 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DIRECTORSHIP CIBELES SL. Representan: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO.Nombramientos. Consejero: DE GONZALO MARTINEZ RODRIGO;DOMINGUEZ CORTES LUIS. Presidente: DOMINGUEZCORTES LUIS. Secretario: DE GONZALO MARTINEZ RODRIGO. Consejero: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO. Vicesecret.:GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO. Consejero: SAUNDERS RICHARD THOMAS. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 38595 , F 113, S 8, H M 686362, I/A 8 (2.02.23).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO. Datos registrales. T 38595 , F 113, S 8, H M 686362, I/A 9 (2.02.23).
27 de Diciembre de 2022Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 38595 , F 112, S 8, H M 686362, I/A 7 (19.12.22).
17 de Octubre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: DE GONZALO MARTINEZ RODRIGO;SAUNDERS RICHARD THOMAS;DOMINGUEZ CORTES LUIS.Datos registrales. T 38595 , F 110, S 8, H M 686362, I/A 6 ( 7.10.22).
18 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: KRUISSEN JOSEPHUS PETRUS MARIA. Datos registrales. T 38595 , F 109, S 8, H M 686362, I/A 5(11.07.22).
07 de Junio de 2022Cambio de domicilio social. AVDA DEL DOCTOR ARCE 14 (MADRID). Datos registrales. T 38595 , F 109, S 8, H M 686362, I/A 4(31.05.22).