Buscador CIF Logo

Actos BORME Estudio Juridico-ejaso Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Estudio Juridico-ejaso Sl

Actos BORME Estudio Juridico-ejaso Sl - B83386490

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Estudio Juridico-ejaso Sl con CIF B83386490

馃敊 Perfil de Estudio Juridico-ejaso Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Estudio Juridico-ejaso Sl

03 de Agosto de 2023
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 19.975,80 Euros. Resultante Suscrito: 100.470,00 Euros. Datos registrales. T 40010 , F180, S 8, H M 308521, I/A 29 (26.07.23).

12 de Abril de 2023
Nombramientos. Apoderado: DE NAVASQUES TORROBA JOSE LUIS. Datos registrales. T 40010 , F 179, S 8, H M 308521, I/A28 ( 3.04.23).

29 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Auditor: LBL AUDIT LP. Datos registrales. T 40010 , F 179, S 8, H M 308521, I/A 27 (22.09.22).

22 de Junio de 2022
Nombramientos. Consejero: GRANDES HERNANDEZ GONZALO;ALTIMIS IBA脩ES JUAN ENRIQUE;DE NAVASQUES TORROBAJOSE LUIS. Datos registrales. T 40010 , F 178, S 8, H M 308521, I/A 26 (15.06.22).

01 de Junio de 2022
Ampliaci贸n de capital. Capital: 11.820,40 Euros. Resultante Suscrito: 120.445,80 Euros. Datos registrales. T 40010 , F 177, S 8, HM 308521, I/A 25 (25.05.22).

04 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: CASTILLO CANO-CORTES JOSE ANGEL;RODRIGUEZ VALLECILLO CARLOS;LATASA VASALLOLUIS;FALERO DE RATO ALEJANDRO;URBANOS CANOREA PABLO. Datos registrales. T 40010 , F 177, S 8, H M 308521, I/A 24(28.01.22).

13 de Julio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIONIS TRENOR GUILLERMO;AGUAYO FERNANDEZ DE CORDOVA MARIANO. Revocaciones.Apo.Man.Soli: DIONIS TRENOR GUILLERMO;AGUAYO FERNANDEZ DE CORDOVA MARIANO. Datos registrales. T 40010 , F176, S 8, H M 308521, I/A 23 ( 6.07.21).

29 de Abril de 2021
Nombramientos. Apoderado: GRANDES HERNANDEZ GONZALO;ALTIMIS IBA脩ES JUAN ENRIQUE. Datos registrales. T 40010 ,F 176, S 8, H M 308521, I/A 22 (22.04.21).

11 de Marzo de 2020
Nombramientos. Aud.Supl.: G N L RUSSELL BEDFORD AUDITORS SL. Reelecciones. Auditor: LORENTE SIBINA RAUL. Datosregistrales. T 40010 , F 175, S 8, H M 308521, I/A 21 ( 4.03.20).

09 de Marzo de 2020
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.260,80 Euros. Resultante Suscrito: 108.625,40 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedadesabsorbidas: VALDES LATASA & ASOCIADOS SLP. Datos registrales. T 32541 , F 212, S 8, H M 308521, I/A 20 ( 2.03.20).

11 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apoderado: HERNANDO DE LARRAMENDI SAMANIEGO ALVARO;HERNANDEZ PARDO ALFREDO;SOBREPERAMILLET ISABEL;FLORES HERNANDEZ CARMEN;DIONIS TRENOR GUILLERMO;GONZALEZ-HABA POGGIO MANUEL;AGUAYOFERNANDEZ DE CORDOVA MARIANO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ PARDO ALFREDO;HERNANDO DELARRAMENDI SAMANIEGO ALVARO;FLORES HERNANDEZ CARMEN;SOBREPERA MILLET ISABEL;HABA POGGIO MANUELGONZALEZ;DIONIS TRENOR GUILLERMO;AGUAYO FERNANDEZ DE CORDOVA MARIANO. Datos registrales. T 32541 , F 211,S 8, H M 308521, I/A 19 ( 4.02.20).

20 de Marzo de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ RIVERA JOSE MANUEL;CAMBAS PUENTE PEDRO. Datos registrales. T 32541 , F211, S 8, H M 308521, I/A 18 (13.03.19).

08 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: AGUAYO FERNANDEZ DE CORDOVA MARIANO. Datos registrales. T 32541 , F 210, S 8, H M308521, I/A 17 ( 1.03.19).

06 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Consejero: GONZALEZ-HABA POGGIO MANUEL. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: MARIANOAGUAYO SA. Datos registrales. T 32541 , F 208, S 8, H M 308521, I/A 16 (26.10.18).

02 de Marzo de 2018
Ceses/Dimisiones. Auditor: GUTIERREZ BUREAU D'AUDITEURS SL. Nombramientos. Auditor: LORENTE SIBINA RAUL.Aud.Supl.: VENTOSA ANTON ALICIA. Datos registrales. T 32541 , F 208, S 8, H M 308521, I/A 15 (21.02.18).

01 de Junio de 2017
Nombramientos. Consejero: AGUAYO FERNANDEZ DE CORDOVA MARIANO. Ampliaci贸n de capital. Capital: 5.502,60 Euros.Resultante Suscrito: 105.364,60 Euros. Datos registrales. T 32541 , F 207, S 8, H M 308521, I/A 14 (24.05.17).

22 de Agosto de 2016
Nombramientos. Auditor: GUTIERREZ BUREAU D'AUDITEURS SL. Datos registrales. T 32541 , F 207, S 8, H M 308521, I/A 13(12.08.16).

17 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ PARDO ALFREDO;HERNANDO DE LARRAMENDI SAMANIEGO ALVARO;FLORES

30 de Junio de 2015
Nombramientos. Apoderado: CEREZALES FERNANDEZ ALFREDO. Datos registrales. T 32541 , F 206, S 8, H M 308521, I/A 11(23.06.15).

20 de Febrero de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ PARDO ALFREDO;HERNANDO DE LARRAMENDI SAMANIEGO ALVARO;FLORESHERNANDEZ CARMEN;SOBREPERA MILLET ISABEL;GAITAN LUJAN MARIA JULIA;GIL GARCIA RAUL;GONZALEZ HABAPOGGIO MANUEL. Nombramientos. Apoderado: HERNANDO DE LARRAMENDI SAMANIEGO ALVARO;HERNANDEZ PARDOALFREDO;SOBREPERA MILLET ISABEL;FLORES HERNANDEZ CARMEN;DIONIS TRENOR GUILLERMO;GONZALEZ-HABAPOGGIO MANUEL;GAITAN LUJAN MARIA JULIA. Datos registrales. T 32541 , F 200, S 8, H M 308521, I/A 10 (12.02.15).

22 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Consejero: EQUIPO DE INTERESES Y TRANSACCIONES SL. Representan: DIONIS TRENOR GUILLERMO.Ampliaci贸n de capital. Capital: 9.986,20 Euros. Resultante Suscrito: 99.862,00 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedadesabsorbidas: EQUIT SERVER 21 SL. Datos registrales. T 17877 , F 63, S 8, H M 308521, I/A 9 (12.12.14).

25 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: GIL GARCIA RAUL. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.891,20 Euros. Resultante Suscrito:97.008,80 Euros. Datos registrales. T 17877 , F 61, S 8, H M 308521, I/A 6 (17.09.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GAITAN LUJAN MARIA JULIA. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 7.642,50 Euros.

Ampliaci贸n de capital. Capital: 509,50 Euros. Resultante Suscrito: 89.875,80 Euros. Datos registrales. T 17877 , F 62, S 8, H M308521, I/A 8 (17.09.14).

16 de Febrero de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ PARDO ALFREDO;HERNANDO DE LARRAMENDI SAMANIEGO ALVARONICOLAS;FLORES HERNANDEZ MARIA CARMEN;SOBREPERA MILLET ISABEL;GAITAN LUJAN MARIA JULIA. Secretario:

27 de Enero de 2009
Cambio de objeto social. A) LA INTERMEDIACION ENTRE LOS CLIENTES Y LOS PROFESIONALES LEGALMENTECOMPETENTES PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO JURIDICO,... Datosregistrales. T 17877 , F 59, S 8, H M 308521, I/A 4 (15.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n