Buscador CIF Logo

Actos BORME Estudios E Ingenieria Aplicada Xxi Sociedad Anonima

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Estudios E Ingenieria Aplicada Xxi Sociedad Anonima

Actos BORME Estudios E Ingenieria Aplicada Xxi Sociedad Anonima - A48116420

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Estudios E Ingenieria Aplicada Xxi Sociedad Anonima con CIF A48116420

🔙 Perfil de Estudios E Ingenieria Aplicada Xxi Sociedad Anonima
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Estudios E Ingenieria Aplicada Xxi Sociedad Anonima

15 de Julio de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRES INCLAN JUAN CARLOS. Nombramientos. Consejero: BOBO GUMPERT FERNANDO.Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 39862 , F 52, S 8, HM 708110, I/A 4 ( 8.07.22).

21 de Enero de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: ARBO FERNANDEZ ALBERTO. Nombramientos. Consejero: TORRES INCLAN JUAN CARLOS.Datos registrales. T 39862 , F 52, S 8, H M 708110, I/A 3 (14.01.21).

21 de Noviembre de 2019
Cambio de domicilio social. C/ SIRIO 14 10º C (MADRID). Datos registrales. T 39862 , F 52, S 8, H M 708110, I/A 2 (15.11.19).

07 de Noviembre de 2019
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 3960 , F 185, S 8, HBI 3520,A , I/ 56 .(29.10.19).

21 de Septiembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: MENENDEZ DE LUARCA BELLIDO RAMON. Presidente: MENENDEZ DE LUARCA BELLIDORAMON. Consejero: GARCIA ALMUZARA MARTIN GONZALO;ARBO FERNANDEZ ALBERTO;SOLDEVILLA REYNSTBARBARA;SEDANO SANLLORENTE LORENZO. Nombramientos. Consejero: MENENDEZ DE LUARCA BELLIDORAMON;GARCIA ALMUZARA MARTIN GONZALO;ARBO FERNANDEZ ALBERTO. Presidente: MENENDEZ DE LUARCA BELLIDORAMON. Modificaciones estatutarias. Modificación del artículo 20 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 3960 , F 99, S 8,H BI 3520,A , I/ 55 .(13.09.18).

21 de Mayo de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: ULRICH CARL;DELGADO DE ROBLES DE LA PEÑA LUIS;ARBO FERNANDEZALBERTO;SOLDEVILLA REYNST BARBARA;GARCIA ALMUZARA MARTIN GONZALO;MENENDEZ DE LUARCA BELLIDORAMON. Presidente: MENENDEZ DE LUARCA BELLIDO RAMON. Nombramientos. Consejero: MENENDEZ DE LUARCABELLIDO RAMON. Presidente: MENENDEZ DE LUARCA BELLIDO RAMON. Consejero: GARCIA ALMUZARA MARTINGONZALO;ARBO FERNANDEZ ALBERTO;SOLDEVILLA REYNST BARBARA;SEDANO SANLLORENTE LORENZO. Datosregistrales. T 3960 , F 98, S 8, H BI 3520,A , I/ 53 .( 2.05.18).

Cambio de domicilio social. C/ RIBERA DE AXPE 11 - EDIFICIO C1, M101 (ERANDIO). Datos registrales. T 3960 , F 98, S 8, H BI3520,A , I/ 54 .(10.05.18).

06 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Consejero: DELGADO DE ROBLES DE LA PEÑA LUIS. Datos registrales. T 3960 , F 98, S 8, H BI 3520,A , I/ 52.(24.10.17).

15 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: BIZKARRA JAIO JOSE MARIA;VIZCARRA JAIO JOSE ALBERTO. Nombramientos. Consejero:ULRICH CARL. Datos registrales. T 3960 , F 98, S 8, H BI 3520,A , I/ 51 .( 7.03.17).

02 de Enero de 2017
Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 3960 , F 98, S 8, HBI 3520,A , I/ 50 .(22.12.16).

11 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apoderado: VIZCARRA LIZUNDIA JOSE MARIA. Datos registrales. T 3960 , F 97, S 8, H BI 3520,A , I/ 49 .(4.02.16).

05 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: CRESPO LLOREDA PEDRO;ALAEZ DIEZ FRANCISCO;SERNA BERASATEGUI ALBERTO.Secretario: FELGUEROSO FUENTES SECUNDINO. Presidente: BIZKARRA JAIO JOSE MARIA. Con.Delegado: BIZKARRA JAIOGEMMA. Consejero: BIZKARRA JAIO GEMMA;SIERRA VILLA JAVIER. Nombramientos. Consejero: MENENDEZ DE LUARCABELLIDO RAMON;GARCIA ALMUZARA MARTIN GONZALO;VIZCARRA JAIO JOSE ALBERTO;ARBO FERNANDEZALBERTO;SOLDEVILLA REYNST BARBARA. Presidente: MENENDEZ DE LUARCA BELLIDO RAMON. SecreNoConsj: BOBOGUMPERT FERNANDO. Datos registrales. T 3960 , F 95, S 8, H BI 3520,A , I/ 46 .(23.12.15).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA ALMUZARA MARTIN GONZALO. Datos registrales. T 3960 , F 96, S 8, H BI 3520,A , I/ 47.(24.12.15).

Nombramientos. Apoderado: MENENDEZ DE LUARCA BELLIDO RAMON. Datos registrales. T 3960 , F 97, S 8, H BI 3520,A , I/48 .(24.12.15).

31 de Julio de 2015
Revocaciones. Apoderado: DEL VAL PECIÑA FERNANDO. Datos registrales. T 3960 , F 95, S 8, H BI 3520,A , I/ 44 .(23.07.15).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GUIJARRO CASTRO ANGEL. Nombramientos. Consejero: SIERRA VILLA JAVIER. Datosregistrales. T 3960 , F 95, S 8, H BI 3520,A , I/ 45 .(23.07.15).

04 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Con.Delegado: BIZKARRA JAIO GEMMA. Datos registrales. T 3960 , F 95, S 8, H BI 3520,A , I/ 43 .(19.08.14).

18 de Agosto de 2014
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: BIZKARRA JAIO GEMMA. Reelecciones. Consejero: BIZKARRA JAIO JOSEMARIA;BIZKARRA JAIO GEMMA. Datos registrales. T 3960 , F 94, S 8, H BI 3520,A , I/ 42 .(21.07.14).

27 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apoderado: DEL VAL PECIÑA FERNANDO. Datos registrales. T 3960 , F 94, S 8, H BI 3520,A , I/ 41 .(16.08.13).

22 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: VIZCARRA LIZUNDIA JOSE MARIA. Presidente: VIZCARRA LIZUNDIA JOSE MARIA. Secretario:SIERRA VILLA JAVIER. Consejero: DEL VALLE SUAREZ ANGEL ANTONIO. Nombramientos. Consejero: GUIJARRO CASTRO

27 de Octubre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRES INCLAN JUAN CARLOS. ConsejSuplen: ALAEZ DIEZ FRANCISCO. Nombramientos.Consejero: ALAEZ DIEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 3960 , F 93, S 8, H BI 3520,A , I/ 39 .(17.10.11).

03 de Agosto de 2010
Revocaciones. D. Gerente: MARTINEZ AZKUE JOSE ANGEL. Datos registrales. T 3960 , F 92, S 8, H BI 3520,A , I/ 37 .(20.07.10).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ AZKUE JOSE ANGEL. Nombramientos. Consejero: CRESPO LLOREDA PEDRO.Datos registrales. T 3960 , F 92, S 8, H BI 3520,A , I/ 38 .(22.07.10).

08 de Marzo de 2010
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GUTIERRREZ GUTIERREZ PEDRO ANGEL. D. Gerente: MARTINEZ AZKUE JOSE ANGEL.Revocaciones. Apoderado: GUTIERRREZ GUTIERREZ PEDRO ANGEL. Nombramientos. D. Gerente: MARTINEZ AZKUE JOSEANGEL. Consejero: VIZCARRA LIZUNDIA JOSE MARIA. Presidente: VIZCARRA LIZUNDIA JOSE MARIA. Secretario: SIERRA VILLA

Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA VALDES FELIX. Nombramientos. Consejero: TORRES INCLAN JUAN CARLOS;DELVALLE SUAREZ ANGEL ANTONIO. Datos registrales. T 3960 , F 92, S 8, H BI 3520,A , I/ 36 .(19.02.10).

22 de Junio de 2009
Nombramientos. D. Gerente: MARTINEZ AZKUE JOSE ANGEL. Datos registrales. T 3960 , F 86, S 8, H BI 3520,A , I/ 34 .(8.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información