Actos BORME de Etracontrol Sl
05 de Julio de 2022Revocaciones. Apoderado: CARLA CASANUEVA MURUAIS. Datos registrales. T 3582 , F 140, S 8, H MU 94822, I/A 27(28.06.22).
27 de Junio de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: JOSE FERNANDO ALBIACH DOMINGO;CESAR GOMEZ PEIRO. Fe de erratas: Al publicar la ins. 11 seomiti贸 consignar que la revocaci贸n de los poderes de los se帽ores indicados en ella lo era tambi茅n de sus facultades mancomunadas.Datos registrales. T 3304 , F 75, S 8, H MU 94822, I/A 11 (13.06.18).
17 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: MARGARITA GARCIA SANCHEZ. Datos registrales. T 3304 , F 82, S 8, H MU 94822, I/A 25(10.06.22).
25 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: LORENZO ARCE SELMA. Datos registrales. T 3304 , F 82, S 8, H MU 94822, I/A 24 (18.05.22).
11 de Mayo de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALBERTO SANZ RUIZ;LORENZO ARCE SELMA. Datos registrales. T 3304 , F 82, S 8, H MU 94822,I/A 23 ( 4.05.22).
25 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apoderado: GLORIA FERNANDEZ SENAC. Datos registrales. T 3304 , F 81, S 8, H MU 94822, I/A 22 (18.11.21).
16 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: ARIADNA GOMEZ DEL PULGAR FERRERO;ARIADNA GOMEZ DEL PULGAR FERRERO. Datosregistrales. T 3304 , F 81, S 8, H MU 94822, I/A 21 ( 9.11.21).
22 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: ANDREA PENEDO SIENES. Datos registrales. T 3304 , F 80, S 8, H MU 94822, I/A 19 (15.06.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: MIGUEL LOPEZ-MEDEL MARINA;MIGUEL LOPEZ-MEDEL MARINA. Datos registrales. T 3304 , F 81, S8, H MU 94822, I/A 20 (15.06.21).
04 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: FRANCISCO-JAVIER ESTEVEZ AROSA. Datos registrales. T 3304 , F 79, S 8, H MU 94822, I/A 18(28.05.21).
22 de Julio de 2020Revocaciones. Apoderado: SARA PEREZ GONZALEZ. Datos registrales. T 3304 , F 79, S 8, H MU 94822, I/A 17 (15.07.20).
30 de Octubre de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: LORENZO ARCE SELMA;JESUS MANZANO DEL POZO. Datos registrales. T 3304 , F 78, S 8, HMU 94822, I/A 15 (23.10.19).
26 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: CARLA CASANUEVA MURUAIS. Datos registrales. T 3304 , F 77, S 8, H MU 94822, I/A 14(19.11.18).
14 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: CARLOS VERCET BOTET;ARIADNA GOMEZ DEL PULGAR FERRERO;MIGUEL LOPEZ-MEDELMARINA. Datos registrales. T 3304 , F 76, S 8, H MU 94822, I/A 13 ( 6.11.18).
06 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apoderado: SARA RODRIGUEZ SANCHEZ;SARA RODRIGUEZ SANCHEZ. Datos registrales. T 3304 , F 75, S 8, HMU 94822, I/A 12 (29.10.18).
20 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: CESAR GOMEZ PEIRO;JOSE FERNANDO ALBIACH DOMINGO. Datos registrales. T 3304 , F 75, S 8,H MU 94822, I/A 11 (13.06.18).
05 de Abril de 2018Nombramientos. Apoderado: JESUS MANZANO DEL POZO. Datos registrales. T 3243 , F 137, S 8, H MU 94822, I/A 10(27.03.18).
28 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ARIADNA GOMEZ DEL PULGAR FERRERO;MIGUEL LOPEZ-MEDEL MARINA. Datos registrales. T3243 , F 137, S 8, H MU 94822, I/A 9 (21.02.18).
26 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: SARA RODRIGUEZ SANCHEZ. Datos registrales. T 3243 , F 134, S 8, H MU 94822, I/A 7 (19.07.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LORENZO ARCE SELMA;ALBERTO SANZ RUIZ. Datos registrales. T 3243 , F 134, S 8, H MU94822, I/A 8 (19.07.17).
04 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: JOSE LUIS LOSADA SANZ. Datos registrales. T 3243 , F 134, S 8, H MU 94822, I/A 6 (27.06.17).
01 de Junio de 2017Revocaciones. Apoderado: JOSE FERNANDO MURGA TOME. Datos registrales. T 3243 , F 133, S 8, H MU 94822, I/A 3(25.05.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOSE-MARIA MU脩OZ CEREZO. Apo.Manc.: PEDRO-JAVIER CARCELES ARCE. Datosregistrales. T 3243 , F 133, S 8, H MU 94822, I/A 4 (25.05.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FRANCISCO MANUEL FERRANDEZ CAMARA. Apo.Manc.: PEDRO-JAVIER CARCELES ARCE.Datos registrales. T 3243 , F 134, S 8, H MU 94822, I/A 5 (25.05.17).
09 de Mayo de 2017Ampliacion del objeto social. 1) La instalacion y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridadconectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia. 2) La explotacion de centrales para laconexion, recepcion, verificacion y en su caso, respuesta y transmision de se帽. Cambio de domicilio social. C/ CARRIL MOLINONERVA 21 (MURCIA). Datos registrales. T 3243 , F 132, S 8, H MU 94822, I/A 2 (28.04.17).
01 de Julio de 2013Nombramientos. Apoderado: PEREZ GONZALEZ SARA. Datos registrales. T 28503 , F 169, S 8, H M 513163, I/A 6 (21.06.13).
06 de Junio de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.003.200,00 Euros. Datos registrales. T 28503 , F 168, S8, H M 513163, I/A 5 (25.05.11).
14 de Marzo de 2011Nombramientos. Apoderado: MURGA TOME JOSE FERNANDO. Datos registrales. T 28503 , F 166, S 8, H M 513163, I/A 2 (2.03.11).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ SANCHEZ SARA. Datos registrales. T 28503 , F 167, S 8, H M 513163, I/A 3 ( 2.03.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALBIACH DOMINGO JOSE FERNANDO. Apo.Manc.: ALBIACH DOMINGO JOSE FERNANDO. Apo.Sol.:GOMEZ PEIRO CESAR. Apo.Manc.: GOMEZ PEIRO CESAR. Datos registrales. T 28503 , F 168, S 8, H M 513163, I/A 4 ( 2.03.11).
09 de Marzo de 2011Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 15.02.11. Objeto social: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSITO AEREO. LA