Actos BORME de Eulen Integra Sa
26 de Septiembre de 2022Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 37957 , F 213, S 8, H M 330247, I/A 207 (19.09.22).
30 de Agosto de 2022Otros conceptos: NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL , POR PLAZO DE SEIS MESES , DECONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 DEL RRM.- Datos registrales. T 37957 , F 213, S 8, H M 330247,I/A206 M (23.08.22).
18 de Abril de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: BILBAO REY JOSE LUIS. Apoderado: BILBAO REY JOSE LUIS. Datos registrales. T 37957 , F 213,S 8, H M 330247, I/A 206 ( 7.04.22).
29 de Marzo de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: VEGA GALLEGO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 37957 , F 213, S 8, H M 330247, I/A 205(22.03.22).
24 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apoderado: ROLDAN FERNANDEZ NATALIA. Datos registrales. T 37957 , F 210, S 8, H M 330247, I/A 203(17.11.21).
Nombramientos. Apoderado: PADRON GARCIA IRIS. Datos registrales. T 37957 , F 212, S 8, H M 330247, I/A 204 (17.11.21).
25 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: FRANCO AVILA JOSE MARIA. Datos registrales. T 37957 , F 210, S 8, H M 330247, I/A 202 (18.06.21).
24 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ DE SANTIAGO EVA INES;SALAZAR ROMAN ANTONIO MIGUEL. Datos registrales. T37957 , F 210, S 8, H M 330247, I/A 201 (17.06.21).
03 de Junio de 2021Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 37957 , F 209, S 8, H M 330247, I/A 200 (27.05.21).
28 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: RAMOS RODRIGUEZ JAVIER. Datos registrales. T 37957 , F 209, S 8, H M 330247, I/A 199 (21.04.21).
06 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN BENAVIDES ENRIQUE. Datos registrales. T 37957 , F 207, S 8, H M 330247, I/A 196(26.03.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: BENITEZ MORALES RAFAEL. Datos registrales. T 37957 , F 207, S 8, H M 330247, I/A 197 (26.03.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: BENITEZ MORALES RAFAEL. Datos registrales. T 37957 , F 208, S 8, H M 330247, I/A 198 (26.03.21).
24 de Marzo de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: RAMOS RODRIGUEZ JAVIER. Datos registrales. T 37957 , F 205, S 8, H M 330247, I/A 194(16.03.21).
Revocaciones. Apoderado: DE LA HOZ NOMBELA FRANCISCO;DE LA HOZ NOMBELA FRANCISCO. Datos registrales. T 37957, F 206, S 8, H M 330247, I/A 195 (16.03.21).
08 de Marzo de 2021Revocaciones. Apoderado: LOMBAN FERNANDEZ TERESA YALAISA. Datos registrales. T 37957 , F 205, S 8, H M 330247, I/A193 ( 1.03.21).
15 de Febrero de 2021Revocaciones. Apoderado: MARTIN ALCALA MARTA. Datos registrales. T 37957 , F 204, S 8, H M 330247, I/A 191 ( 8.02.21).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SUAREZ DIEZ BARTOLOME. Datos registrales. T 37957 , F 205, S 8, H M 330247, I/A 192 (8.02.21).
29 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALVAREZ RODRIGUEZ MARCELINO. Apoderado: ALVAREZ RODRIGUEZ MARCELINO. Datosregistrales. T 37957 , F 202, S 8, H M 330247, I/A 188 (21.12.20).
Nombramientos. Apoderado: ZAMORA BARRIOS JAVIER. Datos registrales. T 37957 , F 203, S 8, H M 330247, I/A 189(21.12.20).
Nombramientos. Apoderado: ZAMORA BARRIOS JAVIER. Datos registrales. T 37957 , F 204, S 8, H M 330247, I/A 190(21.12.20).
28 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: GARCIA RUIZ ANA BELEN. Datos registrales. T 37957 , F 199, S 8, H M 330247, I/A 185 (21.10.20).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA PERULLES EMILIO JAVIER. Datos registrales. T 37957 , F 200, S 8, H M 330247, I/A 186(21.10.20).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA ARIAS MARIA LUISA;MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS;GARCIA RUIZ ANABELEN;ALVAREZ REYGOSA JOAQUIN. Datos registrales. T 37957 , F 202, S 8, H M 330247, I/A 187 (21.10.20).
09 de Julio de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA MARTIN JUAN. Apo.Man.Soli: GARCIA MARTIN JUAN. Datos registrales. T 37957 , F 197, S 8,H M 330247, I/A 182 ( 2.07.20).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ SANCHEZ MARTA. Datos registrales. T 37957 , F 198, S 8, H M 330247, I/A 183 ( 2.07.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ SALCEDA RAUL. Datos registrales. T 37957 , F 198, S 8, H M 330247, I/A 184 ( 2.07.20).
22 de Mayo de 2020Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 37957 , F 197, S 8, H M 330247, I/A 181 (14.05.20).
19 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: MARTIN BENAVIDES ENRIQUE. Datos registrales. T 37957 , F 196, S 8, H M 330247, I/A 180(12.03.20).
11 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apoderado: LAGUNA MARTINEZ FERNANDO. Apo.Sol.: LAGUNA MARTINEZ FERNANDO. Apo.Manc.: LAGUNAMARTINEZ FERNANDO. Datos registrales. T 37957 , F 196, S 8, H M 330247, I/A 179 ( 4.11.19).
04 de Junio de 2019Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ CASTILLO JUDIT. Datos registrales. T 37957 , F 195, S 8, H M 330247, I/A 178 (28.05.19).
11 de Abril de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 37957 , F 195, S 8, H M 330247, I/A 177 ( 4.04.19).
21 de Marzo de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: VALLADARES GONZALEZ LUCIANO. Datos registrales. T 37957 , F 195, S 8, H M 330247, I/A 176(14.03.19).
11 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: ARROYO SOUTO MANUEL. Datos registrales. T 35578 , F 11, S 8, H M 330247, I/A 174 ( 4.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ARROYO SOUTO MANUEL. Datos registrales. T 37957 , F 195, S 8, H M 330247, I/A 175 ( 4.03.19).
08 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: CASTAÑO CHAVES NURIA. Datos registrales. T 35578 , F 10, S 8, H M 330247, I/A 172 (31.10.18).
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ JESUS DAVID;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Nombramientos.Adm. Unico: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 11º, 12º, 13º Y14º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios aAdministrador único. Datos registrales. T 35578 , F 11, S 8, H M 330247, I/A 173 (31.10.18).
04 de Julio de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: DIAZ GARCIA WENCESLAO. Apo.Man.Soli: DIAZ GARCIA WENCESLAO. Datos registrales. T 35578 , F10, S 8, H M 330247, I/A 170 (27.06.18).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ SANCHEZ SALVADOR. Datos registrales. T 35578 , F 10, S 8, H M 330247, I/A 171(27.06.18).
28 de Mayo de 2018Revocaciones. Apoderado: NIÑO RABADAN JUAN JOSE. Datos registrales. T 35578 , F 8, S 8, H M 330247, I/A 168 (21.05.18).
Revocaciones. Apoderado: DEL PINO LOPEZ PULIDO TANIA. Datos registrales. T 35578 , F 9, S 8, H M 330247, I/A 169(21.05.18).
28 de Febrero de 2018Cambio de domicilio social. C/ GOBELAS 29 (MADRID). Datos registrales. T 35578 , F 8, S 8, H M 330247, I/A 166 (20.02.18).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ CASTILLO JUDIT. Datos registrales. T 35578 , F 8, S 8, H M 330247, I/A 167 (20.02.18).
22 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 35578 , F 8, S 8, H M 330247, I/A 165 (12.01.18).
16 de Enero de 2018Revocaciones. Apoderado: CAVERO CATALAN OSCAR. Datos registrales. T 35578 , F 8, S 8, H M 330247, I/A 163 ( 8.01.18).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MANUEL;FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MANUEL. Datos registrales.T 35578 , F 8, S 8, H M 330247, I/A 164 ( 8.01.18).
21 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: NIÑO RABADAN JUAN JOSE. Datos registrales. T 35578 , F 5, S 8, H M 330247, I/A 160 (14.11.17).
Revocaciones. Apo.Sol.: VERDESOTO GOMEZ VERONICA. Datos registrales. T 35578 , F 7, S 8, H M 330247, I/A 161 (14.11.17).
Nombramientos. Apoderado: MARTIN ALCALA MARTA;ARECES PALENCIA MARIA. Datos registrales. T 35578 , F 7, S 8, H M330247, I/A 162 (14.11.17).
28 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: PASCUAL MORALES SANTIAGO. Datos registrales. T 35578 , F 3, S 8, H M 330247, I/A 158(20.09.17).
Nombramientos. Apoderado: LLORENTE CORNEJO JESUS GREGORIO. Datos registrales. T 35578 , F 4, S 8, H M 330247, I/A159 (20.09.17).
24 de Agosto de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ GUTIERREZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 35578 , F 3, S 8, H M 330247, I/A 156(10.08.17).
Revocaciones. Apoderado: CARDENAL PASTOR SONIA. Datos registrales. T 35578 , F 3, S 8, H M 330247, I/A 157 (10.08.17).
11 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: MAGARZO GARROTE PALOMA. Datos registrales. T 35578 , F 1, S 8, H M 330247, I/A 153 (3.05.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: MAGARZO GARROTE PALOMA. Datos registrales. T 35578 , F 2, S 8, H M 330247, I/A 154 ( 4.05.17).
Revocaciones. Apo.Sol.: NIÑO RABADAN JUAN JOSE;NIÑO RABADAN JUAN JOSE. Datos registrales. T 35578 , F 3, S 8, H M330247, I/A 155 ( 4.05.17).
06 de Febrero de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28577 , F 225, S 8, H M 330247, I/A 152 (30.01.17).
25 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apoderado: DEL PINO LOPEZ PULIDO TANIA. Datos registrales. T 28577 , F 224, S 8, H M 330247, I/A 151(17.11.16).
30 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ SANCHO JUAN RAMON;MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS;SALAZAR ROMAN ANTONIOMIGUEL;ALVAREZ RODRIGUEZ MARCELINO;GARCIA MARTIN JUAN. Datos registrales. T 28577 , F 224, S 8, H M 330247, I/A150 (23.09.16).
29 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA MANCEBO DOMINGO. Datos registrales. T 28577 , F 223, S 8, H M 330247, I/A 147(21.09.16).
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ MENDOZA GEMA. Datos registrales. T 28577 , F 224, S 8, H M 330247, I/A 148 (21.09.16).
Revocaciones. Apo.Sol.: ALONSO FERNANDEZ ISMAEL. Apo.Man.Soli: ALONSO FERNANDEZ ISMAEL. Datos registrales. T28577 , F 224, S 8, H M 330247, I/A 149 (21.09.16).
26 de Julio de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ TOME EDUARDO. Datos registrales. T 28577 , F 223, S 8, H M 330247, I/A 146(13.07.16).
13 de Junio de 2016Revocaciones. Apoderado: DEL VAL ANTOÑANA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 28577 , F 222, S 8, H M 330247, I/A145 ( 3.06.16).
05 de Abril de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOMEZ GOMEZ JOSE ANGEL. Datos registrales. T 28577 , F 222, S 8, H M 330247, I/A 144(29.03.16).
14 de Marzo de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: CARRERO ANTIN SANTIAGO. Datos registrales. T 28577 , F 222, S 8, H M 330247, I/A 142 (4.03.16).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 28577 , F 222, S 8, H M 330247, I/A 143 (4.03.16).
01 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: IBAÑEZ FERRIOL LORENA. Datos registrales. T 28577 , F 220, S 8, H M 330247, I/A 141 (19.02.16).
17 de Febrero de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: NUÑEZ FEIJOO MARIA MICAELA;DIAZ GARCIA WENCESLAO;BLANCO DIAZ JOSE ANGEL.Datos registrales. T 28577 , F 219, S 8, H M 330247, I/A 140 (10.02.16).
15 de Febrero de 2016Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28577 , F 219, S 8, H M 330247, I/A 139 ( 4.02.16).
10 de Febrero de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA MENENDEZ CESAR. Datos registrales. T 28577 , F 219, S 8, H M 330247, I/A 138 (3.02.16).
12 de Noviembre de 2015Otros conceptos: DON PEDRO PARES RON RENUNCIA A LOS PODERES QUE LE FUERON CONFERIDOS MEDIANTEESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 2&. Datos registrales. T 28577 , F 218, S 8, H M 330247, I/A 137 ( 3.11.15).
08 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: YAÑEZ SEBASTIAN MABEL-MONICA. Datos registrales. T 28577 , F 217, S 8, H M 330247, I/A136 (27.08.15).
07 de Agosto de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: BORREGON BAÑOS JUAN PABLO. Datos registrales. T 28577 , F 217, S 8, H M 330247, I/A 135(30.07.15).
28 de Mayo de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALVAREZ RODRIGUEZ MARCELINO. Datos registrales. T 28577 , F 215, S 8, H M 330247, I/A133 (20.05.15).
Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ RODRIGUEZ MARCELINO. Datos registrales. T 28577 , F 217, S 8, H M 330247, I/A 134(20.05.15).
06 de Abril de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: GORDON GARCIA SALCEDO ALFONSO. Apoderado: GORDON GARCIA SALCEDOALFONSO;GORDON GARCIA SALCEDO ALFONSO. Datos registrales. T 28577 , F 215, S 8, H M 330247, I/A 132 (26.03.15).
06 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ SANCHEZ SALVADOR. Datos registrales. T 28577 , F 209, S 8, H M 330247, I/A 129(25.02.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA MARTIN JUAN. Datos registrales. T 28577 , F 211, S 8, H M 330247, I/A 130 (25.02.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MURCIANO ROSADO MANUEL JESUS;SALAZAR ROMAN ANTONIO MIGUEL. Datos registrales.T 28577 , F 213, S 8, H M 330247, I/A 131 (25.02.15).
23 de Febrero de 2015Reelecciones. Adm. Solid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ JESUS DAVID;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 28577, F 209, S 8, H M 330247, I/A 128 (16.02.15).
19 de Diciembre de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ FERNANDEZ PATRICIA. Datos registrales. T 28577 , F 209, S 8, H M 330247, I/A 127(12.12.14).
17 de Diciembre de 2014Revocaciones. Apoderado: JORDANO PEREZ JUAN BAUTISTA. Datos registrales. T 28577 , F 208, S 8, H M 330247, I/A 126(10.12.14).
09 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28577 , F 208, S 8, H M 330247, I/A 125 ( 1.12.14).
26 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apoderado: PEREZ SANCHO JUAN RAMON. Datos registrales. T 28577 , F 207, S 8, H M 330247, I/A 124(18.11.14).
06 de Octubre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: LAGUNA MARTINEZ FERNANDO. Apo.Manc.: LAGUNA MARTINEZ FERNANDO. Datos registrales. T28577 , F 205, S 8, H M 330247, I/A 123 (29.09.14).
23 de Junio de 2014Nombramientos. Apoderado: BILBAO REY JOSE LUIS;DEL VALLE IÑIGUEZ BEGOÑA;SANCHEZ DIAZ MARIA BELEN;GORDONGARCIA SALCEDO ALFONSO;PEREZ GARIJO JUAN;DE LA HOZ NOMBELA FRANCISCO;SUAREZ GONZALEZ ISIDRO;ARROYOSOUTO MANUEL. Datos registrales. T 28577 , F 205, S 8, H M 330247, I/A 122 (13.06.14).
09 de Junio de 2014Revocaciones. Apoderado: RAMIREZ OCHOA RAQUEL. Datos registrales. T 28577 , F 205, S 8, H M 330247, I/A 121 (30.05.14).
07 de Marzo de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: ADEVA RAMOS JORGE. Datos registrales. T 28577 , F 205, S 8, H M 330247, I/A 120 (27.02.14).
03 de Febrero de 2014Revocaciones. Apoderado: CORREA ALFONSO GEMA. Datos registrales. T 28577 , F 205, S 8, H M 330247, I/A 119 (24.01.14).
29 de Octubre de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: AGUILO VEGA MARIANO. Datos registrales. T 28577 , F 204, S 8, H M 330247, I/A 117 (18.10.13).
Nombramientos. Apoderado: PEREZ GARIJO JUAN ENRIQUE. Datos registrales. T 28577 , F 204, S 8, H M 330247, I/A 118(18.10.13).
05 de Septiembre de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: ROLDAN GARROTE JOAQUIN. Datos registrales. T 28577 , F 204, S 8, H M 330247, I/A 116(28.08.13).
28 de Febrero de 2013Revocaciones. Apoderado: ROBLEDO PLANET JAVIER. Datos registrales. T 28577 , F 204, S 8, H M 330247, I/A 115 (18.02.13).
07 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apoderado: VELASCO RODRIGUEZ RAFAEL. Datos registrales. T 28577 , F 202, S 8, H M 330247, I/A 113(25.10.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VALLADARES GONZALEZ LUCIANO;ELVIRA ESPINOSA GERARDO;ALVAREZ ALVAREZ JOSEMARIA;DEL OLMO TEJERINA JULIO ALBERTO. Datos registrales. T 28577 , F 202, S 8, H M 330247, I/A 114 (25.10.12).
26 de Septiembre de 2012Revocaciones. Apoderado: GARAY AGUIRRE COSME. Datos registrales. T 28577 , F 202, S 8, H M 330247, I/A 112 (18.09.12).
20 de Agosto de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: BARGUEÑO GONZALEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 28577 , F 202, S 8, H M 330247, I/A 111( 8.08.12).
07 de Agosto de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: PINO DURAN ANTONIO RAMON DEL. Datos registrales. T 28577 , F 202, S 8, H M 330247, I/A 110(27.07.12).
29 de Mayo de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: SUAREZ GONZALEZ ISIDRO. Datos registrales. T 28577 , F 200, S 8, H M 330247, I/A 109(16.05.12).
15 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: ROBLEDO PLANET JAVIER. Datos registrales. T 28577 , F 199, S 8, H M 330247, I/A 108 ( 2.03.12).
17 de Octubre de 2011Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28577 , F 199, S 8, H M 330247, I/A 107 ( 3.10.11).
20 de Septiembre de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ CALVO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 28577 , F 197, S 8, H M 330247, I/A 105 (5.09.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VEGA GALLEGO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 28577 , F 197, S 8, H M 330247, I/A 106( 5.09.11).
02 de Junio de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ TOME EDUARDO. Datos registrales. T 28577 , F 195, S 8, H M 330247, I/A 104(23.05.11).
05 de Mayo de 2011Nombramientos. Apoderado: DEL VAL ANTOÑANA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 28577 , F 193, S 8, H M 330247,I/A 103 (15.04.11).
11 de Abril de 2011Nombramientos. Apoderado: CARDENAL PASTOR SONIA. Datos registrales. T 25239 , F 225, S 8, H M 330247, I/A 102(30.03.11).
30 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: TUNDIDOR MIELGO LUIS MARIA. Datos registrales. T 25239 , F 224, S 8, H M 330247, I/A 100(21.12.10).
Nombramientos. Apoderado: ARROYO SOUTO MANUEL. Datos registrales. T 25239 , F 224, S 8, H M 330247, I/A 101 (21.12.10).
21 de Diciembre de 2010Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 25239 , F 224, S 8, H M 330247, I/A 99 (10.12.10).
07 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apoderado: GALLARDO CUBERO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 25239 , F 224, S 8, H M 330247, I/A 98(24.11.10).
27 de Octubre de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: VIDAURRAZAGA GUISASOLA JUAN. Datos registrales. T 25239 , F 224, S 8, H M 330247, I/A 97(15.10.10).
01 de Septiembre de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALVAREZ MEZQUIRIZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 25239 , F 224, S 8, H M 330247, I/A 96(23.08.10).
05 de Agosto de 2010Nombramientos. Apoderado: JORDANO PEREZ JUAN BAUTISTA. Datos registrales. T 25239 , F 217, S 8, H M 330247, I/A 92(27.07.10).
Nombramientos. Apoderado: CAVERO CATALAN OSCAR. Datos registrales. T 25239 , F 219, S 8, H M 330247, I/A 93 (27.07.10).
Nombramientos. Apoderado: MIMBRERO GONZALEZ MARISA. Datos registrales. T 25239 , F 221, S 8, H M 330247, I/A 94(27.07.10).
Nombramientos. Apoderado: LAZARO GARCIA VANESSA;CALONGE ISTURIZ PATRICIA;PULIDO CASTRESANA IDOIA. Datosregistrales. T 25239 , F 222, S 8, H M 330247, I/A 95 (27.07.10).
30 de Julio de 2010Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ DIEZ DAVID. Datos registrales. T 25239 , F 214, S 8, H M 330247, I/A 91 (20.07.10).
07 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ EMILIO;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARTA MARIA. Nombramientos. Adm.Solid.: ALVAREZ MEZQUIRIZ JESUS DAVID;ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 25239 , F 214, S 8, H M330247, I/A 90 (28.06.10).
08 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ CAPARROS LUCIA. Datos registrales. T 25239 , F 213, S 8, H M 330247, I/A 88(24.02.10).
Revocaciones. Apoderado: PATRICIO DOMINGUEZ JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 25239 , F 214, S 8, H M 330247, I/A89 (24.02.10).
01 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: LOMBAN FERNANDEZ TERESA YALAISA. Datos registrales. T 25239 , F 211, S 8, H M 330247, I/A85 (17.02.10).
Nombramientos. Apoderado: LLIN GARCIA ESPERANZA. Datos registrales. T 25239 , F 212, S 8, H M 330247, I/A 86 (17.02.10).
Revocaciones. Apo.Sol.: NAVARRO VIDAL LAURA. Datos registrales. T 25239 , F 213, S 8, H M 330247, I/A 87 (17.02.10).
12 de Enero de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: GUARDIOLA BERGE PEDRO ARTURO. Datos registrales. T 25239 , F 79, S 8, H M 330247, I/A 82(28.12.09).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA ARIAS MARIA LUISA. Datos registrales. T 25239 , F 79, S 8, H M 330247, I/A 83(28.12.09).
08 de Enero de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO FERNANDEZ ISMAEL. Datos registrales. T 25239 , F 81, S 8, H M 330247, I/A 84(28.12.09).
07 de Enero de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: RUFO GOMEZ ANTONIO. Datos registrales. T 25239 , F 78, S 8, H M 330247, I/A 81 (24.12.09).
10 de Diciembre de 2009Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 25239 , F 78, S 8, H M 330247, I/A 80 (27.11.09).
04 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ JIMENEZ ANA ISABEL. Datos registrales. T 25239 , F 78, S 8, H M 330247, I/A 79(23.10.09).
13 de Julio de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MANUEL;CAMEJO MEDINA RITA EMMA. Datos registrales. T25239 , F 76, S 8, H M 330247, I/A 77 ( 1.07.09).
Revocaciones. Apo.Sol.: RAMOS CARRO JOAQUIN. Datos registrales. T 25239 , F 77, S 8, H M 330247, I/A 78 ( 1.07.09).
26 de Mayo de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ CUERVO DERQUI FERNANDO. Datos registrales. T 25239 , F 74, S 8, H M 330247, I/A 76(11.05.09).
30 de Marzo de 2009Revocaciones. Apoderado: SERRA GIBERNAU NARCISO. Datos registrales. T 25239 , F 74, S 8, H M 330247, I/A 75 (18.03.09).
03 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: DE LUCAS LORENZO MARTA. Datos registrales. T 25239 , F 72, S 8, H M 330247, I/A 73 (23.01.09).
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTIN SANCHEZ RAQUEL. Datos registrales. T 25239 , F 74, S 8, H M 330247, I/A 74 (23.01.09).