Actos BORME de Eureca Mayoristas Sl
26 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: CALCAGNI CARINE. Datos registrales. T 44005 , F 4, S 8, H M 770593, I/A 23 (19.10.23).
24 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: SOTO MONTES ROBERTO ENRIQUE;SOTO MONTES ROBERTO ENRIQUE. Apo.Man.Soli: LEGENDRENICOLAS FRANCOIS MICHEL MARIE. Datos registrales. T 44005 , F 4, S 8, H M 770593, I/A 22 (17.10.23).
19 de Julio de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: JIMENEZ MORCILLO JUAN ANTONIO. Nombramientos. Apo.Sol.: LALLANA FERNANDEZ CARLOS.Datos registrales. T 44005 , F 3, S 8, H M 770593, I/A 21 (12.07.23).
07 de Junio de 2023Nombramientos. Apo.Manc.: BLAZQUEZ SANZ DANIEL. Datos registrales. T 44005 , F 3, S 8, H M 770593, I/A 20 (31.05.23).
02 de Diciembre de 2022Cambio de domicilio social. C/ CAMPEZO 1 - POLIGONO INDUSTRIAL "LAS MERCEDES" (MADRID). Datos registrales. T 44005, F 3, S 8, H M 770593, I/A 19 (25.11.22).
23 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: LEGENDRE NICOLAS FRANCOIS MICHEL MARIE;SKWARA PATRICK PHILIPPE. Datosregistrales. T 44005 , F 1, S 8, H M 770593, I/A 18 (16.11.22).
17 de Noviembre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DE PALMAS ALEXANDRE MARIE MAXIME. Nombramientos. Adm. Unico: LAFFONT DECOLONGES GUILLAUME JACQUES EDGARD. Datos registrales. T 44005 , F 1, S 8, H M 770593, I/A 17 ( 8.11.22).
21 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apoderado: RIEGO VILA JUAN-FRANCISCO;TORRES MORA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 43652 , F139, S 8, H M 770593, I/A 16 (14.09.22).
08 de Julio de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: SOTO MONTES ROBERTO ENRIQUE. Datos registrales. T 43652 , F 136, S 8, H M 770593, I/A 10 (1.07.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANTANA SANCHEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 43652 , F 136, S 8, H M 770593, I/A 11 (1.07.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: BAEZ BERNAL LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 43652 , F 137, S 8, H M 770593, I/A 12 ( 1.07.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: AGUILAR GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 43652 , F 138, S 8, H M 770593, I/A 13 ( 1.07.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: VEYRIER JULIEN PAUL ANDRE. Datos registrales. T 43652 , F 138, S 8, H M 770593, I/A 14 (1.07.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: TORRES MORA JOSE MANUEL;MARTIN JIMENEZ MARIA ELENA;GIBELLO SAIZ JOSEANTONIO;HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN RAMON;SANCHEZ LAGUNA YOLANDA;SANCHEZ FERNANDEZ JUANANTONIO;FERNANDEZ CASAL RICARDO;SOTO MONTES ROBERTO ENRIQUE;MOLLA MENDEZ JOSE FRANCISCO. Datosregistrales. T 43652 , F 139, S 8, H M 770593, I/A 15 ( 1.07.22).
07 de Julio de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN JIMENEZ MARIA ELENA. Apo.Manc.: MARTIN JIMENEZ MARIA ELENA. Datos registrales. T43652 , F 131, S 8, H M 770593, I/A 2 (30.06.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: NU脩EZ ACOSTA DIEGO;SI脩ERIZ MENDEZ JAVIER. Apo.Sol.: NU脩EZ ACOSTA DIEGO;SI脩ERIZMENDEZ JAVIER. Datos registrales. T 43652 , F 132, S 8, H M 770593, I/A 3 (30.06.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN RAMON;DE LAS HERAS ESCUDERO ROCIO. Apo.Sol.:HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN RAMON;DE LAS HERAS ESCUDERO ROCIO. Datos registrales. T 43652 , F 133, S 8, H M770593, I/A 4 (30.06.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: VEYRIER JULIEN PAUL ANDRE. Datos registrales. T 43652 , F 133, S 8, H M 770593, I/A 5 (30.06.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ LAGUNA YOLANDA. Datos registrales. T 43652 , F 134, S 8, H M 770593, I/A 6 (30.06.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO;JIMENEZ MORCILLO JUAN ANTONIO. Datos registrales. T
Nombramientos. Apo.Sol.: MOLLA MENDEZ JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 43652 , F 135, S 8, H M 770593, I/A 8(30.06.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: YBARRA LORING JORGE. Datos registrales. T 43652 , F 135, S 8, H M 770593, I/A 9 (30.06.22).
16 de Junio de 2022Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 25.05.22. Objeto social: la actividad de central de compras y en particular la negociaci贸n,adquisici贸n y prestaci贸n de servicios de suministro de todo tipo de productos y mercanc铆as (incluyendo, entre otros, productosalimentarios, equipamiento, bienes materiales y bienes inmateriales), por cuenta propia o de terceros;. Domicilio: CTRA DE BURGOSKm 14.500 - EDIFICIO DE OFICINAS (ALCOBENDAS). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico:CARREFOUR NEDERLAND BV. Nombramientos. Adm. Unico: DE PALMAS ALEXANDRE MARIE MAXIME. Datos registrales. T43652 , F 130, S 8, H M 770593, I/A 1 ( 9.06.22).