Actos BORME de Euro-cargo Express Sa
06 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: SILVESTRE LLEDO JOSE JOAQUIN. Nombramientos. Con.Delegado: SILVESTRE LLEDOJOSE JOAQUIN. Reelecciones. Consejero: SILVESTRE LLEDO JOSE JOAQUIN;PARAVANI CARLO;VIDAL JEREZ CARLOSJOSE. Presidente: SILVESTRE LLEDO JOSE JOAQUIN. Secretario: VIDAL JEREZ CARLOS JOSE. Datos registrales. T 3741 , F139, S 8, H A 42935, I/A 28 (27.01.23).
10 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: AUDIMER AUDIT PARTNERS SL. Datos registrales. T 3741 , F 139, S 8, H A 42935, I/A 27 (30.11.21).
31 de Enero de 2019Nombramientos. Auditor: AUDIMER AUDIT PARTNERS SL. Datos registrales. T 3741 , F 139, S 8, H A 42935, I/A 26 (23.01.19).
26 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SILVESTRE VIDAL ALEJANDRO;SILVESTRE VIDAL JOSE JOAQUIN;GINER GUTIERREZVALENTIN;MENDEZ GERMAIN JORGE LUIS. Datos registrales. T 3741 , F 138, S 8, H A 42935, I/A 25 (16.02.18).
15 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: SILVESTRE LLEDO JOSE JOAQUIN. Nombramientos. Con.Delegado: SILVESTRE LLEDOJOSE JOAQUIN. Reelecciones. Consejero: SILVESTRE LLEDO JOSE JOAQUIN;PARAVANI CARLO;VIDAL JEREZ CARLOSJOSE. Presidente: SILVESTRE LLEDO JOSE JOAQUIN. Secretario: VIDAL JEREZ CARLOS JOSE. Datos registrales. T 3741 , F138, S 8, H A 42935, I/A 24 ( 5.12.17).
17 de Agosto de 2016Reelecciones. Auditor: GONZALVEZ CERDA ANDRES. Datos registrales. T 3741 , F 138, S 8, H A 42935, I/A 23 ( 8.08.16).
07 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ MU脩OZ FELIPE. Datos registrales. T 3741 , F 138, S 8, H A 42935, I/A 22 (28.09.15).
16 de Enero de 2014Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ FAMILIAR JOSE LUIS. Datos registrales. T 3741 , F 138, S 8, H A 42935, I/A 21 ( 8.01.14).
15 de Enero de 2014Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SILPASAVI SL. Datos registrales. T 2281 , F 174, S 8, H A 42935, I/A 20 ( 7.01.14).
07 de Mayo de 2013Reelecciones. Auditor: GONZALVEZ CERDA ANDRES. Datos registrales. T 2281 , F 174, S 8, H A 42935, I/A 19 (25.04.13).
06 de Mayo de 2013Otros conceptos: Rectificada la inscripci贸n 16& en el sentido que el nombramiento del Auditor DON ANDRES GONZALVEZ CERDA,se hizo por plazo de tres a帽os, para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.- Datos registrales. T 2281 , F 174, S 8, H A 42935, I/A 18(24.04.13).
21 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: SILVESTRE LLEDO JOSE JOAQUIN. Nombramientos. Con.Delegado: SILVESTRE LLEDOJOSE JOAQUIN. Reelecciones. Consejero: SILVESTRE LLEDO JOSE JOAQUIN;PARAVANI CARLO;SANCHEZ MU脩OZFELIPE;VIDAL JEREZ CARLOS JOSE. Presidente: SILVESTRE LLEDO JOSE JOAQUIN. Secretario: VIDAL JEREZ CARLOS JOSE.Datos registrales. T 2281 , F 174, S 8, H A 42935, I/A 17 (13.12.12).
22 de Abril de 2010Nombramientos. Auditor: GONZALVEZ CERDA ANDRES. Datos registrales. T 2281 , F 174, S 8, H A 42935, I/A 16 (12.04.10).
10 de Marzo de 2009Cambio de domicilio social. C/ ISLES BALEARS, 3 - POLIGONO INDUSTRIAL EL PASTO (MONOVAR). Datos registrales. T 2281, F 174, S 8, H A 42935, I/A 15 (25.02.09).
23 de Enero de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 350.623,40 Euros. Desembolsado: 350.623,40 Euros. Resultante Suscrito: 601.060,10 Euros.Resultante Desembolsado: 601.060,10 Euros. Datos registrales. T 2281 , F 173, S 8, H A 42935, I/A 14 (12.01.09).