Buscador CIF Logo

Actos BORME Eurofins Latin American Ventures Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Eurofins Latin American Ventures Sl

Actos BORME Eurofins Latin American Ventures Sl - B65046344

Tenemos registrados 38 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Eurofins Latin American Ventures Sl con CIF B65046344

馃敊 Perfil de Eurofins Latin American Ventures Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Eurofins Latin American Ventures Sl

23 de Noviembre de 2023
Nombramientos. CONSEJERO: GABRIEL JEROME JULIA. Datos registrales. T 47461 , F 178, S 8, H B 377304, I/A 41 (15.11.23).

23 de Junio de 2023
Revocaciones. APODERAD.SOL: BALCELLS MU脩OZ JORDI;JESUS DANIEL FERNANDEZ. APOD.MANCOMU: JESUS DANIELFERNANDEZ;LUCA SALVI;GOMEZ AREVALILLO MAGAN MARIA ISABEL;ALONSO SANTIN JOSE ALFREDO;FABREGAT PEREZMARIA DOLORES;ALEMAN VILLARROEL FABIOLA ANDREA;HERNANDEZ HIDALGO DAVID. APOD.SOL/MAN: SERVIAN RUIZELENA. APODERAD.SOL: RUSI脩OL VILA BERTA. Datos registrales. T 47461 , F 175, S 8, H B 377304, I/A 39 (15.06.23).

Nombramientos. APOD.MANCOMU: IRIBARNE PUGA LAURA;ALONSO SANTIN JOSE ALFREDO;ALEMAN VILLARROELFABIOLA ANDREA;HERNANDEZ HIDALGO DAVID;FABREGAT PEREZ MARIA DOLORES. APOD.SOL/MAN: CERDA DALMAUCARLOTA;BLANCO GUARDADO PEDRO EDMUNDO;SERVIAN RUIZ ELENA. APODERAD.SOL: VAQUERO GUTIERREZ MARIAAROA. Datos registrales. T 47461 , F 175, S 8, H B 377304, I/A 40 (15.06.23).

11 de Abril de 2023
Nombramientos. CONSEJERO: PIETER DE MAESENEER. Datos registrales. T 47461 , F 174, S 8, H B 377304, I/A 37 (30.03.23).

Revocaciones. CONS.DEL.SOL: FERNANDEZ ARMAS RAMON. Nombramientos. CONSEJERO: IRIBARNE PUGA LAURA.CONS.DEL.SOL: IRIBARNE PUGA LAURA. Datos registrales. T 47461 , F 175, S 8, H B 377304, I/A 38 (30.03.23).

22 de Marzo de 2023
Revocaciones. CONSEJERO: GOMEZ AREVALILLO MAGAN MARIA ISABEL. SECRETARIO: GOMEZ AREVALILLO MAGANMARIA ISABEL. CONS.DEL.SOL: GOMEZ AREVALILLO MAGAN MARIA ISABEL. Nombramientos. SECR.NO CONS: BLANCOGUARDADO PEDRO EDMUNDO. CONS.DEL.SOL: FERNANDEZ ARMAS RAMON. Datos registrales. T 47461 , F 174, S 8, H B377304, I/A 36 (13.03.23).

04 de Mayo de 2022
Revocaciones. CONSEJERO: YVES LOIC JEAN MICHEL MARTIN. Datos registrales. T 47461 , F 174, S 8, H B 377304, I/A 35(25.04.22).

14 de Enero de 2022
Nombramientos. CONSEJERO: FERNANDEZ ARMAS RAMON. Datos registrales. T 47461 , F 174, S 8, H B 377304, I/A 34 (7.01.22).

23 de Abril de 2021
Revocaciones. CONSEJERO: DIRK FRANCOIS E BONTRIDDER. Datos registrales. T 47461 , F 173, S 8, H B 377304, I/A 33(15.04.21).

25 de Marzo de 2021
Revocaciones. CONSEJERO: HUGUES PIERRE MARIE VAUSSY. Datos registrales. T 47461 , F 173, S 8, H B 377304, I/A 32(15.03.21).

17 de Febrero de 2021
Revocaciones. CONSEJERO: KOEN FRANS J VAN LOOCK. Datos registrales. T 47461 , F 173, S 8, H B 377304, I/A 31 (9.02.21).

28 de Octubre de 2020
Revocaciones. CONSEJERO: JESUS DANIEL FERNANDEZ. SECRETARIO: JESUS DANIEL FERNANDEZ. CONS.DEL.SOL:JESUS DANIEL FERNANDEZ. Nombramientos. CONSEJERO: LAURENT LEBRAS;YVOINE SOPHIE MCCORT;GOMEZAREVALILLO MAGAN MARIA ISABEL. SECRETARIO: GOMEZ AREVALILLO MAGAN MARIA ISABEL. CONS.DEL.SOL: GOMEZAREVALILLO MAGAN MARIA ISABEL. Datos registrales. T 45970 , F 26, S 8, H B 377304, I/A 29 (20.10.20).

Nombramientos. APOD.MANCOMU: GOMEZ AREVALILLO MAGAN MARIA ISABEL;ALONSO SANTIN JOSEALFREDO;FABREGAT PEREZ MARIA DOLORES;ALEMAN VILLARROEL FABIOLA ANDREA;HERNANDEZ HIDALGO DAVID.APOD.SOL/MAN: SERVIAN RUIZ ELENA. APODERAD.SOL: RUSI脩OL VILA BERTA. Datos registrales. T 47461 , F 171, S 8, H B377304, I/A 30 (20.10.20).

17 de Abril de 2020
Ampliaci贸n de capital. Capital: 8.964.696,00 Euros. Resultante Suscrito: 35.010.314,00 Euros. Datos registrales. T 45970 , F 26, S8, H B 377304, I/A 28 (30.03.20).

29 de Enero de 2020
Revocaciones. SECR.NO CONS: JESUS DANIEL FERNANDEZ. Nombramientos. CONSEJERO: DIRK FRANCOIS EBONTRIDDER;JESUS DANIEL FERNANDEZ. SECRETARIO: JESUS DANIEL FERNANDEZ. CONS.DEL.SOL: JESUS DANIELFERNANDEZ. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 20.- CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 45970 , F 25,S 8, H B 377304, I/A 27 (21.01.20).

29 de Marzo de 2019
Nombramientos. CONSEJERO: KOEN FRANS J VAN LOOCK. Datos registrales. T 45970 , F 25, S 8, H B 377304, I/A 26(21.03.19).

07 de Marzo de 2019
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.020.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 26.045.618,00 Euros. Datos registrales. T 42057 , F 110,S 8, H B 377304, I/A 25 (27.02.19).

29 de Agosto de 2018
Ampliaci贸n de capital. Capital: 14.220.658,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.025.618,00 Euros. Datos registrales. T 42057 , F 110,S 8, H B 377304, I/A 24 (21.08.18).

26 de Enero de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 14.009.940,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.980.960,00 Euros. Ampliaci贸n de capital.

18 de Enero de 2018
Revocaciones. CONS. DELEG.: VALERIE ANNE MARIE HANOTE;LUCA COZZANI;GILLES MARTIN;HUGUES PIERRE MARIEVAUSSY. Nombramientos. APOD.MANCOMU: JESUS DANIEL FERNANDEZ;LUCA SALVI. Modificaci贸n de poderes.APODERAD.SOL: JESUS DANIEL FERNANDEZ. Datos registrales. T 42057 , F 108, S 8, H B 377304, I/A 21 (10.01.18).

Nombramientos. CONSEJERO: YVES LOIC JEAN MICHEL MARTIN. Datos registrales. T 42057 , F 109, S 8, H B 377304, I/A 22(10.01.18).

04 de Julio de 2016
Nombramientos. CONSEJERO: VALERIE ANNE MARIE HANOTE. CONS. DELEG.: VALERIE ANNE MARIE HANOTE;LUCACOZZANI;GILLES MARTIN;HUGUES PIERRE MARIE VAUSSY. Datos registrales. T 42057 , F 108, S 8, H B 377304, I/A 20(23.06.16).

18 de Agosto de 2015
Revocaciones. SECR.NO CONS: BALCELLS MU脩OZ JORDI. Nombramientos. SECR.NO CONS: JESUS DANIEL FERNANDEZ.Datos registrales. T 42057 , F 107, S 8, H B 377304, I/A 18 (10.08.15).

Revocaciones. APODERADO: LUCA SALVI. Nombramientos. APODERAD.SOL: JESUS DANIEL FERNANDEZ. Datosregistrales. T 42057 , F 107, S 8, H B 377304, I/A 19 (10.08.15).

09 de Junio de 2015
Cambio de domicilio social. CL JOSEP ARGEMI,13-15 (ESPLUGUES DE LLOBREGAT). Datos registrales. T 42057 , F 107, S 8,H B 377304, I/A 17 (27.05.15).

03 de Febrero de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 17.990.900,00 Euros. Datos registrales. T 42057 , F 106,S 8, H B 377304, I/A 16 (26.01.15).

04 de Septiembre de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 6.400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 16.790.900,00 Euros. Datos registrales. T 42057 , F 106,S 8, H B 377304, I/A 15 (27.08.14).

04 de Junio de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 870.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.390.900,00 Euros. Datos registrales. T 42057 , F 105, S8, H B 377304, I/A 14 (27.05.14).

22 de Mayo de 2014
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: LUCA COZZANI;HUGUES PIERRE MARIE VAUSSY;GILLES MARTIN. Nombramientos.CONSEJERO: LUCA COZZANI. PRESIDENTE: LUCA COZZANI. CONSEJERO: GILLES MARTIN;HUGUES PIERRE MARIEVAUSSY. SECR.NO CONS: BALCELLS MU脩OZ JORDI. APODERAD.SOL: BALCELLS MU脩OZ JORDI. Datos registrales. T 42057 ,F 105, S 8, H B 377304, I/A 13 (13.05.14).

04 de Noviembre de 2013
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.737.900,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.520.900,00 Euros. Datos registrales. T 42057 , F 104, S8, H B 377304, I/A 12 (23.10.13).

18 de Julio de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.562.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.783.000,00 Euros. Datos registrales. T 42057 , F 103, S8, H B 377304, I/A 11 ( 5.07.12).

30 de Abril de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.821.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.221.000,00 Euros. Datos registrales. T 42057 , F 102, S8, H B 377304, I/A 10 (18.04.12).

03 de Abril de 2012
Otros conceptos: CAMBIO DE SOCIO UNICO.NUEVO SOCIO UNICO:EUROFINS INTERNATIONAL HOLDINGS LUX,SOCIETE ARESPONSABILICE LIMITEE. Datos registrales. T 42057 , F 102, S 8, H B 377304, I/A 9 (22.03.12).

10 de Agosto de 2011
Modificaciones estatutarias. ART.19:DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. Datosregistrales. T 42057 , F 102, S 8, H B 377304, I/A 8 (29.07.11).

26 de Julio de 2011
Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: GILLES MARTIN. Datos registrales. T 42057 , F 102, S 8, H B 377304, I/A 7 (13.07.11).

30 de Agosto de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 396.994,00 Euros. Resultante Suscrito: 400.000,00 Euros. Datos registrales. T 42057 , F 101, S 8,H B 377304, I/A 6 (17.08.10).

22 de Febrero de 2010
Nombramientos. APODERADO: LUCA SALVI. Datos registrales. T 41054 , F 23, S 8, H B 377304, I/A 4 ( 9.02.10).

Otros conceptos: SOCIEDAD UNIPERSONAL,SOCIO UNICO:"EUROFINS LUX,SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE". Datosregistrales. T 41054 , F 24, S 8, H B 377304, I/A 5 ( 9.02.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n