Actos BORME de Europa Muebles Sl
02 de Septiembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: VAZQUEZ FERRO GERMAN;ALVAREZ ALONSO MANUEL;SAN JOSE TORRES PEDRO;DE VEGAVEGA AGUSTIN;RUIZ FRANCO ROGELIO. Presidente: VAZQUEZ FERRO GERMAN. Vicepresid.: ALVAREZ ALONSO MANUEL.Secretario: SAN JOSE TORRES PEDRO. Vicesecret.: DE VEGA VEGA AGUSTIN. Co.De.Ma.So: ALVAREZ ALONSOMANUEL;VAZQUEZ FERRO GERMAN;RUIZ FRANCO ROGELIO;DE VEGA VEGA AGUSTIN;SAN JOSE TORRES PEDRO.Nombramientos. Consejero: ALVAREZ ALONSO MANUEL;VAZQUEZ FERRO GERMAN;SAN JOSE TORRES PEDRO;ROMEROILLESCAS RICARDO;HERREROS IZQUIERDO LEYRE. Presidente: VAZQUEZ FERRO GERMAN. Vicepresid.: ALVAREZ ALONSOMANUEL. Secretario: SAN JOSE TORRES PEDRO. Vicesecret.: ROMERO ILLESCAS RICARDO. Co.De.Ma.So: ROMEROILLESCAS RICARDO;ALVAREZ ALONSO MANUEL;VAZQUEZ FERRO GERMAN;HERREROS IZQUIERDO LEYRE;SAN JOSETORRES PEDRO. Datos registrales. T 26257 , F 96, S 8, H M 220517, I/A 35 (27.08.22).
14 de Noviembre de 2019Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio social . Cambio de domicilio social. AVDA PIRINEOS 7 (SANSEBASTIAN DE LOS REYES). Datos registrales. T 26257 , F 96, S 8, H M 220517, I/A 34 ( 7.11.19).
10 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apoderado: BENITO SANCHEZ JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: TREMIN GUILLEN SANTIAGO;PEREZCENTURION MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 26257 , F 95, S 8, H M 220517, I/A 33 (31.10.17).
10 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: DE VEGA VEGA AGUSTIN. Vicesecret.: DE VEGA VEGA AGUSTIN. Consejero: ALVAREZ ALONSOMANUEL. Vicepresid.: ALVAREZ ALONSO MANUEL. Consejero: VAZQUEZ FERRO GERMAN. Presidente: VAZQUEZ FERROGERMAN. Consejero: RUIZ FRANCO ROGELIO;SAN JOSE TORRES PEDRO. Secretario: SAN JOSE TORRES PEDRO.Co.De.Ma.So: DE VEGA VEGA AGUSTIN;ALVAREZ ALONSO MANUEL;VAZQUEZ FERRO GERMAN;RUIZ FRANCOROGELIO;SAN JOSE TORRES PEDRO. Nombramientos. Consejero: VAZQUEZ FERRO GERMAN;ALVAREZ ALONSOMANUEL;SAN JOSE TORRES PEDRO;DE VEGA VEGA AGUSTIN;RUIZ FRANCO ROGELIO. Presidente: VAZQUEZ FERROGERMAN. Vicepresid.: ALVAREZ ALONSO MANUEL. Secretario: SAN JOSE TORRES PEDRO. Vicesecret.: DE VEGA VEGAAGUSTIN. Co.De.Ma.So: ALVAREZ ALONSO MANUEL;VAZQUEZ FERRO GERMAN;RUIZ FRANCO ROGELIO;DE VEGA VEGAAGUSTIN;SAN JOSE TORRES PEDRO. Datos registrales. T 26257 , F 94, S 8, H M 220517, I/A 32 ( 3.08.17).
21 de Junio de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 216.299,90 Euros. Resultante Suscrito: 2.617.565,35 Euros. Datos registrales. T 26257 ,F 94, S 8, H M 220517, I/A 31 ( 9.06.17).
09 de Enero de 2017Revocaciones. Apoderado: AURIN LLEIDA JAVIER. Apo.Manc.: AURIN LLEIDA JAVIER. Datos registrales. T 26257 , F 93, S 8, HM 220517, I/A 30 (29.12.16).
26 de Octubre de 2016Nombramientos. Apoderado: BENITO SANCHEZ JAVIER. Datos registrales. T 26257 , F 93, S 8, H M 220517, I/A 29 (18.10.16).
28 de Marzo de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: ARANZANA BERNAL JOAQUIN. Datos registrales. T 26257 , F 93, S 8, H M 220517, I/A 28 (21.03.14).
23 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: GUNDIN FANDI脩O EMILIO. Co.De.Ma.So: GUNDIN FANDI脩O EMILIO. Datos registrales. T 26257 ,F 92, S 8, H M 220517, I/A 27 (16.08.13).
24 de Septiembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ ALONSO MANUEL. Vicepresid.: ALVAREZ ALONSO MANUEL. Consejero: GUNDINFANDI脩O EMILIO. Secretario: GUNDIN FANDI脩O EMILIO. Consejero: SAN JOSE TORRES PEDRO. Vicesecret.: SAN JOSETORRES PEDRO. Consejero: DE VEGA VEGA AGUSTIN;VAZQUEZ FERRO GERMAN;RUIZ FRANCO ROGELIO. Co.De.Ma.So:GUNDIN FANDI脩O EMILIO;SAN JOSE TORRES PEDRO;DE VEGA VEGA AGUSTIN;ALVAREZ ALONSO MANUEL;VAZQUEZFERRO GERMAN;RUIZ FRANCO ROGELIO. Presidente: VAZQUEZ FERRO GERMAN. Nombramientos. Consejero: GUNDINFANDI脩O EMILIO;DE VEGA VEGA AGUSTIN. Vicesecret.: DE VEGA VEGA AGUSTIN. Consejero: ALVAREZ ALONSO MANUEL.Vicepresid.: ALVAREZ ALONSO MANUEL. Consejero: VAZQUEZ FERRO GERMAN. Presidente: VAZQUEZ FERRO GERMAN.Consejero: RUIZ FRANCO ROGELIO;SAN JOSE TORRES PEDRO. Secretario: SAN JOSE TORRES PEDRO. Co.De.Ma.So:GUNDIN FANDI脩O EMILIO;DE VEGA VEGA AGUSTIN;ALVAREZ ALONSO MANUEL;VAZQUEZ FERRO GERMAN;RUIZ FRANCOROGELIO;SAN JOSE TORRES PEDRO. Datos registrales. T 26257 , F 92, S 8, H M 220517, I/A 26 (31.08.12).
25 de Febrero de 2011Nombramientos. Auditor: ARROYO LEMUS MANUEL MARIA. Aud.Supl.: PAYER RAMIREZ LUIS ANDRES. Datos registrales. T26257 , F 91, S 8, H M 220517, I/A 25 (15.02.11).
28 de Enero de 2010Cambio de domicilio social. POLIG 30 C, PARCELA 8, CALLE CARLOS JIMENEZ DIAZ S (ALCALA DE HENARES). Datos
07 de Mayo de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: ARANZANA BERNAL JOAQUIN;AURIN LLEIDA JAVIER. Datos registrales. T 16566 , F 124, S 8, H M220517, I/A 23 (21.04.09).
14 de Enero de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: ERICE KEPPLER ALBERTO. Presidente: ERICE KEPPLER ALBERTO. Co.De.Ma.So: ERICEKEPPLER ALBERTO. Nombramientos. Presidente: VAZQUEZ FERRO GERMAN. Datos registrales. T 16566 , F 124, S 8, H M220517, I/A 22 (30.12.08).