Buscador CIF Logo

Actos BORME Europa Muebles Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Europa Muebles Sl

Actos BORME Europa Muebles Sl - B50104439

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Europa Muebles Sl con CIF B50104439

馃敊 Perfil de Europa Muebles Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Europa Muebles Sl

02 de Septiembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: VAZQUEZ FERRO GERMAN;ALVAREZ ALONSO MANUEL;SAN JOSE TORRES PEDRO;DE VEGAVEGA AGUSTIN;RUIZ FRANCO ROGELIO. Presidente: VAZQUEZ FERRO GERMAN. Vicepresid.: ALVAREZ ALONSO MANUEL.Secretario: SAN JOSE TORRES PEDRO. Vicesecret.: DE VEGA VEGA AGUSTIN. Co.De.Ma.So: ALVAREZ ALONSOMANUEL;VAZQUEZ FERRO GERMAN;RUIZ FRANCO ROGELIO;DE VEGA VEGA AGUSTIN;SAN JOSE TORRES PEDRO.Nombramientos. Consejero: ALVAREZ ALONSO MANUEL;VAZQUEZ FERRO GERMAN;SAN JOSE TORRES PEDRO;ROMEROILLESCAS RICARDO;HERREROS IZQUIERDO LEYRE. Presidente: VAZQUEZ FERRO GERMAN. Vicepresid.: ALVAREZ ALONSOMANUEL. Secretario: SAN JOSE TORRES PEDRO. Vicesecret.: ROMERO ILLESCAS RICARDO. Co.De.Ma.So: ROMEROILLESCAS RICARDO;ALVAREZ ALONSO MANUEL;VAZQUEZ FERRO GERMAN;HERREROS IZQUIERDO LEYRE;SAN JOSETORRES PEDRO. Datos registrales. T 26257 , F 96, S 8, H M 220517, I/A 35 (27.08.22).

14 de Noviembre de 2019
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio social . Cambio de domicilio social. AVDA PIRINEOS 7 (SANSEBASTIAN DE LOS REYES). Datos registrales. T 26257 , F 96, S 8, H M 220517, I/A 34 ( 7.11.19).

10 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: BENITO SANCHEZ JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: TREMIN GUILLEN SANTIAGO;PEREZCENTURION MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 26257 , F 95, S 8, H M 220517, I/A 33 (31.10.17).

10 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE VEGA VEGA AGUSTIN. Vicesecret.: DE VEGA VEGA AGUSTIN. Consejero: ALVAREZ ALONSOMANUEL. Vicepresid.: ALVAREZ ALONSO MANUEL. Consejero: VAZQUEZ FERRO GERMAN. Presidente: VAZQUEZ FERROGERMAN. Consejero: RUIZ FRANCO ROGELIO;SAN JOSE TORRES PEDRO. Secretario: SAN JOSE TORRES PEDRO.Co.De.Ma.So: DE VEGA VEGA AGUSTIN;ALVAREZ ALONSO MANUEL;VAZQUEZ FERRO GERMAN;RUIZ FRANCOROGELIO;SAN JOSE TORRES PEDRO. Nombramientos. Consejero: VAZQUEZ FERRO GERMAN;ALVAREZ ALONSOMANUEL;SAN JOSE TORRES PEDRO;DE VEGA VEGA AGUSTIN;RUIZ FRANCO ROGELIO. Presidente: VAZQUEZ FERROGERMAN. Vicepresid.: ALVAREZ ALONSO MANUEL. Secretario: SAN JOSE TORRES PEDRO. Vicesecret.: DE VEGA VEGAAGUSTIN. Co.De.Ma.So: ALVAREZ ALONSO MANUEL;VAZQUEZ FERRO GERMAN;RUIZ FRANCO ROGELIO;DE VEGA VEGAAGUSTIN;SAN JOSE TORRES PEDRO. Datos registrales. T 26257 , F 94, S 8, H M 220517, I/A 32 ( 3.08.17).

21 de Junio de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 216.299,90 Euros. Resultante Suscrito: 2.617.565,35 Euros. Datos registrales. T 26257 ,F 94, S 8, H M 220517, I/A 31 ( 9.06.17).

09 de Enero de 2017
Revocaciones. Apoderado: AURIN LLEIDA JAVIER. Apo.Manc.: AURIN LLEIDA JAVIER. Datos registrales. T 26257 , F 93, S 8, HM 220517, I/A 30 (29.12.16).

26 de Octubre de 2016
Nombramientos. Apoderado: BENITO SANCHEZ JAVIER. Datos registrales. T 26257 , F 93, S 8, H M 220517, I/A 29 (18.10.16).

28 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: ARANZANA BERNAL JOAQUIN. Datos registrales. T 26257 , F 93, S 8, H M 220517, I/A 28 (21.03.14).

23 de Agosto de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUNDIN FANDI脩O EMILIO. Co.De.Ma.So: GUNDIN FANDI脩O EMILIO. Datos registrales. T 26257 ,F 92, S 8, H M 220517, I/A 27 (16.08.13).

24 de Septiembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ ALONSO MANUEL. Vicepresid.: ALVAREZ ALONSO MANUEL. Consejero: GUNDINFANDI脩O EMILIO. Secretario: GUNDIN FANDI脩O EMILIO. Consejero: SAN JOSE TORRES PEDRO. Vicesecret.: SAN JOSETORRES PEDRO. Consejero: DE VEGA VEGA AGUSTIN;VAZQUEZ FERRO GERMAN;RUIZ FRANCO ROGELIO. Co.De.Ma.So:GUNDIN FANDI脩O EMILIO;SAN JOSE TORRES PEDRO;DE VEGA VEGA AGUSTIN;ALVAREZ ALONSO MANUEL;VAZQUEZFERRO GERMAN;RUIZ FRANCO ROGELIO. Presidente: VAZQUEZ FERRO GERMAN. Nombramientos. Consejero: GUNDINFANDI脩O EMILIO;DE VEGA VEGA AGUSTIN. Vicesecret.: DE VEGA VEGA AGUSTIN. Consejero: ALVAREZ ALONSO MANUEL.Vicepresid.: ALVAREZ ALONSO MANUEL. Consejero: VAZQUEZ FERRO GERMAN. Presidente: VAZQUEZ FERRO GERMAN.Consejero: RUIZ FRANCO ROGELIO;SAN JOSE TORRES PEDRO. Secretario: SAN JOSE TORRES PEDRO. Co.De.Ma.So:GUNDIN FANDI脩O EMILIO;DE VEGA VEGA AGUSTIN;ALVAREZ ALONSO MANUEL;VAZQUEZ FERRO GERMAN;RUIZ FRANCOROGELIO;SAN JOSE TORRES PEDRO. Datos registrales. T 26257 , F 92, S 8, H M 220517, I/A 26 (31.08.12).

25 de Febrero de 2011
Nombramientos. Auditor: ARROYO LEMUS MANUEL MARIA. Aud.Supl.: PAYER RAMIREZ LUIS ANDRES. Datos registrales. T26257 , F 91, S 8, H M 220517, I/A 25 (15.02.11).

28 de Enero de 2010
Cambio de domicilio social. POLIG 30 C, PARCELA 8, CALLE CARLOS JIMENEZ DIAZ S (ALCALA DE HENARES). Datos

07 de Mayo de 2009
Nombramientos. Apo.Manc.: ARANZANA BERNAL JOAQUIN;AURIN LLEIDA JAVIER. Datos registrales. T 16566 , F 124, S 8, H M220517, I/A 23 (21.04.09).

14 de Enero de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: ERICE KEPPLER ALBERTO. Presidente: ERICE KEPPLER ALBERTO. Co.De.Ma.So: ERICEKEPPLER ALBERTO. Nombramientos. Presidente: VAZQUEZ FERRO GERMAN. Datos registrales. T 16566 , F 124, S 8, H M220517, I/A 22 (30.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n