Actos BORME de Europea De Asfaltos Sa
06 de Noviembre de 2014Extinci贸n. Datos registrales. T 43725 , F 33, S 8, H B 86773, I/A 73 (29.10.14).
04 de Septiembre de 2014Revocaciones. APODERADO: TORRES TORRAS ALBERTO. Datos registrales. T 43725 , F 33, S 8, H B 86773, I/A 72 (27.08.14).
13 de Marzo de 2014Revocaciones. APODERADO: DAROCA ABAD GENARO;SANTOLARIA SOLANO ANTONIO DOMINGO. Datos registrales. T43725 , F 33, S 8, H B 86773, I/A 71 ( 5.03.14).
03 de Junio de 2013Otros conceptos: SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: "PAVIMENTOS BARCELONA SA". Datos registrales. T 43725 , F33, S 8, H B 86773, I/A 70 (24.05.13).
07 de Mayo de 2013Cambio de domicilio social. CL DE LAS NAVAS DE TOLOSA Num.161 (TERRASSA). Datos registrales. T 43725 , F 32, S 8, H B86773, I/A 69 (22.04.13).
27 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: BARRIOS VALLECILLO TOMAS. Apo.Sol.: BARRIOS VALLECILLO TOMAS. Datos registrales. T 1550, F 89, S 8, H TO 25612, I/A 29 (15.11.12).
28 de Septiembre de 2012Reelecciones. Adm. Unico: COPCISA INDUSTRIAL SL. Datos registrales. T 1500 , F 42, S 8, H TO 25612, I/A 27 (17.09.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: TORRES TORRAS ALBERTO. Apo.Manc.: TORRES TORRAS ALBERTO. Apo.Sol.: PALOMOGONZALEZ SEBASTIAN. Apo.Manc.: PALOMO GONZALEZ SEBASTIAN. Datos registrales. T 1500 , F 42, S 8, H TO 25612, I/A 28(17.09.12).
30 de Agosto de 2012Revocaciones. Apoderado: MORENO LASALLE LLUIS JOSEP. Apo.Man.Soli: MORENO LASALLE LLUIS JOSEP. Datosregistrales. T 1500 , F 42, S 8, H TO 25612, I/A 26 (20.08.12).
28 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: ENFEDAQUE DIAZ TOMAS. Apo.Manc.: ENFEDAQUE DIAZ TOMAS. Datos registrales. T 1500 , F 41,S 8, H TO 25612, I/A 25 (19.12.11).
10 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: ORTIZ RIPOLL JORGE JUAN. Apo.Sol.: ORTIZ RIPOLL JORGE JUAN. Datos registrales. T 1500 , F41, S 8, H TO 25612, I/A 23 (27.10.11).
Revocaciones. Apo.Manc.: HERNANDO MATEO JUAN JOSE. Apo.Sol.: HERNANDO MATEO JUAN JOSE. Datos registrales. T1500 , F 41, S 8, H TO 25612, I/A 24 (27.10.11).
26 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: ABAD BRA脩AS JOSE. Apo.Sol.: ABAD BRA脩AS JOSE. Datos registrales. T 1500 , F 41, S 8, H TO25612, I/A 22 (16.05.11).
29 de Abril de 2011Revocaciones. Auditor: DESPATX I GABINET D' AUDITORIA SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T1500 , F 41, S 8, H TO 25612, I/A 21 (18.04.11).
20 de Agosto de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: CARDONA IGLESIAS JOSE. Apo.Manc.: CARDONA IGLESIAS JOSE. Datos registrales. T 1500 , F 40,S 8, H TO 25612, I/A 20 (12.08.10).
28 de Junio de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: BATALLA CLAVE ALBERT. Apo.Sol.: GELONCH SALO ANNA;BATALLA CLAVE ALBERT. Apo.Manc.:GELONCH SALO ANNA;SANTOLARIA SOLANO ANTONIO DOMINGO. Apo.Sol.: GARCIA ELIAS COS ROC. Apo.Manc.: GARCIAELIAS COS ROC;AGUERIA MARTINEZ REINIERO. Apo.Sol.: AGUERIA MARTINEZ REINIERO. Apo.Manc.: SANTOLARIA SOLANOANTONIO DOMINGO. Datos registrales. T 1500 , F 40, S 8, H TO 25612, I/A 19 (14.06.10).
18 de Enero de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: GALOPA VILARET JOSEP-MARIA;MARQUEZ GOMEZ JOAN MANEL. Datos registrales. T 1362 , F187, S 8, H TO 25612, I/A 18 ( 5.01.10).
21 de Agosto de 2009Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ GARCIA JOSE RAMON. Apo.Manc.: FERNANDEZ GARCIA JOSE RAMON. Datosregistrales. T 1362 , F 187, S 8, H TO 25612, I/A 17 (10.08.09).
03 de Agosto de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: GRANADOS PEREZ DE GRACIA ICIAR. Datos registrales. T 1362 , F 187, S 8, H TO 25612, I/A 16(23.07.09).