Actos BORME de Eurosontra Sl
08 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: REUS JIMENO PEDRO ANTONIO. Datos registrales. T 5612, L 2919, F 24, S 8, H V 50457, I/A 8(27.04.23).
26 de Abril de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: REUS JIMENO PEDRO ANTONIO. Presidente: REUS JIMENO PEDRO ANTONIO. Consejero:OROZCO TORTOLA MARIA CONSUELO. Secretario: OROZCO TORTOLA MARIA CONSUELO. Consejero: OROZCO TORTOLAMARIA ANGELES;OROZCO CRAVIOTO ALVARO. Nombramientos. Consejero: OROZCO TORTOLA MARIACONSUELO;OROZCO TORTOLA MARIA ANGELES;OROZCO TORTOLA ROSA;OROZCO CRAVIOTO ALVARO. Secretario:OROZCO TORTOLA MARIA ANGELES. Presidente: OROZCO TORTOLA MARIA CONSUELO. Datos registrales. T 5612, L 2919, F24, S 8, H V 50457, I/A 7 (19.04.23).
15 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: CRAVIOTO MARTINEZ MARIA PILAR. Nombramientos. Consejero: OROZCO CRAVIOTOALVARO. Modificaciones estatutarias. Modificado el art. 19º de los Estatutos, relativo a la retribución del órgano de administración..Cambio de objeto social. a) Agencia de transportes de mercancías por carretera. b) Arrendamiento de inmuebles para uso deltransporte de mercancías por carretera, excepto el arrendamiento financiero. c) Arrendador y/o arrendatario de vehículos para eltransporte de mercancías por carretera y de locales industriales, excepto. Datos registrales. T 5612, L 2919, F 23, S 8, H V 50457,I/A 6 ( 7.11.18).