Actos BORME de Eurotainment Sl
17 de Marzo de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: ALLES CAMPS PEDRO OSCAR;PEDROSA NEGRETE EDUARDO. Datos registrales. T 27058 , F 210, S8, H M 487616, I/A 14 ( 9.03.22).
07 de Febrero de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: ALLES CAMPS OSCAR;PERAL LEYVA ANA;CAÑIZARES SANTOS YOLANDA;NUÑEZ MESTREVICTORIAApoderado: COSTANZO ANTONELLA ROMINA. Datos registrales. T 27058 , F 129, S 8, H M 487616, I/A 13 (31.01.22).
18 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CAFFER AVANTHAY SOFIA. Datos registrales. T 27058 , F 126, S 8, H M 487616, I/A 12 (11.11.21).
28 de Octubre de 2021Cambio de domicilio social. C/ JUAN DE LA CIERVA 63 - POLIGONO INDUSTRIAL VALD (ARROYOMOLINOS). Datosregistrales. T 27058 , F 126, S 8, H M 487616, I/A 11 (21.10.21).
20 de Diciembre de 2018Cambio de domicilio social. PLAZA SANTA MARIA SOLEDAD TORRES ACOSTA 1 - 4ª PLA (MADRID). Datos registrales. T27058 , F 126, S 8, H M 487616, I/A 10 (13.12.18).
28 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: COSTANZO ANTONELLA ROMINA. Datos registrales. T 27058 , F 125, S 8, H M 487616, I/A 9(21.03.18).
16 de Noviembre de 2017Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ 136 Esc.1ª SEMISOTA A - EL VISO (MADRID). Datos registrales. T 27058 , F 125, S8, H M 487616, I/A 8 ( 7.11.17).
14 de Abril de 2016Declaración de unipersonalidad. Socio único: PERIALES LUCIANA. Datos registrales. T 27058 , F 125, S 8, H M 487616, I/A 7 (6.04.16).
20 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ESTEBAN PERIALES MARCELO;HUMBERTO PERIALES DANIEL. Nombramientos. Adm. Unico:PERIALES LUCIANA. Modificaciones estatutarias. 16. Administración y Representacion.-. Otros conceptos: Cambio del Organode Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Datos registrales. T 27058 , F 124, S 8, H M 487616, I/A 5(10.04.15).
Cambio de domicilio social. C/ JUAN DE LA CIERVA 63 - POLIGONO VALDEARENAL NOR (ARROYOMOLINOS). Datosregistrales. T 27058 , F 125, S 8, H M 487616, I/A 6 (10.04.15).
18 de Mayo de 2010Cambio de domicilio social. C/ CAMILO JOSE CELA, NUMERO 2, LOCAL NUMERO 18, CE (ROZAS DE MADRID (LAS)). Datosregistrales. T 27058 , F 124, S 8, H M 487616, I/A 4 ( 6.05.10).
19 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: ALLES CAMPS OSCAR;PERAL LEYVA ANA;CAÑIZARES SANTOS YOLANDA;NUÑEZ MESTREVICTORIA Datos registrales. T 27058 , F 124, S 8, H M 487616, I/A 3 ( 6.11.09).
22 de Octubre de 2009Cambio de domicilio social. CTRA NACIONAL V Km 23,5 LOCAL 12 - CENTRO COMERCIA (ARROYOMOLINOS). Datosregistrales. T 27058 , F 124, S 8, H M 487616, I/A 2 ( 9.10.09).
14 de Enero de 2009Revocaciones. APODERADO: PABLO IGNACIO MORAGREGA. Datos registrales. T 35100 , F 77, S 8, H B 260917, I/A 6(30.12.08).