Actos BORME de Eusebio Sanchez Sa
20 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ MOLINER JOSE LUIS;SANCHEZ MOLINER AMPARO;SANCHEZ LADWIG ALBERTO.Presidente: SANCHEZ MOLINER JOSE LUIS. Secretario: SANCHEZ MOLINER AMPARO. Nombramientos. Consejero: SANCHEZMOLINER AMPARO;SANCHEZ MOLINER JOSE LUIS;SANCHEZ LADWIG ALBERTO;SANCHEZ BURRIEL JAVIER. Presidente:SANCHEZ MOLINER JOSE LUIS. Secretario: SANCHEZ MOLINER AMPARO. Otros conceptos: Se determina en CUATRO elnumero de miembros del Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 4861, L 2170, F 190, S 8, H V 21229, I/A 25 (13.02.23).
30 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: BALLESTER PI脩ERO ESPERANZA. Datos registrales. T 4861, L 2170, F 189, S 8, H V 21229, I/A 24(22.12.20).
04 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: BALLESTER PI脩ERO ESPERANZA. Datos registrales. T 4861, L 2170, F 189, S 8, H V 21229, I/A 23(28.01.20).
27 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ MOLINER EUSEBIO;SANCHEZ MOLINER JOSE LUIS;SANCHEZ MOLINER MARIAAMPARO. Presidente: SANCHEZ MOLINER EUSEBIO. Secretario: SANCHEZ MOLINER JOSE LUIS. Con.Delegado: SANCHEZMOLINER EUSEBIO. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ MOLINER JOSE LUIS. Presidente: SANCHEZ MOLINER JOSE LUIS.Consejero: SANCHEZ MOLINER AMPARO. Secretario: SANCHEZ MOLINER AMPARO. Consejero: SANCHEZ LADWIG ALBERTO.Datos registrales. T 4861, L 2170, F 188, S 8, H V 21229, I/A 22 (20.01.20).
06 de Marzo de 2019Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 3.596,00 Euros. Desembolsado: 3.596,00 Euros. Resultante Suscrito: 544.000,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 544.000,00 Euros. Otros conceptos: Modificados los Estatutos a la ley de Sociedades de Capital, quedandoMODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS MISMOS.- Cambio de objeto social. La Sociedad tendr谩 por objeto: A la compraventa,importaci贸n y exportaci贸n de tejidos en general, toda clase de bordados y sus aplicaciones, as铆 como tambi茅n la confecci贸n en general.b) La promoci贸n, construcci贸n, venta, arrendamiento no financiero y explotaci贸n de toda clase de bienes inmuebles. Datosregistrales. T 4861, L 2170, F 186, S 8, H V 21229, I/A 21 (27.02.19).
19 de Octubre de 2017Revocaciones. Apoderado: PERALES FILLOL RAFAEL. Datos registrales. T 4861, L 2170, F 186, S 8, H V 21229, I/A 20(11.10.17).
21 de Diciembre de 2016Nombramientos. Con.Delegado: SANCHEZ MOLINER EUSEBIO. Datos registrales. T 4861, L 2170, F 186, S 8, H V 21229, I/A 19(14.12.16).
19 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ MOLINER EUSEBIO;SANCHEZ MOLINER JOSE LUIS;SANCHEZ MOLINER MARIAAMPARO. Con.Delegado: SANCHEZ MOLINER EUSEBIO. Presidente: SANCHEZ MOLINER EUSEBIO. Secretario: SANCHEZMOLINER JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ MOLINER EUSEBIO;SANCHEZ MOLINER JOSE LUIS;SANCHEZMOLINER MARIA AMPARO. Presidente: SANCHEZ MOLINER EUSEBIO. Secretario: SANCHEZ MOLINER JOSE LUIS. Datosregistrales. T 4861, L 2170, F 185, S 8, H V 21229, I/A 18 (11.10.16).
09 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: SANCHEZ MOLINER EUSEBIO. Consejero: SANCHEZ MOLINER EUSEBIO. Presidente:SANCHEZ MOLINER EUSEBIO. Consejero: SANCHEZ MOLINER AMPARO. Secretario: SANCHEZ MOLINER AMPARO. Consejero:SANCHEZ MOLINER JOSE LUIS. Nombramientos. Con.Delegado: SANCHEZ MOLINER EUSEBIO. Consejero: SANCHEZMOLINER EUSEBIO;SANCHEZ MOLINER JOSE LUIS;SANCHEZ MOLINER MARIA AMPARO. Presidente: SANCHEZ MOLINEREUSEBIO. Secretario: SANCHEZ MOLINER JOSE LUIS. Datos registrales. T 4861, L 2170, F 185, S 8, H V 21229, I/A 17 (28.11.11).
16 de Abril de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 300.000,00 Euros. Desembolsado: 300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 540.404,00 Euros.Resultante Desembolsado: 540.404,00 Euros. Datos registrales. T 4861, L 2170, F 185, S 8, H V 21229, I/A 16 ( 3.04.09).