Actos BORME de Everis Initiatives Sl
26 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: GALI ROGENT JOAQUIN. Datos registrales. T 35724 , F 220, S 8, H M 469838, I/A 45 (20.05.23).
27 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: CARBONELL CASTELLO JOSE PABLO. Datos registrales. T 35724 , F 220, S 8, H M 469838, I/A 44(17.03.23).
28 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Representan: CARBONELL CASTELLO JOSE PABLO. Nombramientos. Representan: GARAY ARANBURUJUAN. Datos registrales. T 35724 , F 220, S 8, H M 469838, I/A 43 (21.02.23).
13 de Abril de 2021Revocaciones. Apoderado: LABARTA HERRAEZ EVA. Datos registrales. T 35724 , F 219, S 8, H M 469838, I/A 41 ( 6.04.21).
Nombramientos. Apoderado: GARAY ARANBURU JUAN. Datos registrales. T 35724 , F 219, S 8, H M 469838, I/A 42 ( 6.04.21).
17 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Representan: LABARTA HERRAEZ EVA. Nombramientos. Representan: CARBONELL CASTELLO JOSEPABLO. Datos registrales. T 35724 , F 218, S 8, H M 469838, I/A 40 (10.03.21).
26 de Enero de 2021Nombramientos. Apoderado: CARBONELL CASTELLO JOSE PABLO;BIOSCA ARPA SERGI;GALI ROGENT JOAQUIN;GOMEZJARILLO ANTONIO;GARCIA MESA FLORA BEATRIZ;RODRIGUEZ CARRION CARMEN;CASTILLO GARCIA EMILIO;TURON GINEESTEVE. Datos registrales. T 35724 , F 217, S 8, H M 469838, I/A 39 (19.01.21).
27 de Octubre de 2020Ampliación de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 300.002,00 Euros. Datos registrales. T 35724 , F 216, S 8, H M469838, I/A 38 (20.10.20).
25 de Agosto de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: CERUELO SANABRIA CARLOS ENRIQUE. Apoderado: DEL BARRIO CRUZ OSCAR. Apo.Manc.:CERUELO SANABRIA CARLOS ENRIQUE;DEL BARRIO CRUZ OSCAR. Apoderado: CERUELO SANABRIA CARLOSENRIQUE;DEL BARRIO CRUZ OSCAR. Otros conceptos: Revocado el poder conferido a Don Carlos Enrique Ceruelo Sanabria envirtud de escritura autorizada el día 15 de junio de 2015 por el Notario de Madrid Don Enrique José Rodriguez Cativiela con el número1247 de su protocolo. Revocado el poder conferido a Don Carlos Enrique Ceruelo Sanabria en virtud de escritura autorizada el día 21de junio de 2016 por el Notario de Madrid Don Enrique José Rodriguez Cativiela con el número 2088 de su protocolo. Datosregistrales. T 35724 , F 216, S 8, H M 469838, I/A 37 (18.08.20).
06 de Agosto de 2020Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 35724 , F 216, S 8, H M 469838, I/A 36 (30.07.20).
06 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: TEJEDA MARTINEZ ESTANISLAO. Nombramientos. Representan: LABARTA HERRAEZ EVA.Datos registrales. T 35724 , F 213, S 8, H M 469838, I/A 33 (29.06.20).
Revocaciones. Apoderado: TEJEDA MARTINEZ ESTANISLAO. Datos registrales. T 35724 , F 214, S 8, H M 469838, I/A 34(29.06.20).
Nombramientos. Apoderado: LABARTA HERRAEZ EVA;GOMEZ JARILLO ANTONIO;CERUELO SANABRIA CARLOSENRIQUE;GARCIA MESA FLORA BEATRIZ;DEL BARRIO CRUZ OSCAR;RODRIGUEZ CARRION CARMEN;CASTILLO GARCIAEMILIO;TURON GINE ESTEVE. Datos registrales. T 35724 , F 214, S 8, H M 469838, I/A 35 (29.06.20).
25 de Septiembre de 2019Cambio de domicilio social. CMNO FUENTE DE LA MORA 1 (MADRID). Datos registrales. T 35724 , F 213, S 8, H M 469838, I/A32 (18.09.19).
10 de Abril de 2019Ampliacion del objeto social. La prestación de servicios de consultoría, asesoramiento y gestión empresarial, y especificamente larealización de estudios de mercado, sectores y planes de negocio, busqueda de socios y potenciales colaboradores para emprender olograr el establecimiento de negocios e inversiones, su elección... Datos registrales. T 35724 , F 212, S 8, H M 469838, I/A 31 (3.04.19).
15 de Marzo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ LUQUE FRANCISCO. Apo.Manc.: LOPEZ LUQUE FRANCISCO;LOPEZ LUQUE FRANCISCO.Apoderado: LOPEZ LUQUE FRANCISCO;LOPEZ LUQUE FRANCISCO. Datos registrales. T 33442 , F 184, S 8, H M 469838, I/A 29( 8.03.19).
Nombramientos. Apoderado: TEJEDA MARTINEZ ESTANISLAO;GOMEZ JARRILLO ANTONIO;CERUELO SANABRIA CARLOSENRIQUE;GARCIA MESA FLORA;DEL BARRIO CRUZ OSCAR;RODRIGUEZ CARRION CARMEN;TURON GINE ESTEVE. Datosregistrales. T 35724 , F 211, S 8, H M 469838, I/A 30 ( 8.03.19).
13 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ CARRION CARMEN;CASTILLO GARCIA EMILIO;TURON GINE ESTEVE. Apo.Manc.:GOMEZ JARILLO ANTONIO;CERUELO SANABRIA CARLOS ENRIQUE;LOPEZ LUQUE FRANCISCO;GARCIA MESA FLORA;DELBARRIO CRUZ OSCAR. Datos registrales. T 33442 , F 183, S 8, H M 469838, I/A 28 ( 6.03.19).
06 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: LOPEZ LUQUE FRANCISCO. Nombramientos. Representan: TEJEDA MARTINEZESTANISLAO. Datos registrales. T 33442 , F 182, S 8, H M 469838, I/A 27 (30.01.19).
04 de Febrero de 2019Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ BLANCO BENITO;CASTILLO GARCIA EMILIO;TURON GINE ESTEVE. Apo.Man.Soli:TRIGUERO ROBLES MARIO. Apoderado: VAZQUEZ BLANCO BENITO;CASTILLO GARCIA EMILIO;TURON GINEESTEVE;TRIGUERO ROBLES MARIO. Otros conceptos: revocados los poderes conferidos a don Mario Triguero Robles, donBenito Vázquez Blanco, don Emilio Castillo García, don Esteve Turón Giné y Don Juan Martínez Velarde, formalizados en escriturasque causaron las inscripciones 13ª,14ª,15ª,17ª y 20ª de la hoja social. Datos registrales. T 33442 , F 182, S 8, H M 469838, I/A 26(28.01.19).
18 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: GARCIA LOZANO MARTIN ALFONSO. Nombramientos. Representan: GARAY ARANBURUJUAN. Datos registrales. T 33442 , F 181, S 8, H M 469838, I/A 25 (11.01.19).
11 de Octubre de 2018Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ PEREZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 33442 , F 180, S 8, H M 469838, I/A 24 (4.10.18).
21 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: DE LOS RIOS ARRANZ ALBERTO. Datos registrales. T 33442 , F 180, S 8, H M 469838, I/A 23(14.06.18).
31 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: EVERIS SPAIN SL. Representan: MEDINA MENDEZ GREGORIO. Nombramientos. Representan:LOPEZ LUQUE FRANCISCO. Adm. Mancom.: EVERIS SPAIN SL;EVERIS PARTICIPACIONES SOCIEDAD LIMITADA. Representan:GARCIA LOZANO MARTIN ALFONSO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único aAdministradores mancomunados. Datos registrales. T 33442 , F 178, S 8, H M 469838, I/A 22 (23.05.18).
17 de Febrero de 2017Ampliación de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 300.001,00 Euros. Datos registrales. T 33442 , F 178, S 8, H M469838, I/A 21 ( 8.02.17).
15 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: DEL BARRIO CRUZ OSCAR. Datos registrales. T 33442 , F 177, S 8, H M 469838, I/A 20 ( 7.09.16).
11 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apoderado: GARRIDO ARRIBAS CARLOS ALBERTO;GARRIDO ARRIBAS CARLOS ALBERTO. Nombramientos.Apoderado: GARRIDO ARRIBAS CARLOS ALBERTO. Datos registrales. T 33442 , F 177, S 8, H M 469838, I/A 19 ( 2.11.15).
30 de Julio de 2015Revocaciones. Apoderado: GARRIDO ARRIBAS CARLOS ALBERTO. Otros conceptos: REVOCADOS LOS PODERESCONFERIDOS A FAVOR DE DON CARLOS-ALBERTO GARRIDO ARRIBAS QUE CAUSARON LAS INSCRIPCIONES 13&, 14& Y15& DE LA HOJA SOCIAL. Datos registrales. T 33442 , F 176, S 8, H M 469838, I/A 18 (22.07.15).
08 de Julio de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA MESA FLORA BEATRIZ. Datos registrales. T 33442 , F 175, S 8, H M 469838, I/A 17(30.06.15).
30 de Junio de 2015Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ VELARDE JUAN;MEDINA MENDEZ GREGORIO;VAZQUEZ BLANCO BENITO;CASTILLOGARCIA EMILIO;TURON GINE ESTEVE;GARRIDO ARRIBAS CARLOS ALBERTO;GOMEZ JARILLO ANTONIO;TRIGUEROROBLES MARIO;CERUELO SANABRIA CARLOS ENRIQUE;LOPEZ LUQUE FRANCISCO. Datos registrales. T 33442 , F 173, S 8,H M 469838, I/A 16 (22.06.15).
03 de Junio de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ LUQUE FRANCISCO. Apo.Manc.: LOPEZ LUQUE FRANCISCO. Datos registrales. T 28741 , F209, S 8, H M 469838, I/A 15 (26.05.15).
16 de Junio de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: CERUELO SANABRIA CARLOS ENRIQUE. Datos registrales. T 28741 , F 208, S 8, H M 469838,I/A 14 ( 9.06.14).
31 de Mayo de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: TRIGUERO ROBLES MARIO;GOMEZ JARILLO ANTONIO. Datos registrales. T 28741 , F 205, S 8,H M 469838, I/A 13 (24.05.13).
23 de Octubre de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: MENDEZ OLMOS BEATRIZ. Datos registrales. T 28741 , F 205, S 8, H M 469838, I/A 12 (11.10.12).
16 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: JAMBRINA LLORENTE MARIA TERESA;GOMEZ JARRILLO ANTONIO. Datos registrales. T 26066 , F111, S 8, H M 469838, I/A 10 ( 2.11.11).
Revocaciones. Apoderado: ARECHABALETA GIL GORKA. Datos registrales. T 28741 , F 205, S 8, H M 469838, I/A 11 ( 2.11.11).
14 de Junio de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: MARCOS MUÑOZ EMILIA;IZQUIERDO VICENTE CARMEN. Datos registrales. T 26066 , F 111, S 8, HM 469838, I/A 9 ( 2.06.11).
15 de Diciembre de 2009Ampliación de capital. Capital: 200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 300.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículode los estatutos: 6. Capital.-. Datos registrales. T 26066 , F 110, S 8, H M 469838, I/A 8 ( 2.12.09).
01 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: MENDEZ OLMOS BEATRIZ. Datos registrales. T 26066 , F 109, S 8, H M 469838, I/A 7 (19.11.09).
26 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Representan: GARAY ARAMBURU JUAN-ANTONIO. Nombramientos. Representan: MEDINA MENDEZGREGORIO. Datos registrales. T 26066 , F 109, S 8, H M 469838, I/A 6 ( 6.08.09).