Buscador CIF Logo

Actos BORME Excavaciones Castilla Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Excavaciones Castilla Sl

Actos BORME Excavaciones Castilla Sl - B09013731

Tenemos registrados 35 Actos BORME del Registro Mercantil de Burgos para Excavaciones Castilla Sl con CIF B09013731

馃敊 Perfil de Excavaciones Castilla Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Burgos

Actos BORME de Excavaciones Castilla Sl

24 de Agosto de 2023
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 782, L 573, F 58, S 8, H BU 3540,I/A 88 (18.08.23).

09 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apo.Manc.: FRANCES FERNANDEZ-CASTA脩EDA JAVIER;BALLESTER MARIN MARIA;VIAJEL ELVIRABEGO脩A. Datos registrales. T 782, L 573, F 58, S 8, H BU 3540, I/A 87 ( 3.02.23).

14 de Septiembre de 2022
Reelecciones. Consejero: CONTRERAS CABALLERO IGNACIO;PLANTALAMOR CONTRERAS VICTORIA. Presidente:CONTRERAS CABALLERO IGNACIO. Vicepresid.: PLANTALAMOR CONTRERAS VICTORIA. Cons.Del.Sol: PLANTALAMORCONTRERAS VICTORIA. Consejero: PLANTALAMOR ENRIQUEZ MONICA. Secretario: RAMIREZ FERNANDEZ JORGE MARTIN.Datos registrales. T 782, L 573, F 57, S 8, H BU 3540, I/A 84 ( 8.09.22).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ FERNANDEZ MARIA LUISA. Apo.Manc.: MARTIN CASTILLO ESTEBAN. Nombramientos.Apo.Sol.: JOSE CANO ANTONIO. Datos registrales. T 782, L 573, F 57, S 8, H BU 3540, I/A 85 ( 8.09.22).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 782, L 573, F 57, S 8, H BU 3540,I/A 86 ( 8.09.22).

24 de Septiembre de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 782, L 573, F 56, S 8, H BU 3540,I/A 83 (17.09.21).

13 de Mayo de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CONTRERAS CABALLERO IGNACIO;PLANTALAMOR CONTRERAS VICTORIA;DELICADOESCUDERO FERNANDO;CASTIELLA GONZALEZ JUAN;GOMEZ ANDRES LUIS;SALAS GONZALEZ ARANTXA;MENENDEZ DE LARIERA GABRIEL;AGUIRRE QUINTERO MARTA;TORRENOVA JARA ROSA;RODRIGUEZ RODRIGUEZ INGRID;VIME FERNANDEZ-SITO LUCIA;MARTINEZ MARTINEZ MARIA CRUZ;VIAJEL ELVIRA BEGO脩A;CABELLO TOVAR EUGENIO;MARTIN CASTILLO

27 de Agosto de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: PLANTALAMOR ENRIQUEZ ALVARO. Datos registrales. T 772, L 563, F 69, S 8, H BU 3540, I/A 81(21.08.20).

06 de Agosto de 2020
Nombramientos. Consejero: PLANTALAMOR ENRIQUEZ MONICA. Datos registrales. T 772, L 563, F 69, S 8, H BU 3540, I/A 80(31.07.20).

28 de Mayo de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOSE CANO ANTONIO. Apo.Manc.: CONTRERAS CABALLERO IGNACIO;PLANTALAMORCONTRERAS VICTORIA;DELICADO ESCUDERO FERNANDO;SALAS GONZALEZ ARANTXA;GOMEZ ANDRES LUIS;BELTRANLEZAUN FERNANDO. Datos registrales. T 703, L 494, F 125, S 8, H BU 3540, I/A 79 (21.05.20).

05 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ FERNANDEZ MARIA LUISA. Datos registrales. T 703, L 494, F 124, S 8, H BU 3540, I/A 78(27.02.19).

12 de Diciembre de 2018
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 703, L 494, F 124, S 8, H BU 3540, I/A 77 ( 5.12.18).

14 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BELTRAN APARICIO FERNANDO;MARIN MARTIN MANUEL. Datos registrales. T 703, L 494, F124, S 8, H BU 3540, I/A 76 ( 7.11.18).

26 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PLANTALAMOR CONTRERAS VICTORIA. Nombramientos. Cons.Del.Sol: PLANTALAMORCONTRERAS VICTORIA. Datos registrales. T 703, L 494, F 124, S 8, H BU 3540, I/A 75 (20.09.17).

12 de Septiembre de 2017
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Consejero: CONTRERAS CABALLERO IGNACIO;PLANTALAMOR ENRIQUEZALVARO;PLANTALAMOR CONTRERAS VICTORIA. Datos registrales. T 703, L 494, F 122, S 8, H BU 3540, I/A 72 ( 6.09.17).

Nombramientos. Vicepresid.: PLANTALAMOR CONTRERAS VICTORIA. Reelecciones. Presidente: CONTRERAS CABALLEROIGNACIO. Datos registrales. T 703, L 494, F 122, S 8, H BU 3540, I/A 73 ( 6.09.17).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SALAS GONZALEZ ARANTXA;BELTRAN LEZAUN FERNANDO. Datos registrales. T 703, L 494, F122, S 8, H BU 3540, I/A 74 ( 6.09.17).

25 de Abril de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE VICENTE RABANAL SUSANA. Datos registrales. T 703, L 494, F 121, S 8, H BU 3540, I/A 71(19.04.17).

15 de Febrero de 2017
Nombramientos. Con.Delegado: PLANTALAMOR CONTRERAS VICTORIA. Datos registrales. T 703, L 494, F 121, S 8, H BU3540, I/A 70 ( 9.02.17).

05 de Diciembre de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARMENTEROS MENENDEZ EDUARDO. Datos registrales. T 703, L 494, F 121, S 8, H BU 3540, I/A69 (24.11.16).

30 de Agosto de 2016
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 703, L 494, F 121, S 8, H BU 3540, I/A 68 (24.08.16).

03 de Mayo de 2016
Modificaci贸n de poderes. Apo.Man.Soli: MENENDEZ DE LA RIERA GABRIEL. Datos registrales. T 703, L 494, F 124, S 8, H BU3540, I/A 67 (26.04.16).

24 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apo.Sol.: ARMENTEROS MENENDEZ EDUARDO. Apo.Man.Soli: DELICADO ESCUDERO FERNANDO. Apoderado:SALAS GONZALEZ MARIA ARANZAZU. Apo.Sol.: PLANTALAMOR CONTRERAS VICTORIA. Apo.Man.Soli: GOMEZ ADRES LUIS.Nombramientos. Apo.Man.Soli: CONTRERAS CABALLERO IGNACIO;PLANTALAMOR CONTRERAS VICTORIA;ARMENTEROSMENENDEZ EDUARDO;DELICADO ESCUDERO FERNANDO;CASTIELLA GONZALEZ JUAN;GOMEZ ANDRES LUIS;BELTRANAPARICIO FERNANDO;SALAS GONZALEZ ARANTXA;MENENDEZ DE LA RIERA GABRIEL;AGUIRRE QUINTERO MARTA;MARIN

20 de Octubre de 2015
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 560, L 351, F 17, S 8, H BU 3540, I/A 65 (14.10.15).

05 de Noviembre de 2014
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 560, L 351, F 17, S 8, H BU 3540, I/A 64 (30.10.14).

08 de Abril de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: PLANTALAMOR CONTRERAS VICTORIA. Apo.Man.Soli: GOMEZ ADRES LUIS. Datos registrales. T560, L 351, F 15, S 8, H BU 3540, I/A 63 ( 1.04.14).

16 de Agosto de 2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 560, L 351, F 15, S 8, H BU 3540, I/A 62 ( 8.08.13).

27 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RIVAS PINO ANGEL IGNACIO. Nombramientos. Secretario: RAMIREZ FERNANDEZ JORGEMARTIN. Datos registrales. T 560, L 351, F 14, S 8, H BU 3540, I/A 60 (17.08.12).

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: TERRIENTE QUESADA JOSE CARLOS. Nombramientos. Consejero:PLANTALAMOR CONTRERAS VICTORIA. Reelecciones. Consejero: CONTRERAS CABALLERO IGNACIO. Presidente:CONTRERAS CABALLERO IGNACIO. Consejero: PLANTALAMOR ENRIQUEZ ALVARO. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datosregistrales. T 560, L 351, F 15, S 8, H BU 3540, I/A 61 (17.08.12).

12 de Julio de 2012
Revocaciones. Dir. General: MERAYO MIGUELEZ MANUEL. Datos registrales. T 560, L 351, F 15, S 8, H BU 3540, I/A 59 (3.07.12).

07 de Octubre de 2011
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 560, L 351, F 14, S 8, H BU 3540, I/A 58 (29.09.11).

20 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Secretario: CEBRIAN ECHARRI CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj: RIVAS PINO ANGEL IGNACIO.Datos registrales. T 560, L 351, F 14, S 8, H BU 3540, I/A 57 (12.07.11).

15 de Octubre de 2010
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 560, L 351, F 14, S 8, H BU 3540, I/A 56 ( 5.10.10).

19 de Agosto de 2010
Reelecciones. Consejero: CONTRERAS CABALLERO IGNACIO. Presidente: CONTRERAS CABALLERO IGNACIO. Datosregistrales. T 560, L 351, F 14, S 8, H BU 3540, I/A 55 (10.08.10).

13 de Agosto de 2009
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 560, L 351, F 13, S 8, H BU 3540, I/A 54 ( 4.08.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n