Buscador CIF Logo

Actos BORME Expal Aeronautics Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Expal Aeronautics Sociedad Anonima

Actos BORME Expal Aeronautics Sociedad Anonima - A83134437

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Albacete para Expal Aeronautics Sociedad Anonima con CIF A83134437

馃敊 Perfil de Expal Aeronautics Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Albacete

Actos BORME de Expal Aeronautics Sociedad Anonima

22 de Marzo de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: EXPAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA. Representan: BARBEITO DIEZ JAIME;FERNANDEZBOSCH JOSE MANUEL. Revocaciones. Apoderado: SALLENT ACEBO PEDRO;GASTA脩ADUY TILVE CARLOS;CANO LEJOAMPARO;CAMINO DE MIGUEL MIGUEL;ORTIZ PERRIN CAROLINA;GARCIA VALLE MARIA REMEDIOS;CARPINTERO JIMENEZPEDRO.Apo.Sol.: CARDAMA GOMEZ FERNANDA;AQUERRETA BAROJA FRANCISCO JAVIER. Apo.Man.Soli: DE TERESAPERTUSA MARTA. Apo.Sol.: GALAN PEINADO JUAN;GONZALEZ BENITEZ LUIS. Apo.Man.Soli: NAVARRETE VENEGAS MARIAINES. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1020, L 784, F 28, S 8, H AB 18226, I/A 30 (12.03.21).

11 de Agosto de 2020
Nombramientos. Representan: FERNANDEZ BOSCH JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1020, L 784, F 27, S 8, H AB 18226, I/A29 ( 4.08.20).

03 de Agosto de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARICHALAR VIGIER FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: NAVARRETEVENEGAS MARIA INES. Datos registrales. T 1015, L 779, F 103, S 8, H AB 18226, I/A 28 (27.07.20).

07 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PICOSSI GO脩I MARIA IDOYA. Apo.Sol.: PICOSSI GO脩I MARIA IDOYA. Apoderado: GUEHRINGDANIELLE MARIE. Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ BENITEZ LUIS. Datos registrales. T 1015, L 779, F 103, S 8, H AB18226, I/A 27 ( 3.02.20).

04 de Febrero de 2020
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1011, L 775, F 46, S 8, H AB 18226, I/A 26(27.01.20).

15 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARICHALAR VIGIER FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 989, L 753, F 86, S 8, H AB18226, I/A 25 ( 7.10.19).

03 de Diciembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ MARTIN MARIA JESUS. Datos registrales. T 989, L 753, F 86, S 8, H AB 18226, I/A 24(26.11.18).

29 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: MORCUENDE ROJO ANA ISABEL. Nombramientos. Apoderado: GUEHRING DANIELLE MARIE. Datosregistrales. T 975, L 739, F 38, S 8, H AB 18226, I/A 23 (21.12.17).

07 de Abril de 2017
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 975, L 739, F 38, S 8, H AB 18226, I/A22 (31.03.17).

05 de Abril de 2017
Reelecciones. Adm. Unico: EXPAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 975, L 739, F 38, S 8, H AB 18226, I/A21 (29.03.17).

13 de Septiembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ ALFARO EVANGELINA;MARTINEZ ALFARO EVANGELINA. Nombramientos. Apo.Sol.:GALAN PEINADO JUAN. Datos registrales. T 969, L 733, F 97, S 8, H AB 18226, I/A 20 ( 6.09.16).

06 de Mayo de 2016
Revocaciones. Apoderado: MORENO HUART JOSE VICENTE;DE CUBAS GARRIDO RAFAEL;MORENO HUART JOSEVICENTE;LOPEZ SORS GONZALEZ RAFAEL;CUERDO VEGA ANA ISABEL;DEL OLMO PASTOR JESUS ANTONIO;PEIRONCELYSARACHO IGNACIO. Apo.Sol.: SANTOS MARTIN ERNESTO;VIGIL MARTINEZ FEDERICO. Apoderado: MATEU HOYOSBLANCA;MORENO GONZALEZ FERNANDO. Datos registrales. T 969, L 733, F 97, S 8, H AB 18226, I/A 19 (28.04.16).

15 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE TERESA PERTUSA MARTA. Datos registrales. T 947, L 711, F 156, S 8, H AB 18226, I/A 18 (8.03.16).

28 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: AQUERRETA BAROJA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 947, L 711, F 156, S 8, H AB 18226,I/A 17 (21.10.15).

20 de Enero de 2015
Cambio de objeto social. 2) La investigaci贸n, desarrollo y comercializaci贸n de tecnolog铆a know-how y propiedad industrial relativos alos anteriores productos. 3) La investigaci贸n, desarrollo y comercializaci贸n de procesos industriales y plantas y dem谩s instalacionespara la fabricaci贸n de los productos antes mencionados. 4. Datos registrales. T 947, L 711, F 156, S 8, H AB 18226, I/A 15(13.01.15).

25 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: MORCUENDE ROJO ANA ISABEL. Datos registrales. T 943, L 707, F 165, S 8, H AB 18226, I/A 14(18.09.14).

23 de Junio de 2014
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 943, L 707, F165, S 8, H AB 18226, I/A 13 (13.06.14).

09 de Mayo de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: CARDAMA GOMEZ FERNANDA. Datos registrales. T 914, L 678, F 128, S 8, H AB 18226, I/A 12 (2.05.14).

15 de Febrero de 2012
Revocaciones. Apoderado: MORENO GONZALEZ FERNANDO. Nombramientos. Apoderado: MATEU HOYOS BLANCA. Datosregistrales. T 909, L 673, F 8, S 8, H AB 18226, I/A 11 ( 6.02.12).

21 de Octubre de 2011
Reelecciones. Adm. Unico: EXPAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 909, L 673, F 8, S 8, H AB 18226, I/A 10(11.10.11).

01 de Agosto de 2011
Cambio de domicilio social. CTRA DE LAS PE脩AS Km 5,3 - CALLE A, S/N, PARQUE AE (ALBACETE). Datos registrales. T 886,L 650, F 106, S 8, H AB 18226, I/A 9 (20.07.11).

29 de Junio de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: VIGIL MARTINEZ FEDERICO;PICOSSI GO脩I MARIA IDOYA. Datos registrales. T 886, L 650, F 106, S8, H AB 18226, I/A 8 (17.06.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n